

Moses Rountree

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Moses Rountree [1] b. 1550 d. 1621
Melvina York b. 1556 d. 1624
- 2 William Rowntree [1.1]
b. 1573 d. 1627
Rachel Simpson b. 1574 d. 1636
- 3 Joseph Rountree [1.1.1]
b. 1598 d. 1660
Rebecca Toms b. 1601 d. 1656
- 4 John Rountree [1.1.1.1]
b. 1622 d. 1680
Jane Hardy b. 1625 d. 1684
- 5 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.1]
b. 1646
- 5 William Rountree [1.1.1.1.2]
b. 1647 d. 1680
- 5 Francis Rountree, I [1.1.1.1.3]
b. 1649 d. 31 Aug 1723
Sarah Coleman b. 1655 d. 1723
- 6 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.1]
- 6 Susanna Rountree [1.1.1.1.3.2]
b. 1670 d. 30 Sep 1730
- 6 Christian Rountree [1.1.1.1.3.3]
b. 1670
- 6 Rebecca Rountree [1.1.1.1.3.4]
b. 1670
- 6 Robert Rountree [1.1.1.1.3.5]
b. 1672 d. 18 Dec 1746
- 6 John Rountree [1.1.1.1.3.6]
b. 1674 d. 1744
- 6 Francis Rountree, II [1.1.1.1.3.7]
b. 1676 d. 1746
Susan Ames b. 1683 d. 1749
- 7 Mary Rebecca Rountree [1.1.1.1.3.7.1]
b. 1700 d. 1759
Jonathan Jotham Lassiter b. 1678 d. 1769
- 8 Tobias Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1]
b. Bef 1740 d. 1803
Sarah S Northern b. Feb 1759 d. 18 Oct 1817
- 9 Rhoda Rebecca Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.1]
b. 1775 d. 1869
Drury Mitchell b. 1765 d. 10 Jul 1857
- 10 Ricey Maderias John Mitchell [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1]
b. 24 Jan 1804 d. 1 Sep 1890
Rhoda Ann Howell b. 1819 d. 1909
- 11 Litorah Taylor Mitchell [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1.1]
b. 24 Jun 1847 d. 17 May 1917
Thomas Jefferson Grantham b. 17 Jan 1842 d. 11 Jun 1903
- 12 Richard Jefferson Grantham [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1.1.1]
b. 6 Oct 1880 d. 24 Jun 1955 [ =>]
- 12 Joseph H Grantham [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1.1.2]
b. Mar 1885
- 12 Grover Cleveland Grantham [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1.1.3]
b. 8 Mar 1885 d. 23 Jul 1967
- 12 Richard Jefferson Grantham [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1.1.1]
- 11 Litorah Taylor Mitchell [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1.1]
- 10 Rebecca Brooks [1.1.1.1.3.7.1.1.1.2]
b. 8 Jan 1808 d. 6 Jun 1857
- 10 Ricey Maderias John Mitchell [1.1.1.1.3.7.1.1.1.1]
- 9 Benjamin C C Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.2]
b. 1778 d. 1869
Elizabeth E Hill b. 1785 d. 1852
- 10 Martha Ann Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.2.1]
b. 1828 d. 1917
Maltire Anthony Thrash b. 1817 d. 1898
- 11 Enoch Callaway Thrash [1.1.1.1.3.7.1.1.2.1.1]
b. 25 Apr 1864 d. 5 Jan 1938
Arie Lillie Estes b. 6 Aug 1877 d. 10 Mar 1963
- 12 Calvin Lassetter Thrash, I [1.1.1.1.3.7.1.1.2.1.1.1]
b. 29 Oct 1898 d. 7 Jul 1970 [ =>]
- 12 Calvin Lassetter Thrash, I [1.1.1.1.3.7.1.1.2.1.1.1]
- 11 Enoch Callaway Thrash [1.1.1.1.3.7.1.1.2.1.1]
- 10 Martha Ann Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.2.1]
- 9 Joseph Jesse Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3]
b. 6 Dec 1781 d. 21 Sep 1848
Sophie Penelope McClendon b. 1 Jun 1790 d. 9 Apr 1883
- 10 Thomas J Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1]
Margaret Hambrick
- 11 Nancy Ann Matilda Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1]
b. 1844 d. 1914
Nathan Granberry Pilcher b. 3 Apr 1849 d. 16 May 1891
- 12 Willie J Pilcher [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1.1]
[ =>]
- 12 Mary Pilchier [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1.2]
b. 1870
- 12 John W. Pilchier [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1.3]
b. 1872
- 12 Emma Frances Castleberry Pilcher [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1.4]
b. 1874 [ =>]
- 12 Josephene Pilchier [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1.5]
b. 1877
- 12 Willie J Pilcher [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1.1]
- 11 Nancy Ann Matilda Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1.1]
- 10 William Elisha Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.2]
b. 15 Sep 1808 d. 23 Apr 1840
Sarah Powell b. 27 Mar 1810 d. 6 Jul 1860
- 11 Jesse R Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.2.1]
b. 1830 d. 19 Sep 1863
Sarah Jane Walls b. Mar 1832 d. 10 Jan 1905
- 12 John William Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.2.1.1]
b. Jan 1860 d. May 1936 [ =>]
- 12 John William Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.2.1.1]
- 11 Jesse R Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.2.1]
- 10 Thomas J Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.3.1]
- 9 Matthew Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.4]
b. 1789 d. 1880
Henrietta b. Abt 1795 d. Abt 1855
- 10 Lucinda Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.4.1]
b. 15 Oct 1813 d. 25 Jan 1891
James Smith b. Abt 1810 d. Abt 1833
- 11 Henrietta Ann Smith [1.1.1.1.3.7.1.1.4.1.1]
b. 6 Nov 1831 d. 17 Nov 1914
Jackson T Jones b. 8 Jun 1822 d. 1910
- 12 Charles Lawrence Jones [1.1.1.1.3.7.1.1.4.1.1.1]
b. 1 Apr 1872 d. 25 Mar 1964 [ =>]
- 12 Charles Lawrence Jones [1.1.1.1.3.7.1.1.4.1.1.1]
- 11 Henrietta Ann Smith [1.1.1.1.3.7.1.1.4.1.1]
- + James Thomas Brown
- 10 Lucinda Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.4.1]
- 9 Rhoda Rebecca Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1.1]
- 8 Jonas Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2]
b. 1740 d. 1814
Winifred Parker b. 1742 d. 1815
- 9 Chloe Edna Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.1]
b. 1759 d. 1824
John Parker b. 1755 d. 1806
- 10 Willie Parker [1.1.1.1.3.7.1.2.1.1]
b. 1794 d. 1836
Mason Robertson b. 1794
- 11 Willie Alec Parker [1.1.1.1.3.7.1.2.1.1.1]
b. 1819 d. 1884
Polly Marie Horton b. 1821 d. 1892
- 12 Sarah I Parker [1.1.1.1.3.7.1.2.1.1.1.1]
b. 1865 d. 1952 [ =>]
- 12 Sarah I Parker [1.1.1.1.3.7.1.2.1.1.1.1]
- 11 Willie Alec Parker [1.1.1.1.3.7.1.2.1.1.1]
- 10 Willie Parker [1.1.1.1.3.7.1.2.1.1]
- 9 Isaac Amos Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2]
b. 1765 d. 1834
Faithy Parker b. 1770 d. 1834
- 10 Jacob Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2.1]
b. 1785 d. 1850
Lucy
- 11 Luke Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2.1.1]
b. 1803
Nancy Cane b. 1804
- 12 J M Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2.1.1.1]
b. 1835 [ =>]
- 12 J M Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2.1.1.1]
- 11 Luke Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2.1.1]
- 10 Jacob Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.2.1]
- 9 Abraham Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3]
b. 1770 d. 1842
Susannah Williams b. 1771 d. 1850
- 10 David Franklin Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1]
b. 1809 d. 1846
Elizabeth Asbury Speer b. 1812 d. 1861
- 11 James Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.1]
b. 1833
- 11 Fletcher Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.2]
b. 1835
- 11 Jeremiah Carter Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.3]
b. 21 Mar 1837 d. 1877
- + Naomi F Cox, (Xfer) b. 1833
- + Naomi F Cox, (Xfer) b. 1833
- 11 Henry Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.4]
b. 1839
- 11 Jane Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.5]
b. 1841
- 11 Mary Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.6]
b. 1843
- 11 Amanda Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.7]
b. 1845
- 11 Sarah Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.8]
b. 1846
- 11 James Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1.1]
- 10 David Franklin Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.3.1]
- 9 Chloe Edna Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.2.1]
- 8 Tobias Lassiter [1.1.1.1.3.7.1.1]
- 7 Francis Rountree, III [1.1.1.1.3.7.2]
b. 1700 d. 27 Jun 1734
Anne Elizabeth Sumner
- 8 Jethro Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1]
d. 1782
- 9 John Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1]
b. 1742 d. 1799
Christian Freeman b. 1751 d. 1799
- 10 Dudley Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1.1]
b. 1789 d. Jul 1856
Mary b. Abt 1798
- 11 Andrew G Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1.1.1]
b. Abt 1830
- 11 Georgian P Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1.1.2]
b. Abt 1835
- 11 Andrew G Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1.1.1]
- 10 Dudley Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1.1]
- 9 John Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1.1]
- 8 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.7.2.2]
b. 1691 d. Oct 1750
Thomas Wallace b. 1690 d. 1750
- 9 William D Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1]
b. 1730 d. 19 Sep 1774
Martha Andrews b. 16 Mar 1730 d. 13 Feb 1775
- 10 Agnes Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.1]
b. 27 May 1747 d. 1795
Edmund Andrews b. 1725 d. 1795
- 11 Arden Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.1.1.1]
b. 6 Mar 1777 d. 3 May 1847
Drupina Gainer b. 28 Feb 1767 d. 1853
- 12 Wallace Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.1.1.1.1]
b. 20 Feb 1801 d. 22 Jul 1865 [ =>]
- 12 Wallace Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.1.1.1.1]
- 11 Arden Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.1.1.1]
- 10 William D Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2]
b. 6 May 1754 d. 5 Feb 1825
Susanna Exum b. 1755 d. 6 Nov 1826
- 11 John Thomas Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.1]
b. 1782 d. 1845
Delilah Taylor b. 1786 d. 1853
- 12 Reuben Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.1.1]
b. 8 May 1813 d. 1880 [ =>]
- 12 Reuben Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.1.1]
- 11 Reuben Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.2]
b. 1790 d. 23 Feb 1875
Martha Page b. 12 Feb 1792 d. 28 Dec 1856
- 12 Lydia Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.2.1]
b. 1820 d. 1880 [ =>]
- 12 Lydia Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.2.1]
- 11 John Thomas Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.2.1]
- 10 Agnes Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1.1]
- 9 John Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2]
b. Abt 1734 d. 6 Nov 1771
Elizabeth
- 10 Miles Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1]
b. 1768 d. 21 Oct 1849
Mary Polly Freeman b. 1765 d. 10 Aug 1849
- 11 Peter Docturn Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1]
b. 15 May 1799 d. 8 Mar 1874
Nancy King b. 10 Apr 1800 d. 15 Apr 1888
- 12 William Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.1]
b. 12 Jan 1820 d. 14 Oct 1892
- 12 Susan C Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.2]
b. 11 Aug 1820 d. 4 Oct 1906
- 12 Julia Ann Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.3]
b. 1 Feb 1821 d. 11 May 1892 [ =>]
- 12 Jacob Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.4]
b. 10 Jan 1823 d. 18 Jun 1886
- 12 Sarah Hodgin [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.5]
b. 1827 d. 12 Feb 1905
- 12 Nancy Mackey [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.6]
b. 3 Feb 1831 d. 3 Jun 1896
- 12 Robert Russell Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.7]
b. 3 Mar 1833 d. 23 Jan 1897
- 12 George W Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.8]
b. 1838
- 12 William Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.1]
- 11 Peter Docturn Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1.1]
- 10 Miles Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.2.1]
- 9 Susannah Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.3]
b. 1738 d. 1816
Joseph Gainer b. Abt 1725 d. 1793
- 10 Drupina Gainer [1.1.1.1.3.7.2.2.3.1]
b. 28 Feb 1767 d. 1853
Arden Andrews b. 6 Mar 1777 d. 3 May 1847
- 11 Wallace Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.3.1.1]
b. 20 Feb 1801 d. 22 Jul 1865
Nancy Chance b. 10 Feb 1812 d. 17 Jun 1877
- 12 Duprina F Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.3.1.1.1]
b. 17 Dec 1834 d. 18 Oct 1896 [ =>]
- 12 Duprina F Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.3.1.1.1]
- 11 Wallace Andrews [1.1.1.1.3.7.2.2.3.1.1]
- 10 Drupina Gainer [1.1.1.1.3.7.2.2.3.1]
- 9 William D Wallace [1.1.1.1.3.7.2.2.1]
- 8 Francis Rountree, IV [1.1.1.1.3.7.2.3]
b. 1718 d. 13 Jul 1748
Mary Coleman b. 1704 d. Aft 1748
- 9 Reuben Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1]
b. 1733 d. 1815
Mary
- 10 Job Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1]
b. 1758 d. 1828
Mary Little b. 1770
- 11 Isaac Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.1]
b. 1792 d. 9 Jun 1860
Elizabeth
- 12 Edward Washington Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.1.1]
b. 20 Sep 1825 d. Aft 1880 [ =>]
- 12 Edward Washington Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.1.1]
- 11 Job Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2]
b. 1796 d. 1856
Mary Killingsworth b. 1799 d. 11 Nov 1870
- 12 William Henry Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.1]
b. 1826 d. 1891
- 12 Adeline Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.2]
b. 1827
- 12 Martha Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.3]
b. 1830
- 12 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.4]
b. 1832
- 12 Francis Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.5]
b. 1834
- 12 Sally Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.6]
b. 1834
- 12 Susan Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.7]
b. 1836
- 12 Richard Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.8]
b. 1838
- 12 James Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.9]
b. 1840
- 12 William Henry Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.2.1]
- 11 Sarah Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.3]
b. 1805
John Bunyan Cave b. 1799
- 12 John Washington Cave [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.3.1]
b. 1835
- 12 John Washington Cave [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.3.1]
- 11 Isaac Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1.1]
- 10 Job Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1.1]
- 9 Cader Rountree, Sr [1.1.1.1.3.7.2.3.2]
b. 1740 d. Aug 1821
Elizabeth Barfort b. 1747 d. Aft 1817
- 10 Cader Rountree, Jr [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1]
b. 1767 d. 27 Aug 1821
Penelope Renfro b. 1770 d. 1830
- 11 Sarah S Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.1]
b. 17 Oct 1794 d. 1847
Captain John Williams b. 1798 d. 5 Oct 1862
- 12 Isaac Newton Williams [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.1.1]
b. 4 Jun 1833 d. 18 Jun 1888 [ =>]
- 12 Isaac Newton Williams [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.1.1]
- 11 Francis R Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.2]
b. 1800 d. 1863
Nancy Strother b. 9 Nov 1800 d. 20 Jan 1886
- 12 Thomas Jefferson Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.2.1]
b. 24 May 1830 d. 15 Dec 1877 [ =>]
- 12 Thomas Jefferson Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.2.1]
- 11 Jesse Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3]
b. 8 Nov 1812 d. 1870
Delphia Lawson b. Abt 1816
- 12 Adam Winwright Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.1]
b. 2 Nov 1834 d. 27 Dec 1908 [ =>]
- 12 Susannah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.2]
b. Abt 1837
- 12 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.3]
b. Abt 1839
- 12 Stacia Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.4]
b. Abt 1841
- 12 John J Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.5]
b. 6 Sep 1844 d. 9 May 1917
- 12 Welbourn Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.6]
b. Sep 1847 d. 1910
- 12 Will W Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.7]
b. 1848 d. 28 Feb 1928
- 12 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.8]
b. Abt 1853
- 12 Emily Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.9]
b. Abt 1855
- 12 Laura Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.10]
b. Abt 1859
- 12 Adam Winwright Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.3.1]
- 11 Hiniard Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.4]
b. 1817 d. 1860
Jane Lawson b. 1820
- 12 Pleasant Wiley Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.4.1]
b. 1836 d. 1915 [ =>]
- 12 Pleasant Wiley Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.4.1]
- 11 Sarah S Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1.1]
- 10 Cader Rountree, Jr [1.1.1.1.3.7.2.3.2.1]
- 9 William Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3]
b. 1740 d. 1791
Rachel White b. 1740 d. 1789
- 10 James Lester Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1]
b. 1787 d. 26 Mar 1834
Nancy Hendley b. 1793 d. 1845
- 11 Harriet Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.1]
b. 12 Jan 1812 d. 10 Nov 1873
- + McMullen b. Abt 1811
- + McMullen b. Abt 1811
- 11 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.2]
b. 25 Oct 1814 d. 27 Jan 1906
- + McMullen b. Abt 1813
- + McMullen b. Abt 1813
- 11 Weston W Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.3]
b. 5 Jun 1815 d. 12 Feb 1895
- 11 Henrietta E Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.4]
b. May 1817 d. 1901
- + Wells b. Abt 1816
- + Wells b. Abt 1816
- 11 James Lester Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.5]
b. 18 Dec 1823 d. 14 Nov 1905
Elizabeth C Sutton b. 1825 d. 1898
- 12 John Albert Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.5.1]
b. 1846 d. 1927 [ =>]
- 12 John Albert Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.5.1]
- 11 Annie Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.6]
b. Jan 1826 d. 28 Feb 1910
- + James Folsom b. 10 May 1812 d. 28 Oct 1865
- + James Folsom b. 10 May 1812 d. 28 Oct 1865
- 11 Harriet Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1.1]
- 10 Francis Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.2]
b. 1787 d. 1836
Henrietta Lester b. 1787 d. 1851
- 11 Sarah Ann Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.2.1]
b. 1824 d. 11 Feb 1895
- + John Milton Towles b. 1819 d. 1875
- + John Milton Towles b. 1819 d. 1875
- 11 Sarah Ann Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.2.1]
- 10 James Lester Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.3.1]
- 9 Susannah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.4]
b. 1741 d. 1805
Joseph Camp b. 1741 d. 1813
- 10 Abner Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1]
b. 1772 d. Mar 1858
Margaret Earl b. 1779 d. 14 Oct 1845
- 11 Joseph Alexander Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.1]
b. 1800 d. 17 Jan 1876
Lucretia Taylor
- 12 Joseph Alexander Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.1.1]
b. 13 Feb 1841 d. 12 Oct 1923 [ =>]
- 12 Joseph Alexander Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.1.1]
- 11 Lawson Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.2]
b. 1804 d. 1896
Margaret Peggy Hardin b. 1814 d. 1858
- 12 Elizabeth Margaret Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.2.1]
b. 3 May 1833 d. 30 Dec 1895 [ =>]
- 12 Elizabeth Margaret Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.2.1]
- 11 Joseph Alexander Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1.1]
- 10 Rebecca Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.2]
b. 1790 d. 1860
Geroge Washington Wilson b. 1790
- 11 Washington Cooper Wilson [1.1.1.1.3.7.2.3.4.2.1]
b. 1817 d. 28 Dec 1861
Lucinda Cook b. Abt 1825
- 12 George Washington Wilson [1.1.1.1.3.7.2.3.4.2.1.1]
b. Abt 1857 [ =>]
- 12 George Washington Wilson [1.1.1.1.3.7.2.3.4.2.1.1]
- 11 Washington Cooper Wilson [1.1.1.1.3.7.2.3.4.2.1]
- 10 Abner Camp [1.1.1.1.3.7.2.3.4.1]
- 9 Moses Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5]
b. Bef 1748 d. Apr 1804
Theresa Polly Thomas b. 1757 d. 1792
- 10 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.1]
b. 1780 d. 1817
- + William Ellis b. 1779 d. 1831
- + William Ellis b. 1779 d. 1831
- 10 Sally Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.2]
b. Abt 1781
- 10 Lewis Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.3]
b. 1782 d. 4 Mar 1850
- 10 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.4]
b. 1783 d. 10 May 1855
Stephen Tomlinson b. 2 Dec 1777 d. 1 Jun 1835
- 11 Jonathan William Tomlinson [1.1.1.1.3.7.2.3.5.4.1]
b. 26 Aug 1801 d. 2 Mar 1875
Precilla Rentfrow b. 1806 d. 21 Sep 1866
- 12 Jonathan William Tomlinson [1.1.1.1.3.7.2.3.5.4.1.1]
b. 17 Apr 1834 [ =>]
- 12 Jonathan William Tomlinson [1.1.1.1.3.7.2.3.5.4.1.1]
- 11 Jonathan William Tomlinson [1.1.1.1.3.7.2.3.5.4.1]
- 10 Theresa Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.5]
b. 1785 d. 10 May 1855
- + John C M Strickland b. Abt 1780
- + John C M Strickland b. Abt 1780
- 10 Willie Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.6]
b. 1790 d. 1847
Martha Dew b. 26 Mar 1798
- 11 Obedience Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.6.1]
b. 27 Jan 1827 d. 7 Aug 1895
- + John William Farmer b. Jun 1817 d. 13 Jun 1888
- + John William Farmer b. Jun 1817 d. 13 Jun 1888
- 11 Delphia Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.6.2]
b. 1 Dec 1828 d. 6 Feb 1892
- + William Elder Woodard b. 6 Nov 1830 d. 11 Sep 1910
- + William Elder Woodard b. 6 Nov 1830 d. 11 Sep 1910
- 11 Obedience Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.6.1]
- 10 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.1]
Priscilla White d. 29 Dec 1804
- 10 Benajah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.7]
b. Abt 1802
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.8]
b. Abt 1803
- 10 Nathan H Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.9]
b. 1804 d. 4 Sep 1837
- 10 Benajah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.5.7]
- 9 Francis Rountree, V [1.1.1.1.3.7.2.3.6]
b. Sep 1748 d. 1793
- 9 Reuben Rountree [1.1.1.1.3.7.2.3.1]
- 8 Martha Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4]
b. 1720 d. 1793
Jacob Renfro b. 1731 d. 1825
- 9 Penelope Renfro [1.1.1.1.3.7.2.4.1]
b. 1770 d. 1830
Cader Rountree, Jr b. 1767 d. 27 Aug 1821
- 10 Sarah S Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1]
b. 17 Oct 1794 d. 1847
Captain John Williams b. 1798 d. 5 Oct 1862
- 11 Isaac Newton Williams [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1.1]
b. 4 Jun 1833 d. 18 Jun 1888
Alice Margaret Menefee b. 26 Jan 1835 d. 20 Mar 1914
- 12 Eugenia Isabel Danie Williams [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1.1.1]
b. 17 Jan 1854 d. 30 Dec 1935 [ =>]
- 12 Albert Lee Williams [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1.1.2]
b. 14 Jun 1873 d. 7 Sep 1944 [ =>]
- 12 Eugenia Isabel Danie Williams [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1.1.1]
- 11 Isaac Newton Williams [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1.1]
- 10 Francis R Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2]
b. 1800 d. 1863
Nancy Strother b. 9 Nov 1800 d. 20 Jan 1886
- 11 Thomas Jefferson Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1]
b. 24 May 1830 d. 15 Dec 1877
Rebecca McAnally b. 13 Dec 1830 d. 6 Apr 1877
- 12 Millard Francis Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1.1]
b. 7 Jan 1852 d. 1 Dec 1917 [ =>]
- 12 John W Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1.2]
b. 15 Jun 1854 d. 29 Mar 1911 [ =>]
- 12 James Thomas Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1.3]
b. 1859 d. 1933 [ =>]
- 12 William Coleman Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1.4]
b. 1 Sep 1869 d. 2 Aug 1939
- 12 Millard Francis Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1.1]
- 11 Thomas Jefferson Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.2.1]
- 10 Jesse Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3]
b. 8 Nov 1812 d. 1870
Delphia Lawson b. Abt 1816
- 11 Adam Winwright Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1]
b. 2 Nov 1834 d. 27 Dec 1908
Susan Easter Dykes b. 2 Jan 1845 d. 6 Oct 1888
- 12 John Lawson Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.1]
b. 1 Oct 1861 d. 7 Jul 1956 [ =>]
- 12 Isaac Thomas Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.2]
b. 15 Jan 1866 d. 24 Feb 1917 [ =>]
- 12 David Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.3]
b. Abt 1867
- 12 Marion Dennis Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.4]
b. 7 Jul 1867 d. 21 Sep 1936
- 12 Charles Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.5]
b. Abt 1869
- 12 Rosanna Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.6]
b. Abt 1872
- 12 Jesse Winright Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.7]
b. 24 Nov 1872 d. 19 Jun 1940 [ =>]
- 12 Stacey R Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.8]
b. Abt 1876 d. 23 Nov 1953
- 12 Laura Malifa Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.9]
b. 10 Aug 1878 d. 7 Dec 1959
- 12 John Lawson Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.1]
Martha Benton b. 2 Feb 1858 d. 11 Jan 1907
- 12 Anna Pearl Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.10]
b. Aug 1893 d. 20 Sep 1906
- 12 Thomas Cayce Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.11]
b. 22 Feb 1897 d. Sep 1973
- 12 Anna Pearl Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1.10]
- 11 Susannah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.2]
b. Abt 1837
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.3]
b. Abt 1839
- 11 Stacia Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.4]
b. Abt 1841
- 11 John J Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.5]
b. 6 Sep 1844 d. 9 May 1917
- 11 Welbourn Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.6]
b. Sep 1847 d. 1910
- 11 Will W Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.7]
b. 1848 d. 28 Feb 1928
- 11 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.8]
b. Abt 1853
- 11 Emily Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.9]
b. Abt 1855
- 11 Laura Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.10]
b. Abt 1859
- 11 Adam Winwright Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.3.1]
- 10 Hiniard Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.4]
b. 1817 d. 1860
Jane Lawson b. 1820
- 11 Pleasant Wiley Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.4.1]
b. 1836 d. 1915
Sarah Hayes
- 12 Pleasant Hinyard Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.4.1.1]
b. 7 Dec 1866 d. 7 Apr 1915 [ =>]
- 12 Edward Lee Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.4.1.2]
b. 1874 d. 1907 [ =>]
- 12 Pleasant Hinyard Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.4.1.1]
- 11 Pleasant Wiley Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.4.1]
- 10 Sarah S Rountree [1.1.1.1.3.7.2.4.1.1]
- 9 Penelope Renfro [1.1.1.1.3.7.2.4.1]
- 8 Jethro Rountree [1.1.1.1.3.7.2.1]
- 7 William Rountree [1.1.1.1.3.7.3]
b. 1710 d. 1742
Rachel b. 1710
- 8 William Reuben Rountree [1.1.1.1.3.7.3.1]
b. 1733 d. 1815
- 9 Reuben Rountree [1.1.1.1.3.7.3.1.1]
b. 1791 d. 1861
- + Elizabeth Trentham b. 1795 d. 1861
- + Elizabeth Trentham b. 1795 d. 1861
- 9 Reuben Rountree [1.1.1.1.3.7.3.1.1]
- 8 Job Rountree, Sr [1.1.1.1.3.7.3.2]
b. 1735 d. 1782
- 9 Job Rountree, Jr [1.1.1.1.3.7.3.2.1]
b. 13 Mar 1761 d. 1846
- 10 Levi Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.1]
b. 1772 d. Abt 1841
- 10 Adah Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.2]
b. 1778 d. 25 Sep 1840
- + Job Wethersbee b. 1775 d. 1819
- + Job Wethersbee b. 1775 d. 1819
- 10 Louisiana Zealey Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.3]
b. 1800 d. Abt 1890
Harmon Baughmann b. 1790 d. 1855
- 11 Henry Baughmann [1.1.1.1.3.7.3.2.1.3.1]
b. 1 Mar 1829 d. 10 Jan 1879
Mary Beck b. 14 Apr 1836 d. 27 Oct 1917
- 12 Indiana E Baughmann [1.1.1.1.3.7.3.2.1.3.1.1]
b. 23 May 1858 d. 27 Jan 1943 [ =>]
- 12 Indiana E Baughmann [1.1.1.1.3.7.3.2.1.3.1.1]
- 11 Henry Baughmann [1.1.1.1.3.7.3.2.1.3.1]
- 10 Levi Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.1]
Mary Little
- 10 Captain William Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.4]
b. 18 Feb 1790 d. 9 Jun 1860
Sallie Jane b. Abt 1799
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.4.1]
b. Abt 1833
- 11 Laura Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.4.2]
b. Abt 1835
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.4.1]
- 10 Captain William Rountree [1.1.1.1.3.7.3.2.1.4]
- 9 Job Rountree, Jr [1.1.1.1.3.7.3.2.1]
- 8 William Reuben Rountree [1.1.1.1.3.7.3.1]
- 7 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.4]
b. 1715 d. 1761
John Kittrell b. 1718 d. 1780
- 8 Sarah Kittrell [1.1.1.1.3.7.4.1]
b. 1740 d. 1778
James Arline b. 1739 d. 26 Dec 1791
- 9 John Arline [1.1.1.1.3.7.4.1.1]
b. 1762 d. 1813
Phereby Pullen b. 1779 d. 1824
- 10 Sarah Ann Arline [1.1.1.1.3.7.4.1.1.1]
b. 29 Oct 1802 d. 8 Aug 1857
James Wesley Glass b. 1798 d. 11 Jul 1861
- 11 Elizabeth Lizzie Glass [1.1.1.1.3.7.4.1.1.1.1]
b. 1833 d. 26 Nov 1931
William Jasper Earnest b. 1828 d. 8 Aug 1916
- 12 John James Earnest [1.1.1.1.3.7.4.1.1.1.1.1]
b. 28 Sep 1855 d. 29 Mar 1933 [ =>]
- 12 John James Earnest [1.1.1.1.3.7.4.1.1.1.1.1]
- 11 Elizabeth Lizzie Glass [1.1.1.1.3.7.4.1.1.1.1]
- 10 Sarah Ann Arline [1.1.1.1.3.7.4.1.1.1]
- 9 John Arline [1.1.1.1.3.7.4.1.1]
- 8 Sarah Kittrell [1.1.1.1.3.7.4.1]
Thomas Walton, Sr b. 1713 d. 1759
- 8 Thomas Walton, Jr [1.1.1.1.3.7.4.2]
b. 1739 d. 16 Apr 1806
Sarah Mary Haire b. 1743 d. 1797
- 9 William Haire Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.1]
b. 1778 d. 23 Oct 1815
Elizabeth Matilda Cratin b. 1786 d. 22 Oct 1866
- 10 Julia Antoinette Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1]
b. 22 Nov 1806 d. Abt 1880
Dr Richard Van Bray b. 1798 d. Abt 1824
- 11 Captain William Chrystoston Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1]
b. 27 Dec 1822 d. 28 Jun 1880
Arry Anne Brown b. 12 Mar 1834 d. 24 Sep 1922
- 12 Isabella Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.1]
b. 1861
- 12 Charlie W. Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.2]
b. 1865
- 12 Antoinette E. Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.3]
b. 1867
- 12 Baxter B. Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.4]
b. 1868
- 12 Robert W. Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.5]
b. 1870
- 12 Clarence V. Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.6]
b. 1872
- 12 Claudius Julius Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.7]
b. 16 Jul 1876 d. 23 Jan 1972 [ =>]
- 12 Isabella Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1.1]
- 11 Captain William Chrystoston Bray [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1.1]
- 10 Julia Antoinette Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.1.1]
- 9 James Benton Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.2]
b. 1780 d. 28 Oct 1812
Alcey Steele b. Mar 1786 d. 20 Mar 1852
- 10 Thomas Steele Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.2.1]
b. 2 Apr 1807 d. 23 Sep 1845
Frances Lowe Anderson b. 21 Oct 1809 d. 2 Nov 1908
- 11 Aurelia Qualls Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.2.1.1]
b. 1833 d. 1894
William Ferguson Cole b. 1818 d. 1901
- 12 Walter Steele Cole [1.1.1.1.3.7.4.2.2.1.1.1]
b. 2 Jan 1853 d. 11 Nov 1925 [ =>]
- 12 Walter Steele Cole [1.1.1.1.3.7.4.2.2.1.1.1]
- 11 Aurelia Qualls Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.2.1.1]
- 10 Thomas Steele Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.2.1]
- 9 William Haire Walton [1.1.1.1.3.7.4.2.1]
- 8 Richard Walton [1.1.1.1.3.7.4.3]
b. 1739 d. 1814
Suzanne Smith b. 8 Apr 1739 d. 1814
- 9 Susannah Walton [1.1.1.1.3.7.4.3.1]
b. 1771
Daniel Kern b. 1770 d. 1835
- 10 Daniel Kern, Jr [1.1.1.1.3.7.4.3.1.1]
b. Abt 1811 d. Abt 1870
Eliza Thomas b. 1811 d. 1860
- 11 Daniel Kern, III [1.1.1.1.3.7.4.3.1.1.1]
b. 17 Jul 1841 d. 5 Sep 1870
Mary Catherine Mitchell b. 1835 d. 1921
- 12 Edward Lester Kern [1.1.1.1.3.7.4.3.1.1.1.1]
b. 12 Jan 1870 d. 6 Aug 1951 [ =>]
- 12 Edward Lester Kern [1.1.1.1.3.7.4.3.1.1.1.1]
- 11 Daniel Kern, III [1.1.1.1.3.7.4.3.1.1.1]
- 10 Daniel Kern, Jr [1.1.1.1.3.7.4.3.1.1]
- 9 Susannah Walton [1.1.1.1.3.7.4.3.1]
- 8 Mary Katherine Christian Walton [1.1.1.1.3.7.4.4]
b. 1739 d. 1808
Abraham Hill b. 1732 d. 1792
- 9 Celia Hill [1.1.1.1.3.7.4.4.1]
b. 1768 d. 1866
Joseph Hayes b. 1762 d. 1840
- 10 John Hayes [1.1.1.1.3.7.4.4.1.1]
b. 1804 d. 1887
Rachel Catherine Payne b. 1814 d. 1885
- 11 Celia Catherine Hays [1.1.1.1.3.7.4.4.1.1.1]
b. 1846 d. 1912
- + John F Sullivan, (xfer) b. 1846 d. 1930
- + John F Sullivan, (xfer) b. 1846 d. 1930
- 11 Celia Catherine Hays [1.1.1.1.3.7.4.4.1.1.1]
- 10 John Hayes [1.1.1.1.3.7.4.4.1.1]
- 9 Wylie Hill [1.1.1.1.3.7.4.4.2]
b. 1775 d. 1844
Martha Pope b. 1782 d. 1853
- 10 Sarah C W Hill [1.1.1.1.3.7.4.4.2.1]
b. 1807 d. 1842
John Jordan b. 1793 d. 1856
- 11 Benjamin Flemin Jordan [1.1.1.1.3.7.4.4.2.1.1]
b. 1831 d. 1896
Martha V Anderson b. 1837 d. 1891
- 12 Benjamin F Jordan [1.1.1.1.3.7.4.4.2.1.1.1]
b. 1863 d. 1927 [ =>]
- 12 Benjamin F Jordan [1.1.1.1.3.7.4.4.2.1.1.1]
- 11 Benjamin Flemin Jordan [1.1.1.1.3.7.4.4.2.1.1]
- 10 Sarah C W Hill [1.1.1.1.3.7.4.4.2.1]
- 9 Celia Hill [1.1.1.1.3.7.4.4.1]
- 8 William Walton, Sr [1.1.1.1.3.7.4.5]
b. 1740 d. 13 Jun 1797
Elizabeth Smith b. 20 Dec 1746 d. 14 Apr 1783
- 9 Timothy Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.1]
b. 1768 d. 1828
- 9 Nancy Ann Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.2]
b. 1771 d. 1843
- 9 Martha Patsy Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.3]
b. 1772
- 9 Samuel Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.4]
b. 1776 d. 1850
- 9 William H Walton, Jr [1.1.1.1.3.7.4.5.5]
b. 1777 d. 5 Mar 1844
Sarah Avera b. 20 Dec 1776 d. 1850
- 10 Timothy Jones Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1]
b. 10 Oct 1800 d. 19 Apr 1882
- + Elizabeth Jones b. Abt 1802 d. Bef 1850
Emma Elvira Haren b. 1 Jan 1822 d. 25 Feb 1863
- 11 Jesse Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.1]
b. 1851
- 11 Nancy Emily Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.2]
b. 25 May 1853 d. 9 May 1936
- + Allison b. Abt 1852
- + Allison b. Abt 1852
- 11 Julia Catherine Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3]
b. 12 Feb 1855 d. 17 Oct 1930
Robert Pollock Brittain b. 9 May 1848 d. 21 Jan 1937
- 12 Magdalia Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.1]
b. 22 Feb 1872 d. 3 Sep 1958
- 12 Rev Phoenicia Hinson Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.2]
b. 2 Jul 1876 d. 14 Mar 1948 [ =>]
- 12 Lavinia Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.3]
b. 21 Feb 1882 d. 22 Mar 1923
- 12 Minevia Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.4]
b. 11 Nov 1884 d. 28 Apr 1981
- 12 Vistula Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.5]
b. 2 Jul 1887 d. 25 Mar 1954
- 12 Verona Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.6]
b. 3 Nov 1889 d. 4 Oct 1973
- 12 Rev Nebula Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.7]
b. 4 Dec 1892 d. 15 Apr 1930
- 12 Iberea Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.8]
b. 29 Jan 1895 d. 26 Dec 1971
- 12 Magdalia Brittain [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.3.1]
- 11 Mary Jane Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.4]
b. 25 Dec 1857 d. 20 May 1943
- + Isaac Holcombe b. Abt 1855
- + Isaac Holcombe b. Abt 1855
- 11 William Killian Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5]
b. 9 Jun 1861 d. 17 Oct 1933
Ida Vandora Wagner b. 20 May 1868 d. 4 Jun 1947
- 12 Emma Elvira Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.1]
b. 13 Mar 1893 d. 25 Jun 1916
- 12 Alice Merle Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.2]
b. 4 Jan 1895 d. 24 Jan 1969
- 12 Ralph Avery Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.3]
b. 21 Mar 1897 d. 25 Dec 1960 [ =>]
- 12 Minnie Bell Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.4]
b. 16 Mar 1899 d. 4 Mar 1977
- 12 William Orph Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.5]
b. 18 Aug 1902 d. 5 Dec 1966
- 12 Mary Tom Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.6]
b. 13 Jun 1906 d. 27 Dec 2001
- 12 Jesse Marvin Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.7]
b. 20 May 1909 d. 1 Oct 1960
- 12 Emma Elvira Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.5.1]
- 11 Jesse Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1.1]
- + Elizabeth Jones b. Abt 1802 d. Bef 1850
- 10 Thomas Aventon Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.2]
b. 1 Sep 1804 d. 4 Sep 1885
Delaney Collins b. 17 Jul 1810 d. 16 Jun 1882
- 11 Abington F Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.2.1]
b. 23 Feb 1827 d. 22 Jul 1908
Sarah Ann Dowdy b. Dec 1831 d. 1918
- 12 Americus C Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.2.1.1]
b. 25 Dec 1854 d. 6 Mar 1930 [ =>]
- 12 Americus C Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.2.1.1]
- 11 Abington F Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.2.1]
- 10 David Samuel Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3]
b. 1811 d. 1870
Edith Avera b. 29 Jun 1807 d. 1880
- 11 Sarah Caroline Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1]
b. 1829 d. 1887
Rev Joel Monroe Utley b. 1820 d. 1887
- 12 David Alvin Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.1]
b. 1852 d. 1894 [ =>]
- 12 Mary Jane Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.2]
b. 1853 d. 13 May 1918 [ =>]
- 12 Samuel Sidney Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.3]
b. 29 Nov 1855 d. 1 Jul 1892 [ =>]
- 12 Robert Lee Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.4]
b. 29 Jan 1863 d. 7 Jun 1925 [ =>]
- 12 Louisa J Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.5]
b. 1866 d. 3 Nov 1929
- 12 Thomas G Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.6]
b. 1869 d. 1920 [ =>]
- 12 Walter R. Uttey [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.7]
b. 1869
- 12 Lela Edith Uttey [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.8]
b. 1871 d. 6 Apr 1957 [ =>]
- 12 Alonza Uttey [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.9]
b. 1873
- 12 James Alonzo Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.10]
b. 22 May 1873 d. 24 Dec 1939 [ =>]
- 12 Winnie E. Uttey [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.11]
b. 1876
- 12 David Alvin Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1.1]
- 11 James Henry Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2]
b. 1836 d. 8 Feb 1906
Sina Simpson d. 1869
- 12 Thomas Gracy Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.1]
b. 25 Oct 1861 d. 2 Apr 1925 [ =>]
- 12 Mary J. Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.2]
b. 1865 d. Yes, date unknown
- 12 Padetta Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.3]
b. 1866 d. 1866
- 12 Sina P Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.4]
b. 1869 d. 1869
- 12 Thomas Gracy Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.1]
Mary C Cox b. 1847 d. Sep 1880
- 12 Madora Elizabeth Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.5]
b. 22 Nov 1871 d. 1 Jun 1950 [ =>]
- 12 Adina Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.6]
b. 1875 d. 1947 [ =>]
- 12 James Tilden Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.7]
b. 9 Oct 1876 d. 25 Jun 1936
- 12 Queen Victoria Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.8]
b. 1878 d. 21 Jul 1956 [ =>]
- 12 William D Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.9]
b. 1880 d. 2 Oct 1880
- 12 Madora Elizabeth Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.5]
Cornelia Alexander b. 1853 d. 12 Jun 1930
- 12 Summerville Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.10]
b. 1880 d. 1883
- 12 Edith Dixie Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.11]
b. 1882 d. 22 Oct 1970 [ =>]
- 12 Maude Gertrue Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.12]
b. 15 Dec 1884 d. 29 Nov 1968 [ =>]
- 12 John David Walton, Sr [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.13]
b. 1888 d. 15 Mar 1938 [ =>]
- 12 Alexander Leon Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.14]
b. 17 Nov 1895
- 12 Summerville Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.2.10]
- 11 Louisa W Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.3]
b. 29 Apr 1837 d. 16 Jul 1877
William S Nixon b. 1832 d. 1880
- 12 Perry Monroe Nixon [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.3.1]
b. May 1864 d. 19 Jan 1938 [ =>]
- 12 Laura E Nixon [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.3.2]
b. 9 Feb 1866 d. Jul 1902
- 12 Irwin Randolph Nixon [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.3.3]
b. 12 Jul 1870 d. 9 Nov 1927 [ =>]
- 12 Perry Monroe Nixon [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.3.1]
- 11 Jane Hauk Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.4]
b. 1840 d. 1884
Dr Lucius Thornton Hocutt b. 23 Oct 1843 d. 30 Oct 1923
- 12 Cevannah Caroline Hocutt [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.4.1]
b. 11 Nov 1866 d. 18 Apr 1921 [ =>]
- 12 Cevannah Caroline Hocutt [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.4.1]
- 11 William Thomas Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.5]
b. 1843 d. 1918
Texannah Miller b. 1856 d. 1903
- 12 William Adolphus Walton, Sr [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.5.1]
b. Jun 1874 d. Apr 1928 [ =>]
- 12 Olver Hauser Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.5.2]
b. 17 Feb 1878 d. 8 Dec 1962 [ =>]
- 12 William Adolphus Walton, Sr [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.5.1]
- 11 Sarah Caroline Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.3.1]
- 10 William Samuel Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.4]
b. 13 Apr 1813 d. 22 Oct 1893
Harriett Elizazbeth Phifer
- 11 William Thomas Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.4.1]
b. 24 Jul 1862 d. 29 Dec 1939
Mollie Elizabeth Vess b. 14 Jan 1869 d. 11 Oct 1950
- 12 James Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.4.1.1]
b. 10 Mar 1896 d. 14 Nov 1982 [ =>]
- 12 James Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.4.1.1]
- 11 William Thomas Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.4.1]
- 10 Timothy Jones Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.5.1]
- 9 Sarah Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.6]
b. 10 Feb 1779 d. 2 Nov 1838
Rev LIttlejohn Utley b. 7 Feb 1775 d. 13 May 1859
- 10 Samuel Walton Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1]
b. 28 Oct 1799 d. 20 Aug 1852
Mariah Berry
- 11 Gabriel Marion Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1.1]
b. 27 Jul 1844 d. 2 Aug 1929
Sophia Minerva Burgess b. 20 Feb 1853 d. 13 Mar 1909
- 12 John Burgess Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1.1.1]
b. 14 Nov 1886 d. 24 Jan 1950 [ =>]
- 12 Ethel Sophia Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1.1.2]
b. 4 Feb 1888 d. 29 Mar 1953 [ =>]
- 12 John Burgess Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1.1.1]
- 11 Gabriel Marion Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1.1]
- 10 Littlejohn Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.2]
b. 1 Feb 1806 d. 27 Dec 1871
- 10 Foster Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3]
b. 9 Jun 1820 d. 13 Jun 1894
Sarah Sallie Collier Davis b. 27 Jul 1824 d. 30 Nov 1902
- 11 Thomas Jasper Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.1]
b. 25 Jun 1847 d. 6 Oct 1911
Delia Emmett Cheek b. 10 Jun 1856 d. 9 Jul 1926
- 12 Bertha White Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.1.1]
b. 10 Sep 1879 d. 23 Mar 1951 [ =>]
- 12 Bertha White Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.1.1]
- 11 William Sanders Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.2]
b. 1851 d. 1910
Ella Madora Price b. 1857 d. 1914
- 12 Eugene Foster Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.2.1]
b. 1880 d. 1953
- 12 Eugene Foster Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.2.1]
- 11 Susan Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.3]
b. 1855
- 11 Sallie S Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.4]
b. 1859
- 11 Manuel Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.5]
b. 1864
- 11 Rosa T Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.6]
b. 1867
- 11 Lewis G Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.7]
b. 1869
- 11 Thomas Jasper Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.3.1]
- 10 Samuel Walton Utley [1.1.1.1.3.7.4.5.6.1]
- 9 John Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.7]
b. 1781 d. 1866
- 9 Elizabeth Betsy Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.8]
b. 1786 d. 29 May 1853
Samuel Suggs b. 23 Feb 1781 d. 18 May 1827
- 10 Charles Hinton Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.1]
b. 15 Jun 1818 d. 1890
Avazilla Parrish b. 1840 d. 1911
- 11 Charles Patrick Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.1.1]
b. 5 Jun 1855 d. 27 Jul 1937
Elizabeth Jsne Leach b. 25 Aug 1858 d. 21 Aug 1913
- 12 Minnie Lou Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.1.1.1]
b. 13 Nov 1895 d. 5 Oct 1929 [ =>]
- 12 Minnie Lou Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.1.1.1]
- 11 Charles Patrick Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.1.1]
- 10 James Newton Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.2]
b. 7 Nov 1823
Sarah M Rombeau b. 21 Feb 1833 d. 5 Nov 1910
- 11 Samuel R Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.2.1]
b. 17 Apr 1877 d. 18 Apr 1954
Cleo Taylor b. 1 Jun 1877 d. 5 Jun 1931
- 12 Andrew Lee Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.2.1.1]
b. 29 Jul 1901 d. 31 Oct 1971 [ =>]
- 12 Andrew Lee Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.2.1.1]
- 11 Samuel R Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.2.1]
- 10 Charles Hinton Suggs [1.1.1.1.3.7.4.5.8.1]
- 9 Christian Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.9]
b. 1791 d. 1846
- 9 Timothy Walton [1.1.1.1.3.7.4.5.1]
- 8 Thomas Walton, Jr [1.1.1.1.3.7.4.2]
- 7 Jesse Rountree, Sr [1.1.1.1.3.7.5]
b. 1722 d. 17 Oct 1777
Mary Barnes b. 1724 d. 1793
- 8 Jesse Rountree, Jr [1.1.1.1.3.7.5.1]
b. 1745 d. 1820
Rachel Spivey b. 1743 d. 1779
- 9 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.1]
- 9 Jesse Rountree, III [1.1.1.1.3.7.5.1.2]
b. 27 Jun 1765 d. 12 Apr 1831
Winifred Jenkins b. 11 Apr 1765 d. 14 Dec 1840
- 10 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1]
b. 24 Dec 1784 d. 1850
Jacob Atkinson b. 12 Apr 1776 d. 29 Mar 1837
- 11 Winnifred Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.1]
b. 1801 d. 1870
William Pipkin b. 1787 d. 1855
- 12 Louisa Pipkin [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.1.1]
b. 1815 d. 1880 [ =>]
- 12 William Pipkin [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.1.2]
b. 1817 d. 1880 [ =>]
- 12 Joseph John Pipkin [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.1.3]
b. 1824 d. 1895 [ =>]
- 12 Louisa Pipkin [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.1.1]
- 11 Jesse Rountree Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.2]
b. 1811 d. 1882
Martha Ann Brewer b. 1811 d. 1876
- 12 Philanthrophy Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.2.1]
b. 1850 d. 1930 [ =>]
- 12 Philanthrophy Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.2.1]
- 11 Benjamin Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.3]
b. 1814 d. 1855
- 11 John Wright Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.4]
b. 1821 d. 1910
- 11 Winnifred Atkinson [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1.1]
- 10 William Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.2]
b. 15 Nov 1792 d. 26 Aug 1827
Sally Forbes b. Bef 5 Sep 1802
- 11 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.2.1]
b. 3 Apr 1817 d. 1878
- + Caleb C Cannon b. 1815 d. 1887
- + Caleb C Cannon b. 1815 d. 1887
- 11 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.2.1]
- 10 Charles Jenkins Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3]
b. 17 Mar 1794 d. 17 Jan 1845
Susannah Hart b. 18 Nov 1796 d. 25 Apr 1853
- 11 Samuel Hart Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.1]
b. 23 Feb 1825 d. 12 Sep 1906
Martha Ann J Dunn b. 1829 d. 1898
- 12 William R Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.1.1]
b. 1870 d. 1933 [ =>]
- 12 William R Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.1.1]
- 11 Dr Dr. Francis Marion Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.2]
b. 2 Jun 1836 d. 19 Feb 1888
Alice E Edwards
- 12 Albert Edwards Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.2.1]
b. 19 Jan 1878 d. 4 Mar 1934 [ =>]
- 12 Albert Edwards Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.2.1]
- 11 Samuel Hart Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.3.1]
- 10 Sally Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.4]
b. 7 Nov 1796 d. 10 Dec 1847
John Simmons Brown b. 24 Dec 1788 d. 30 May 1864
- 11 Sarah Sally Ann Brown [1.1.1.1.3.7.5.1.2.4.1]
b. 27 Jun 1829 d. 23 Nov 1863
Joseph Devin b. 16 Nov 1826 d. 26 Mar 1863
- 12 Elvira Ann Devin [1.1.1.1.3.7.5.1.2.4.1.1]
b. 21 Jan 1851 d. 4 Mar 1914 [ =>]
- 12 Elvira Ann Devin [1.1.1.1.3.7.5.1.2.4.1.1]
- 11 Sarah Sally Ann Brown [1.1.1.1.3.7.5.1.2.4.1]
- 10 Rachel Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.5]
b. 6 Feb 1800 d. 5 Nov 1886
- + Asa Brown b. 1794 d. 1851
- + Asa Brown b. 1794 d. 1851
- 10 Winnifred Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.6]
b. 5 Aug 1807 d. 6 Nov 1869
- + Benjamin Brown b. 2 Jan 1798 d. 9 Jul 1862
- + Benjamin Brown b. 2 Jan 1798 d. 9 Jul 1862
- 10 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.2.1]
- 9 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.5.1.1]
- + Elizabeth White
- 8 John Rountree [1.1.1.1.3.7.5.2]
b. 1746
- 8 William Rountree [1.1.1.1.3.7.5.3]
b. 1750 d. Dec 1791
- 8 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.7.5.4]
b. 1750
- 8 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.5.5]
b. 1755 d. 1820
John Frizzle b. 1717 d. 1818
- 9 Penelope Frizzle [1.1.1.1.3.7.5.5.1]
Enoch Albritton
- 10 George Washington Albritton [1.1.1.1.3.7.5.5.1.1]
b. 23 Oct 1810 d. 28 Oct 1867
Sarah Ann Fowler
- 11 Joseph Ford Albritton [1.1.1.1.3.7.5.5.1.1.1]
b. 20 Apr 1864 d. 1934
Holland Slawson
- 12 Elva Elizabeth Albritton [1.1.1.1.3.7.5.5.1.1.1.1]
b. 7 Nov 1893 d. 5 Aug 1937 [ =>]
- 12 Elva Elizabeth Albritton [1.1.1.1.3.7.5.5.1.1.1.1]
- 11 Joseph Ford Albritton [1.1.1.1.3.7.5.5.1.1.1]
- 10 George Washington Albritton [1.1.1.1.3.7.5.5.1.1]
- 9 Mary Frizzle [1.1.1.1.3.7.5.5.2]
b. 1772 d. 1855
James Hancock, Jr b. 29 Nov 1774 d. 20 Jul 1845
- 10 James Raymond Hancock [1.1.1.1.3.7.5.5.2.1]
b. 1797 d. 12 Aug 1854
Majoy Margeanna b. 1800 d. 1865
- 11 Mary Elizabeth Hancock [1.1.1.1.3.7.5.5.2.1.1]
b. 1815 d. 1890
Elisha Plyler b. 1810 d. 1884
- 12 James Milbern Plyler [1.1.1.1.3.7.5.5.2.1.1.1]
b. 22 May 1850 d. 20 Oct 1902 [ =>]
- 12 James Milbern Plyler [1.1.1.1.3.7.5.5.2.1.1.1]
- 11 Mary Elizabeth Hancock [1.1.1.1.3.7.5.5.2.1.1]
- 10 James Raymond Hancock [1.1.1.1.3.7.5.5.2.1]
- 9 Penelope Frizzle [1.1.1.1.3.7.5.5.1]
- + James Hancock
- 8 John Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6]
b. 1756 d. 27 Jul 1821
Nancy Manning b. 1765 d. 1792
- 9 Joshua Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1]
b. 1783 d. 1851
Zilphia Durden b. 16 Nov 1784 d. 1870
- 10 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.1]
b. 5 Dec 1804 d. 3 Oct 1851
Moultry Miller Braddy b. 1800 d. 1865
- 11 Alonzo Ebeneezer Braddy [1.1.1.1.3.7.5.6.1.1.1]
b. Apr 1839 d. 1904
Harriet Sutton b. 1853 d. 1887
- 12 Lonnie Eben Braddy [1.1.1.1.3.7.5.6.1.1.1.1]
b. 17 Mar 1884 d. 4 Jun 1951 [ =>]
- 12 Lonnie Eben Braddy [1.1.1.1.3.7.5.6.1.1.1.1]
- 11 Alonzo Ebeneezer Braddy [1.1.1.1.3.7.5.6.1.1.1]
- 10 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.2]
b. 15 Apr 1807 d. 25 Jun 1890
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3]
b. 24 Jul 1809 d. 6 Sep 1858
Nancy Brown b. 6 Apr 1802 d. 8 Feb 1863
- 11 Lucinda Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.1]
b. Feb 1826 d. 18 Dec 1922
Bird Lewis Sumner b. 8 Feb 1820 d. 10 Aug 1892
- 12 Elizabeth Jane Sumner [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.1.1]
b. 4 Sep 1845 d. 23 Apr 1919 [ =>]
- 12 Elizabeth Jane Sumner [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.1.1]
- 11 James A Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.2]
b. 16 Apr 1834 d. 15 Sep 1914
Lavinia Merietta Cobb
- 12 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.2.1]
b. 1 Dec 1868 d. 28 Feb 1950
- 12 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.2.1]
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.3]
b. 1836
- 11 William Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.4]
b. 1837
- 11 Zilphia Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.5]
b. 1839
- 11 Elizabeth Jane Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6]
b. 30 Dec 1840 d. 2 Apr 1925
Berrien Walter Durden b. 7 Jun 1838 d. 17 Jun 1922
- 12 Willie Lorenzo Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.1]
b. 9 Apr 1860 d. 8 Feb 1945
- 12 Robert L. Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.2]
b. 11 Mar 1864 d. 23 Jun 1888
- 12 George Walton Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.3]
b. 7 Apr 1866 d. 16 May 1946
- 12 Mary Lillian Gray [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.4]
b. 25 Oct 1869 d. 25 Sep 1907
- 12 Ida Jane Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.5]
b. 1879 d. 15 Feb 1917
- 12 Maude McLemore [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.6]
b. 22 Jul 1884 d. 21 Apr 1969
- 12 Infant Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.7]
b. 23 Jun 1887 d. 28 Jun 1887
- 12 Floyd Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.8]
b. 30 Oct 1891 d. 5 Jan 1892
- 12 Willie Lorenzo Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.6.1]
- 11 July Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.7]
b. 1841
- 11 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.8]
b. 1843
- 11 America Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.9]
b. 1844
- 11 John Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.10]
b. 1847
- 11 Lucinda Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.3.1]
- 10 Zilphia Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.4]
b. 6 May 1813 d. 10 Jan 1893
- + John A Kemp b. 1793 d. 1859
- + John A Kemp b. 1793 d. 1859
- 10 William Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5]
b. 5 Dec 1815 d. 1 Sep 1885
Mary Kent b. 1826 d. 1855
- 11 Joshua W Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.1]
b. 17 Jun 1850 d. 19 Jan 1914
- + Mahala Durden b. 18 Apr 1851 d. 4 Apr 1892
Anna Thompson b. 11 Sep 1868 d. 22 Dec 1960
- 12 Jottye Edna Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.1.1]
b. 29 Mar 1899 d. 12 Apr 1984
- 12 Jottye Edna Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.1.1]
- + Mahala Durden b. 18 Apr 1851 d. 4 Apr 1892
- 11 Virginia Jincy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.2]
b. 1852
- 11 James Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.3]
b. 1854 d. 1922
Susan Lucinda Brinson b. 1859 d. 1928
- 12 Eker Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.3.1]
b. 10 Jul 1894 d. 3 Aug 1974
- 12 Eker Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.3.1]
- 11 Joshua W Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.1]
Caroline Dekle b. 11 Feb 1837 d. 18 Dec 1884
- 11 Ellen L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.4]
b. 29 Jul 1857 d. 28 Jan 1889
- + Solomon Parrish b. 7 Jul 1849 d. 26 Dec 1919
- + Solomon Parrish b. 7 Jul 1849 d. 26 Dec 1919
- 11 George R Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.5]
b. 20 Apr 1859 d. 16 Mar 1895
Saphronia Bennett b. 1855
- 12 George Marvin Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.5.1]
b. 30 Apr 1892 d. 22 Oct 1968 [ =>]
- 12 George Marvin Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.5.1]
- 11 Moselle L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.6]
b. 6 Jul 1860 d. 1 Jan 1914
- + Perry Algerine Trapnell b. 27 Feb 1856 d. 31 Oct 1907
- + Perry Algerine Trapnell b. 27 Feb 1856 d. 31 Oct 1907
- 11 Dr John Rodphus Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.7]
b. 22 Apr 1862 d. 2 Jun 1900
Annie Elizabeth Barwick b. 28 Nov 1872 d. 27 Apr 1962
- 12 Roy Lee Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.7.1]
b. 3 Dec 1893 d. 24 Jun 1992
- 12 Vera Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.7.2]
b. 30 Mar 1896
- 12 Zelma Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.7.3]
b. 18 Jan 1898 d. 12 Apr 1983
- 12 Roy Lee Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.7.1]
- 11 Dora Virginia Ann Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.8]
b. 25 Dec 1863 d. 24 Jul 1953
- 11 William Larenze Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.9]
b. 1865 d. 1872
- 11 Mary Dellia Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10]
b. 23 Mar 1867 d. 5 Jun 1936
John Gideon Trapnell b. 27 Apr 1863 d. 13 Jun 1918
- 12 Gertrude Bowen [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10.1]
b. 24 Nov 1889 d. 2 Aug 1982
- 12 Rufus Burnette Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10.2]
b. 14 Apr 1893 d. 3 Apr 1977
- 12 Frederick Lewis Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10.3]
b. 18 Oct 1894 d. 29 Aug 1981 [ =>]
- 12 Perry Lee Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10.4]
b. 10 Jan 1896 d. 21 Jan 1980
- 12 Frankie Rose [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10.5]
b. 25 Nov 1904 d. 5 Nov 1998
- 12 Gertrude Bowen [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.10.1]
- 11 Dr Alonzo Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.11]
b. 2 Jun 1869 d. 21 Jul 1936
Hattie Rogers b. 29 Aug 1878 d. 1 Feb 1975
- 12 John Rogers Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.11.1]
b. 1907 d. 2001
- 12 Wilbur Dekle Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.11.2]
b. 1910 d. 2002
- 12 Lottie Vickery Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.11.3]
b. 1914 d. 2006
- 12 John Rogers Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.11.1]
- 11 Carrie Emma Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12]
b. 23 Mar 1870 d. 25 Mar 1932
Joseph Addison Durden b. 22 Mar 1860 d. 5 Sep 1929
- 12 Bertha Irene Hart [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.1]
b. 24 Feb 1892 d. 19 May 1982
- 12 Rita Stevens [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.2]
b. 7 Nov 1893 d. 29 Sep 1977
- 12 Marie Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.3]
b. 3 Oct 1897 d. 31 Dec 1898
- 12 Rowie Vinson Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.4]
b. 8 Apr 1899 d. 10 Feb 1958
- 12 Joe A. Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.5]
b. 24 Jun 1903 d. 8 Jun 1990
- 12 Hoke Vernon Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.6]
b. 23 May 1905 d. 13 Feb 1968
- 12 Bertha Irene Hart [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.12.1]
- 11 Leon Dekle Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.13]
b. 28 Dec 1872 d. 22 Aug 1934
- 11 Fan Ida Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.14]
b. 1874 d. 1957
Burnett B Trapnell b. 9 Apr 1875 d. 8 Jan 1956
- 12 Elberta Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.14.1]
b. 1899
- 12 Claribel Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.14.2]
b. 27 Sep 1901 d. 29 Sep 1992
- 12 Leo Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.14.3]
b. 1907
- 12 Horace Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.14.4]
b. 1912
- 12 Elberta Trapnell [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.14.1]
- 11 Perry Lee Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.15]
b. 1876 d. 1925
- + Minnie Kennedy
- + Ella Trapnell b. 29 Sep 1877 d. 6 Aug 1977
- + Minnie Kennedy
- 11 Ellen L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.5.4]
- 10 Manning Randolph Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6]
b. 17 Jan 1818 d. 28 Dec 1893
Lucinda Durden b. 10 Nov 1818 d. 27 Jan 1891
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.1]
b. 19 Aug 1839
- + Leaston E Sutton b. 1842
- + Leaston E Sutton b. 1842
- 11 Mary Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.2]
b. 25 Jul 1841 d. 17 Feb 1898
Elder Hudson Temples b. 15 Mar 1843 d. 7 Apr 1922
- 12 Dent Rountree Temples [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.2.1]
b. 27 Apr 1887 d. 14 Jan 1965 [ =>]
- 12 Dent Rountree Temples [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.2.1]
- 11 Jane Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3]
b. 22 Jul 1843 d. 6 Nov 1922
George Ira Barwick b. 1 Apr 1843 d. 19 Dec 1898
- 12 Elder Robert Henry Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3.1]
b. 20 Sep 1866 d. 19 May 1945 [ =>]
- 12 Mary Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3.2]
b. 1869
- 12 Annie Elizabeth Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3.3]
b. 28 Nov 1872 d. 27 Apr 1962 [ =>]
- 12 Dora Lucinda Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3.4]
b. 16 May 1876 d. 11 Jan 1957 [ =>]
- 12 George Clayton Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3.5]
b. 12 Nov 1878 d. 3 Apr 1952
- 12 Elder Robert Henry Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.3.1]
- 11 John Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.4]
b. 28 May 1845 d. Bef 1850
- 11 Joshua Rudolph Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5]
b. 11 Sep 1847 d. 13 Dec 1911
Dora M Sumner b. 18 Dec 1853 d. 14 May 1894
- 12 Mary Anne Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.1]
b. 27 Dec 1872 d. 11 Apr 1955
- 12 William Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.2]
b. 9 Apr 1877 d. 27 Sep 1918 [ =>]
- 12 Amy Estelle Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.3]
b. 1878 d. 1949
- 12 Julian Rupert Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.4]
b. 1882 d. 1912
- 12 Lena Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.5]
b. Mar 1885
- 12 George Sumner Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.6]
b. May 1887 d. 1955
- 12 Joshua Clarke Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.7]
b. Nov 1890 d. 1972
- 12 Mary Anne Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.1]
Martha Mattie L Anderson b. 8 Jul 1868 d. 27 Feb 1950
- 12 Lucille Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.8]
b. 5 Jul 1896 d. 23 Jan 1971 [ =>]
- 12 Cecil Anderson Rountree, Sr [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.9]
b. 6 Jun 1897 d. 12 Dec 1967 [ =>]
- 12 John L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.10]
b. 25 Oct 1903 d. 16 May 2003 [ =>]
- 12 Martha E Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.11]
b. 1905 d. 1973
- 12 James Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.12]
b. 26 Feb 1911 d. 18 Mar 1980
- 12 Lucille Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.5.8]
- 11 Manning R Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.6]
b. 20 Sep 1849
- + Edgie Almond b. 2 Aug 1849 d. 1 Dec 1943
- + Edgie Almond b. 2 Aug 1849 d. 1 Dec 1943
- 11 Ebenezer Durden Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7]
b. 12 Nov 1851 d. 11 Aug 1919
Sally Youmans b. 23 Jul 1855 d. 27 Feb 1930
- 12 Felix Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7.1]
b. 16 Dec 1873 d. 24 Dec 1931 [ =>]
- 12 Henry Hudson Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7.2]
b. 1 Feb 1876 d. 24 Oct 1937
- 12 Robert E. Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7.3]
b. 6 Jul 1880 d. 8 Aug 1958
- 12 Grover C Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7.4]
b. 20 Jul 1884 d. 12 Jul 1885
- 12 Virgil Payne Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7.5]
b. 8 Feb 1886 d. 31 Jan 1958
- 12 Felix Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.7.1]
- 11 Andrew Jackson Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8]
b. 24 Dec 1853 d. 9 Apr 1912
Mary Ann Mozelle Coleman b. 20 Mar 1857 d. 9 Dec 1912
- 12 Jennie Dean Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.1]
b. 1877 d. 1953
- 12 Charles Ross Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.2]
b. 29 Mar 1879 d. 20 May 1950 [ =>]
- 12 Neil G Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.3]
b. 21 Oct 1880 d. 17 Nov 1894
- 12 Ralph L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.4]
b. 19 Dec 1883 d. 27 Dec 1934
- 12 Manning R Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.5]
b. 12 Jan 1886 d. 1 Jan 1964
- 12 Jesse Lewis Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.6]
b. 2 Jan 1888 d. 6 Jan 1959 [ =>]
- 12 John Plunkett Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.7]
b. 15 Jun 1890 d. 1960 [ =>]
- 12 Ethel Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.8]
b. 16 Oct 1892
- 12 Ollie Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.9]
b. 3 Aug 1894 d. 1 Jul 1958
- 12 J Rex Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.10]
b. 25 Jul 1897 [ =>]
- 12 Lee Turner Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.11]
b. 20 Apr 1900 d. 23 Apr 1970
- 12 Jennie Dean Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.8.1]
- 11 Isaac Norris Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.9]
b. 21 Dec 1855 d. 4 Apr 1933
Emma Daughtry b. Abt 1856
- 12 Annie Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.9.1]
b. May 1885
- 12 Fannie Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.9.2]
b. Jan 1887
- 12 Walter Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.9.3]
b. Jan 1888
- 12 Ruth M Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.9.4]
b. 1893
- 12 Annie Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.9.1]
- + Leonora L Almond b. 21 Oct 1860 d. 10 Jan 1954
- 11 George Washington Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.10]
b. 25 Apr 1858
- 11 Joseph B Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.11]
b. 5 Jan 1861
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.6.1]
- 10 Eady Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.7]
b. 1820 d. 29 Mar 1860
James Anderson b. 1817 d. Aug 1880
- 11 Roxanna Belle Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.1.7.1]
b. 1854 d. 1889
William P Matthews b. 1843 d. 1927
- 12 Joe Matthews [1.1.1.1.3.7.5.6.1.7.1.1]
b. 1881 d. 1938 [ =>]
- 12 Joe Matthews [1.1.1.1.3.7.5.6.1.7.1.1]
- 11 Roxanna Belle Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.1.7.1]
- 10 Roxanne Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8]
b. 1829 d. 1871
Ebenezer Jenkins Durden b. 7 Sep 1826 d. 26 Apr 1914
- 11 Mary Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.1]
b. 23 Sep 1847 d. 20 Mar 1919
- + Hendricks b. Abt 1846
- + Hendricks b. Abt 1846
- 11 Mahala Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.2]
b. 18 Apr 1851 d. 4 Apr 1892
- + Joshua W Rountree b. 17 Jun 1850 d. 19 Jan 1914
- + Joshua W Rountree b. 17 Jun 1850 d. 19 Jan 1914
- 11 William Rountree Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.3]
b. 20 Mar 1854 d. 3 Jun 1889
- 11 James A Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.4]
b. 26 Mar 1855 d. 6 Oct 1946
- 11 Ebenezer Pinkney Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.5]
b. 29 Jun 1857 d. 19 Jun 1943
- 11 Sarah Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.6]
b. 1859 d. 10 Nov 1933
- + Dixon b. Abt 1858
- + Dixon b. Abt 1858
- 11 Eleazar Lindsay Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.7]
b. 12 Aug 1862 d. 10 Apr 1945
Marie Antoinette Hendrix b. 1 Feb 1866 d. 23 Jul 1961
- 12 Glen E Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.7.1]
b. 21 Aug 1887 d. 22 Nov 1941
- 12 Siddie Maude Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.7.2]
b. 14 Dec 1888 d. 29 Jan 1973 [ =>]
- 12 Edward A Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.7.3]
b. 1894 d. 1964
- 12 John Apling Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.7.4]
b. 6 Nov 1897 d. 16 Oct 1972
- 12 Glen E Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.7.1]
- 11 Roxie Elizabeth Betty Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.8]
b. 27 Sep 1864 d. 4 Sep 1939
John A Sconyers b. 1859 d. 1919
- 12 Lula Sconyers [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.8.1]
b. 11 Oct 1890 d. 29 Apr 1960 [ =>]
- 12 Lula Sconyers [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.8.1]
- 11 Lula Gennett Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.9]
b. 11 Mar 1867 d. 10 Sep 1927
- + Nichols b. Abt 1866
- + Nichols b. Abt 1866
- 11 John Eason Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.10]
b. 12 Aug 1870 d. 30 Nov 1922
- 11 Mary Durden [1.1.1.1.3.7.5.6.1.8.1]
- 10 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1.1]
- 9 George Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2]
b. 1783 d. 1856
Lavinia Mae Neal b. 1785 d. 1856
- 10 Elizabeth Betsy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1]
b. 18 Jan 1816 d. 17 Apr 1875
Lott Barwick b. 6 Apr 1813 d. 25 May 1894
- 11 George Ira Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1]
b. 1 Apr 1843 d. 19 Dec 1898
Jane Rountree b. 22 Jul 1843 d. 6 Nov 1922
- 12 Elder Robert Henry Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1.1]
b. 20 Sep 1866 d. 19 May 1945 [ =>]
- 12 Mary Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1.2]
b. 1869
- 12 Annie Elizabeth Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1.3]
b. 28 Nov 1872 d. 27 Apr 1962 [ =>]
- 12 Dora Lucinda Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1.4]
b. 16 May 1876 d. 11 Jan 1957 [ =>]
- 12 George Clayton Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1.5]
b. 12 Nov 1878 d. 3 Apr 1952
- 12 Elder Robert Henry Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1.1]
- 11 Lott Lee Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.2]
b. 21 Feb 1848 d. May 1900
Georgeanne Overstreet b. 1850 d. 1880
- 12 Bettie Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.2.1]
b. 16 Aug 1875 d. 1 Mar 1957 [ =>]
- 12 Bettie Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.2.1]
- 11 George Ira Barwick [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1.1]
- 10 Allen Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.2]
b. 26 Dec 1819 d. 16 May 1896
Elizabeth Mahalia Burnet b. 5 Mar 1829 d. 10 Feb 1908
- 11 George Ismay Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.2.1]
b. 12 Jun 1851 d. 11 Jun 1930
Mary Frances Turner b. 1858 d. 1898
- 12 Dent Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.2.1.1]
b. 19 Mar 1888 d. 25 Feb 1982
- 12 John Allen Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.2.1.2]
b. 6 Mar 1893 d. 29 Oct 1957 [ =>]
- 12 Dent Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.2.1.1]
- + Mary Ann Jones b. Abt 1852
- 11 George Ismay Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.2.1]
- 10 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3]
b. 18 May 1822
William N Sumner b. 14 Mar 1817 d. 23 Feb 1883
- 11 Dora M Sumner [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1]
b. 18 Dec 1853 d. 14 May 1894
Joshua Rudolph Rountree b. 11 Sep 1847 d. 13 Dec 1911
- 12 Mary Anne Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.1]
b. 27 Dec 1872 d. 11 Apr 1955
- 12 William Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.2]
b. 9 Apr 1877 d. 27 Sep 1918 [ =>]
- 12 Amy Estelle Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.3]
b. 1878 d. 1949
- 12 Julian Rupert Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.4]
b. 1882 d. 1912
- 12 Lena Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.5]
b. Mar 1885
- 12 George Sumner Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.6]
b. May 1887 d. 1955
- 12 Joshua Clarke Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.7]
b. Nov 1890 d. 1972
- 12 Mary Anne Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1.1]
- 11 Dora M Sumner [1.1.1.1.3.7.5.6.2.3.1]
- 10 Sallie Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.4]
b. 19 Jan 1823
- 10 John Mack Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5]
b. 1829
Elizabeth Coward b. 1833
- 11 Augustus Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5.1]
b. 1850
- 11 George G Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5.2]
b. 1852
- 11 Oliver P Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5.3]
b. 1855
- 11 Mary Ann Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5.4]
b. 1857
- 11 Joseph Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5.5]
b. 1859
- 11 Augustus Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.5.1]
- 10 Jane Pheraba Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.6]
b. 1829 d. 1905
- 10 George Smiley Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.7]
b. 1831 d. 1903
Milly Ann Rebecca Renfro b. 1836
- 11 Madison N Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.7.1]
b. 1853
- 11 Winford S Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.7.2]
b. 1856
- 11 George L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.7.3]
b. 1860
- 11 Madison N Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.7.1]
- 10 Merida Mendes Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.8]
b. 1833 d. 5 Feb 1865
- 10 Doriann Lavinia Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.9]
b. 27 Jul 1836 d. 4 Jan 1907
- + Dr Benjamin Darius Smith b. 1831
- + Dr Benjamin Darius Smith b. 1831
- 10 William Perry Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10]
b. 25 Apr 1839 d. 28 Jul 1925
Laura A Coleman b. Jan 1850
- 11 Gertrude Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.1]
b. 13 Nov 1870 d. 26 Aug 1963
- + John Henry Medlock b. 30 Sep 1872 d. 8 Mar 1932
- + John Henry Medlock b. 30 Sep 1872 d. 8 Mar 1932
- 11 Dr Walter Hodges Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.2]
b. 1873 d. 1 Jan 1951
Bell Goethe b. 1880
- 12 George Perry Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.2.1]
b. 18 Mar 1901 d. 27 Nov 1956 [ =>]
- 12 Laura Annie Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.2.2]
b. 22 Feb 1905 d. 3 Dec 1980
- 12 John Ellis Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.2.3]
b. 16 Jan 1911 d. 22 Nov 1985
- 12 Living [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.2.4]
- 12 George Perry Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.2.1]
- 11 Alice Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.3]
b. 12 May 1874 d. 16 Sep 1956
James Ira Anderson b. 20 Jan 1871 d. 3 May 1957
- 12 Vera Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.3.1]
b. 14 Aug 1896 d. 1 Mar 1968 [ =>]
- 12 Vera Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.3.1]
- 11 Robert Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.4]
b. 1877
- 11 Cora Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.5]
b. Mar 1878
- 11 Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.6]
b. 1879
- 11 Wade Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.7]
b. 8 Jul 1880 d. 17 Nov 1913
- + Lottie Whiddon Barwick b. 1884 d. 1911
- + Lottie Whiddon Barwick b. 1884 d. 1911
- 11 Emma Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.8]
b. Aug 1882
- 11 Maud Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.9]
b. Aug 1886
- 11 Roy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.10]
b. Jul 1892
- 11 Gertrude Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.10.1]
- 10 Madison Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.11]
b. 1842
- 10 Elizabeth Betsy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.2.1]
- 9 Jerusha Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.3]
b. 1785 d. 1853
John Ellis b. 1770 d. Bef 1840
- 10 Jerusha Ellis [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1]
b. 1819 d. Bef 1900
Owen S Morey b. 1813 d. Bef 1850
- 11 Owen S Morey [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1.1]
b. 1846 d. 1929
Eliza McDonald Mizell b. 25 Dec 1853 d. 4 Jun 1934
- 12 Custus Veracruz Morey [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1.1.1]
b. 26 Oct 1879 d. 26 Oct 1962
- 12 Lawrence Jackson Morey [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1.1.2]
b. 12 Oct 1882 d. 24 Nov 1931 [ =>]
- 12 Custus Veracruz Morey [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1.1.1]
- 11 Owen S Morey [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1.1]
- 10 Jerusha Ellis [1.1.1.1.3.7.5.6.3.1]
- 9 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4]
b. 7 May 1785 d. 4 May 1856
George Dekle b. 30 May 1781 d. 10 May 1846
- 10 Sarah Sallie Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1]
b. 3 Nov 1803 d. 6 Nov 1874
Elijah Leonidas Neel b. 15 Mar 1802 d. 10 Jul 1889
- 11 Roxie Ann Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1]
b. 16 Nov 1823 d. 14 Mar 1901
George Austin Dekle b. 1820
- 12 Palestine Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1.1]
b. 12 Aug 1844 d. 23 Nov 1871
- 12 Sarah Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1.2]
b. 8 Jan 1846 d. 17 Dec 1895
- 12 Elijah Neel Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1.3]
b. 1847 d. 1930 [ =>]
- 12 Green Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1.4]
b. 1849
- 12 Palestine Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1.1]
- 11 Matilda Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.2]
b. Abt 1824 d. Died Young
- 11 Elizabeth Betsy Ann Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3]
b. 4 Apr 1825 d. 1 Apr 1893
Elder William Allison Dekle b. 2 Jun 1822 d. 3 May 1879
- 12 Eli Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.1]
b. 1843 d. 1862
- 12 Sgt George W Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.2]
b. 1845 d. 10 Apr 1864
- 12 Matilda Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.3]
b. 1847
- 12 Elder Neel Jalape Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.4]
b. 1849 d. 1904 [ =>]
- 12 Sarah Ann Dicey Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.5]
b. 9 May 1850 d. 17 Feb 1935 [ =>]
- 12 William Wisconsin Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.6]
b. 24 Sep 1852 d. 23 Mar 1939 [ =>]
- 12 Austin Rudolph Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.7]
b. 21 Oct 1854 d. 14 Oct 1937 [ =>]
- 12 Lizzie Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.8]
b. 1857 d. Died Young
- 12 Mary Lusina Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.9]
b. 1858 d. 11 Jan 1901 [ =>]
- 12 Ella Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.10]
b. 1861
- 12 Emma Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.11]
b. 1866
- 12 Eli Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.3.1]
- 11 Eleanor Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.4]
b. 25 Nov 1826 d. 3 May 1850
Dr Manning Benjamin Franklin Neel b. 21 Jan 1818 d. 19 Feb 1914
- 12 Infant Child Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.4.1]
b. 6 Apr 1850 d. 6 Apr 1850
- 12 Infant Child Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.4.1]
- 11 Missouri Ann Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5]
b. 5 Aug 1828 d. 11 Dec 1911
William Timmons Connell b. 16 Dec 1824 d. 1890
- 12 James Thomas Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.1]
b. 1849
- 12 Ann Jane Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.2]
b. 15 Mar 1850
- 12 William Joseph Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.3]
b. 1853
- 12 Sarah A Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.4]
b. 1855
- 12 Mary Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.5]
b. 1857
- 12 Eula Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.6]
b. 1860
- 12 Elijah N Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.7]
b. 1865
- 12 John Timmons Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.8]
b. 1866
- 12 Ada Ann Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.9]
b. 1868
- 12 Hugh Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.10]
b. 1869
- 12 James Thomas Connell [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.5.1]
- 11 George Madison Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.6]
b. 5 Apr 1830
- 11 Lodusky Louise Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.7]
b. 5 Nov 1831 d. 8 Aug 1910
Dr Manning Benjamin Franklin Neel b. 21 Jan 1818 d. 19 Feb 1914
- 12 Claud Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.7.1]
d. Died Young
- 12 Joseph Pascal Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.7.2]
b. 24 Dec 1856 d. 18 Jul 1932 [ =>]
- 12 Claud Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.7.1]
- 11 Sarah Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.8]
b. 25 Sep 1833 d. Died Young
- 11 Sidney Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.9]
b. 26 May 1835 d. Died Young
- 11 Theresa Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.10]
b. 28 Oct 1836 d. Died Young
- 11 Lucina Mary Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.11]
b. 1 Feb 1839 d. 11 Oct 1889
John Riley
- 12 Albert Aurelius Riley [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.11.1]
- 12 Albert Aurelius Riley [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.11.1]
- 11 Samantha Amanda Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.12]
b. 2 Nov 1840 d. 23 Jan 1918
- 11 John Cicero Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.13]
b. 21 Jan 1845 d. 16 Mar 1910
- + Susan Braswell b. 24 Jan 1847 d. 19 Aug 1874
- + Martha Rebecca Bryan b. 20 Dec 1852 d. 7 Apr 1930
- + Susan Braswell b. 24 Jan 1847 d. 19 Aug 1874
- 11 Leonidas Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.14]
b. 1846
- 11 Roxie Ann Neel [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1.1]
- 10 Grissom Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.2]
b. 17 Feb 1806 d. 1833
- 10 William Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.3]
b. 1808
- 10 Littleton Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4]
b. 7 Jul 1811 d. 1870
Susan Warren b. 1810 d. 1900
- 11 Mary Polly Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1]
b. 1832
Jesse Holland Brown b. 1827 d. Bef 1870
- 12 Susanna Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.1]
b. 1850 d. Bef 1860
- 12 Victoria Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.2]
b. Jan 1852 d. 1905 [ =>]
- 12 Jasper Washington Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.3]
b. 1855
- 12 Gideon Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.4]
b. 1856
- 12 George Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.5]
b. 1860
- 12 Rosalee Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.6]
b. 1863
- 12 Susanna Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1.1]
- 11 Elender A Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2]
b. 30 Jul 1834 d. 3 Dec 1907
Jordan Jesse Sutton b. 1834 d. 3 Jul 1863
- 12 Caroline Naomi Sutton [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.1]
b. 1856
- 12 Littleton Sutton [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.2]
b. 30 Mar 1858
- 12 Susan Onelia Sutton [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.3]
b. 8 Mar 1859 d. 2 Oct 1935 [ =>]
- 12 Ann Jane Sutton [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.4]
b. 1862
- 12 Caroline Naomi Sutton [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.1]
Elder Swain Marsh Anderson b. 24 Oct 1846 d. 17 Mar 1923
- 12 Florence Ellen Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.5]
b. 23 Sep 1866 d. 18 Mar 1912 [ =>]
- 12 Martha Mattie L Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.6]
b. 8 Jul 1868 d. 27 Feb 1950 [ =>]
- 12 James Ira Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.7]
b. 20 Jan 1871 d. 3 May 1957 [ =>]
- 12 Joseph H Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.8]
b. 5 May 1875 d. 4 Mar 1919
- 12 Florence Ellen Anderson [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.2.5]
- 11 Jane Lois Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.3]
b. 20 Sep 1835 d. 12 Dec 1921
- + Elias Mad Holland b. 1827 d. 1880
- + William Calvin Sutton b. 1833 d. 15 Aug 1862
- + Elias Mad Holland b. 1827 d. 1880
- 11 Caroline Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4]
b. 11 Feb 1837 d. 18 Dec 1884
William Rountree b. 5 Dec 1815 d. 1 Sep 1885
- 12 Ellen L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.1]
b. 29 Jul 1857 d. 28 Jan 1889
- 12 George R Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.2]
b. 20 Apr 1859 d. 16 Mar 1895 [ =>]
- 12 Moselle L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.3]
b. 6 Jul 1860 d. 1 Jan 1914
- 12 Dr John Rodphus Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.4]
b. 22 Apr 1862 d. 2 Jun 1900 [ =>]
- 12 Dora Virginia Ann Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.5]
b. 25 Dec 1863 d. 24 Jul 1953
- 12 William Larenze Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.6]
b. 1865 d. 1872
- 12 Mary Dellia Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.7]
b. 23 Mar 1867 d. 5 Jun 1936 [ =>]
- 12 Dr Alonzo Manning Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.8]
b. 2 Jun 1869 d. 21 Jul 1936 [ =>]
- 12 Carrie Emma Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.9]
b. 23 Mar 1870 d. 25 Mar 1932 [ =>]
- 12 Leon Dekle Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.10]
b. 28 Dec 1872 d. 22 Aug 1934
- 12 Fan Ida Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.11]
b. 1874 d. 1957 [ =>]
- 12 Perry Lee Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.12]
b. 1876 d. 1925
- 12 Ellen L Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.4.1]
- 11 George Washington Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5]
b. 6 Mar 1838 d. 16 Apr 1898
Susan Lanier b. 11 Feb 1840 d. 30 Mar 1913
- 12 John L Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.1]
b. 7 Sep 1868 d. 4 Oct 1919 [ =>]
- 12 George Littleton Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.2]
b. 8 Dec 1869 d. 3 Dec 1932
- 12 William M. Dekle, Sr [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.3]
b. 26 Apr 1872 d. 5 Jun 1922
- 12 Robert Lee Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.4]
b. 1 Apr 1874 d. 18 Mar 1953
- 12 Emma Mozelle Brown [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.5]
b. 10 Jun 1876 d. 22 Aug 1926
- 12 James Ivy Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.6]
b. 7 Apr 1878 d. 6 Nov 1957
- 12 Mollie Fordham [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.7]
b. 18 Aug 1880 d. 28 Sep 1957
- 12 John L Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.5.1]
- 11 Susan Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 24 Oct 1907
William Walter Jones b. 22 Oct 1838 d. 2 Jun 1899
- 12 Millard Fillmore Jones [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.6.1]
b. 25 Jul 1878 d. 3 Apr 1955
- 12 Susan Ida Jones [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.6.2]
b. 5 May 1881 d. 4 Jan 1919
- 12 James Doyle Jones, Sr [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.6.3]
b. 23 Apr 1883 d. 17 Mar 1955
- 12 Millard Fillmore Jones [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.6.1]
- 11 Martha Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7]
b. 1841
Richard Kirkland b. 1846
- 12 Rass Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.1]
b. 1868
- 12 Iva Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.2]
b. 1869
- 12 Ella Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.3]
b. 1870
- 12 Randolph Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.4]
b. 1872
- 12 Trew Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.5]
b. 1874
- 12 Palmer Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.6]
b. 1875
- 12 Stella Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.7]
b. 1876
- 12 Deppish Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.8]
b. 1877
- 12 John Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.9]
b. Sep 1879
- 12 Belle Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.10]
b. 1883 d. 1934 [ =>]
- 12 Rass Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.7.1]
- 11 Tiercy Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.8]
b. 1842
- 11 Nancy Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.9]
b. 1844
- 11 Canvasy Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.10]
b. 1847
- 11 Dora Ann Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.11]
b. 17 Jan 1853 d. 1899
Parrish b. Abt 1850
- 12 Maxie Parrish [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.11.1]
[ =>]
- 12 Maxie Parrish [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.11.1]
- 11 Mary Polly Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.4.1]
- 10 Minton Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.5]
b. 1813 d. 1903
- 10 Eleanor Ellen Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.6]
b. 1815 d. 1876
Aurin Goodgame Horn b. 19 May 1793 d. 9 Aug 1857
- 11 Eli H Horn [1.1.1.1.3.7.5.6.4.6.1]
b. 1851 d. 1931
Roxie Ann R Knight b. 1857 d. 1940
- 12 Pearlie Horn [1.1.1.1.3.7.5.6.4.6.1.1]
b. 1883 d. 1936 [ =>]
- 12 Pearlie Horn [1.1.1.1.3.7.5.6.4.6.1.1]
- 11 Eli H Horn [1.1.1.1.3.7.5.6.4.6.1]
- 10 Thomas Cummings Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.7]
b. 1817 d. 1860
- 10 Cynthia Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.8]
b. 1819 d. 1848
- 10 John Morgan Squuire Dekle, Sr [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9]
b. 18 Feb 1821 d. 11 Aug 1896
Mary Mercer b. 9 Oct 1830 d. 10 Apr 1875
- 11 Julia V Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1]
b. 18 Mar 1849 d. 2 Oct 1926
William Alfred Kirkland b. 20 Nov 1850 d. 22 Apr 1903
- 12 Alice Florence Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.1]
b. 17 Nov 1867 d. 5 Apr 1954 [ =>]
- 12 Georgia Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.2]
b. 1870
- 12 Dawson Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.3]
b. 1874
- 12 Ann Florence Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.4]
b. 1876
- 12 Mikiel Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.5]
b. 1877
- 12 Jincy Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.6]
b. 1878
- 12 Minney Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.7]
b. 1879
- 12 John Dekle Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.8]
b. 27 Mar 1880 d. 30 Oct 1945
- 12 Holley Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.9]
b. Mar 1884
- 12 Alice Florence Kirkland [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1.1]
- 11 George Mack Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.2]
b. 17 Aug 1851 d. 14 May 1907
Mayne Cynthia Moore b. 1869 d. 26 Dec 1942
- 12 Cecil Carlisle Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.2.1]
b. 13 Nov 1892 d. 26 Mar 1976 [ =>]
- 12 Cecil Carlisle Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.2.1]
- 11 Jennie Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.3]
b. 31 Mar 1856 d. 17 Mar 1926
- + Everett b. Abt 1855
- + Everett b. Abt 1855
- 11 Elder Penner Remer Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4]
b. 9 Feb 1858 d. 13 Jan 1903
Mary Jane Bowen b. 27 Nov 1858 d. 25 Nov 1943
- 12 Leroy R Deakle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.1]
b. Jun 1879
- 12 Laura Pearl Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.2]
b. 14 May 1882 d. 3 Jul 1978 [ =>]
- 12 George Adam Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.3]
b. 23 Jun 1884 d. 29 Apr 1970
- 12 John Harvey Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.4]
b. 19 Sep 1888 d. 24 May 1971 [ =>]
- 12 Silas M Deakle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.5]
b. May 1890
- 12 Remer G Deakle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.6]
b. Jun 1892
- 12 Mary E Deakle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.7]
b. Aug 1898
- 12 Leroy R Deakle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.4.1]
- 11 Mitchell Sanford Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5]
b. 14 Oct 1860 d. 28 Feb 1928
Beulah M Lee b. 23 Nov 1865 d. 29 Jan 1937
- 12 Grover Clyde Dekle, Sr [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.1]
b. 25 Dec 1884 d. 6 Sep 1944 [ =>]
- 12 Lesley L Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.2]
b. Jun 1886 d. 5 Jun 1929
- 12 Ivey Huland Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.3]
b. 23 Jun 1887 d. 11 Jun 1944 [ =>]
- 12 Mandie Mabel Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.4]
b. Mar 1890
- 12 Eva Roxy Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.5]
b. Feb 1892
- 12 James Paul Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.6]
b. 18 Dec 1893 d. 21 Mar 1944 [ =>]
- 12 Seth L Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.7]
b. Aug 1895
- 12 Beulah Mary Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.8]
b. 14 Sep 1896 d. 21 Sep 1959 [ =>]
- 12 Henry Clyde Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.9]
b. 14 Mar 1902 d. 10 Feb 1907
- 12 John Edwin Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.10]
b. 30 Sep 1905
- 12 Grover Clyde Dekle, Sr [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.5.1]
- 11 John Morgan Dekle, Jr [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.6]
b. 16 Apr 1863 d. 3 Mar 1916
- 11 Laura Williams [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.7]
b. 17 Dec 1864 d. 8 Apr 1951
- 11 Ida M Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.8]
b. 2 Jun 1867 d. 24 Feb 1935
- + J Edward Collins b. Abt 1866
- + Mills
- + J Edward Collins b. Abt 1866
- 11 Tallulah Satirah Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.9]
b. 22 Mar 1870 d. 11 Oct 1959
- + Leon Jackson Trapnell b. 1865 d. 1938
- + Leon Jackson Trapnell b. 1865 d. 1938
- 11 Mary Anna Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.10]
b. 8 Feb 1872 d. 12 Feb 1956
- + James Rufus Lee b. Abt 1871
- + James Rufus Lee b. Abt 1871
- 11 Julia V Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.9.1]
- 10 Nancy Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.10]
b. 1825 d. 1909
- 10 Theresa Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.11]
b. 1826
- 10 Sarah Sallie Dekle [1.1.1.1.3.7.5.6.4.1]
- 9 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.5]
b. 1794 d. 1851
- 9 Joshua Rountree [1.1.1.1.3.7.5.6.1]
- 8 Jesse Rountree, Jr [1.1.1.1.3.7.5.1]
- 7 Mary Rebecca Rountree [1.1.1.1.3.7.1]
- 6 Thomas Rountree, Sr [1.1.1.1.3.8]
b. Abt 1676 d. 18 Dec 1748
Elizabeth Sumner b. 1685 d. 1764
- 7 Joan Rountree [1.1.1.1.3.8.1]
- 7 Francis Rountree [1.1.1.1.3.8.2]
- 7 Susannah Rountree [1.1.1.1.3.8.3]
- 7 John Rountree [1.1.1.1.3.8.4]
- 7 Ann Rountree [1.1.1.1.3.8.5]
b. 1691 d. 27 Nov 1778
- 7 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.8.6]
b. Abt 1699 d. 1778
Elias Stallings, I b. 1683 d. Dec 1784
- 8 Kader Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1]
b. 1721 d. 1817
- 9 Green Berry Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.1]
b. Abt 1750
- 9 James Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.2]
b. Abt 1751
- 9 Lynnea Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.3]
b. Abt 1752
- 9 Moses Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.4]
b. Abt 1753
- 9 William Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.5]
b. Abt 1754
- 9 Wilson Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.6]
b. Abt 1755
- 9 Green Berry Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1.1]
- 8 Elias Stallings, II [1.1.1.1.3.8.6.2]
b. 1729 d. 24 Sep 1794
Nancy Ann Riddick b. Abt 1730 d. Aft 28 Nov 1800
- 9 Hardy Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1]
b. 1755 d. 1821
Hepzibah Perry b. 1737 d. 1813
- 10 Jesse Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1]
b. 1775 d. 1855
Lydia Bennett b. 1772 d. 1855
- 11 Humphrey Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1]
b. 24 Oct 1801 d. 1848
Cynthia Robertson b. 7 Apr 1805 d. 8 Feb 1889
- 12 John Alfred Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.1]
b. 3 May 1826 d. 12 Sep 1882 [ =>]
- 12 Sarah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.2]
b. 1828
- 12 Bryant Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.3]
b. 1829 d. 1898
- 12 Edwin Grey Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.4]
b. 11 Jun 1832 d. 30 Jan 1878
- 12 William Bryant Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.5]
b. 15 Jun 1834 d. 6 Sep 1872
- 12 Lott M Gilbert Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.6]
b. 30 Jul 1838 d. 5 Feb 1901
- 12 Lydia Ann Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.7]
b. 1840 d. 1913
- 12 John Alfred Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1.1]
- 11 Humphrey Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1.1]
- 10 Jesse Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1.1]
- 9 Delilah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.2]
b. 1762 d. Aft 16 Mar 1824
Stephen Williams b. 9 May 1760 d. 8 Apr 1839
- 10 Richard Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1]
b. 22 Jul 1780 d. 28 Mar 1877
Nancy Strother b. 1 Mar 1794 d. 5 Apr 1878
- 11 Francis Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.1]
b. 1814 d. 1847
- 11 Henry Hall Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.2]
b. 11 Feb 1819 d. 15 Nov 1901
- 11 Nancy Jane Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3]
b. 2 Mar 1825 d. 27 Oct 1888
Henry Hall Womack b. 11 Sep 1812 d. 16 Oct 1903
- 12 Stephen Henry Womack [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3.1]
b. 15 Mar 1847 d. 20 Dec 1918
- 12 David Crockett Womack [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3.2]
b. 16 Dec 1852 d. 16 Dec 1937
- 12 William Balas Womack [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3.3]
b. 24 Dec 1854 d. 10 Aug 1940
- 12 Franklin Cary Womack [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3.4]
b. 10 May 1860 d. 21 Dec 1932
- 12 Martha Miriam Womack [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3.5]
b. 23 Dec 1862 d. 22 Jan 1941 [ =>]
- 12 Stephen Henry Womack [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.3.1]
- 11 Mariah L Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.4]
b. 26 Oct 1829 d. 6 Jan 1887
- + Newsom b. Abt 1828
- + Newsom b. Abt 1828
- 11 Eliza Jane Glenn Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.5]
b. 1835 d. 1880
- + Ratcliff b. Abt 1834
- + Ratcliff b. Abt 1834
- 11 Francis Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1.1]
- 10 Richard Williams [1.1.1.1.3.8.6.2.2.1]
- 9 Hardy Stallings [1.1.1.1.3.8.6.2.1]
- 8 Richard Stallings [1.1.1.1.3.8.6.3]
b. Abt 1730
- 8 John Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4]
b. 1731 d. 1818
Priscilla _____ b. Abt 1750 d. 1821
- 9 Jesse Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4.1]
b. 1787
- 9 Selah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4.2]
b. Abt 1788
- 9 Joseph Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4.3]
b. 1790
- 9 Elizabeth Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4.4]
b. 1791
- 9 Priscilla Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4.5]
b. 1800
- 9 Jesse Stallings [1.1.1.1.3.8.6.4.1]
- 8 Luke Stallings [1.1.1.1.3.8.6.5]
b. 1732 d. 1799
- 9 Ruthey Stallings [1.1.1.1.3.8.6.5.1]
b. Abt 1750 d. 1853
John Morgan b. 1750 d. 1837
- 10 Celia Morgan [1.1.1.1.3.8.6.5.1.1]
b. 1785 d. 1852
Hutchens Ferrell b. 1787 d. 1841
- 11 Charity Ferrell [1.1.1.1.3.8.6.5.1.1.1]
b. 1808 d. 1888
Gaybird Coleman b. Abt 1808
- 12 Olivia Ann Coleman [1.1.1.1.3.8.6.5.1.1.1.1]
b. 1839 d. 1926 [ =>]
- 12 Olivia Ann Coleman [1.1.1.1.3.8.6.5.1.1.1.1]
- 11 Charity Ferrell [1.1.1.1.3.8.6.5.1.1.1]
- 10 Celia Morgan [1.1.1.1.3.8.6.5.1.1]
- 9 Ruthey Stallings [1.1.1.1.3.8.6.5.1]
- 8 Elizabeth Stallings [1.1.1.1.3.8.6.6]
b. Abt 1732
- + Webb b. Abt 1731
- + Webb b. Abt 1731
- 8 Reuben Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7]
b. Abt 1733 d. 1825
Abselah Wilson b. Abt 1755
- 9 Noah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.1]
b. 1784 d. 17 Mar 1864
Leah Forehand b. 1792 d. 1865
- 10 Leah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.1.1]
b. 1823 d. 1915
- + James M Stallings b. 1821 d. 1881
- + James M Stallings b. 1821 d. 1881
- 10 Leah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.1.1]
- 9 Kader Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.2]
b. Abt 1785
- 9 Elisha Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.3]
b. Abt 1787
- 9 Willis Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.4]
b. Abt 1789
- 9 Abselah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.5]
b. 1790 d. 12 Mar 1874
Dempsey Twine b. 1794
- 10 James Twine [1.1.1.1.3.8.6.7.5.1]
b. 1835
- 10 James Twine [1.1.1.1.3.8.6.7.5.1]
- 9 Mills Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.6]
b. 1791 d. 1840
- 9 Christian Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.7]
b. 1791
- 9 Zilla Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.8]
b. Abt 1793
- 9 Lydia Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.9]
b. 1795
- 9 Noah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.7.1]
- 8 Solomon Stallings [1.1.1.1.3.8.6.8]
b. Abt 1736
- 8 Mary Stallings [1.1.1.1.3.8.6.9]
b. Abt 1738
- + Colley b. Abt 1737
- + Colley b. Abt 1737
- 8 Priscilla Stallings [1.1.1.1.3.8.6.10]
b. 1740 d. Aft 1785
- 9 Rhoda _____ [1.1.1.1.3.8.6.10.1]
b. Abt 1775
- 9 Rhoda _____ [1.1.1.1.3.8.6.10.1]
- 8 Palasiah Stallings, Sr [1.1.1.1.3.8.6.11]
b. Abt 1741 d. 14 May 1772
- 9 Palasiah Stallings, Jr [1.1.1.1.3.8.6.11.1]
b. 1763
- + Mary Polly Edwards b. Abt 1764
- + Mary Polly Edwards b. Abt 1764
- 9 Palasiah Stallings, Jr [1.1.1.1.3.8.6.11.1]
- 8 Penneniah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.12]
b. 1742 d. Bef 1785
- + John Hudson b. Abt 1741
- + John Hudson b. Abt 1741
- 8 Jesse Stallings [1.1.1.1.3.8.6.13]
b. 1745 d. 1810
- + Eliza Pittman b. Abt 1746
- + Eliza Pittman b. Abt 1746
- 8 Sarah Charity Stallings [1.1.1.1.3.8.6.14]
b. 1745 d. 1810
Jarvis Forehand b. 1745 d. 1788
- 9 John Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.1]
b. 1767 d. 1837
- 9 Thomas Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2]
b. 1780 d. 1844
Juda Asbill b. 1781 d. 1823
- 10 Thomas Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2.1]
b. 1804
Penina Bunch b. 1814 d. 1878
- 11 William James Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2.1.1]
b. 1843 d. 1901
Margaret Jane Byrum b. 1840 d. 1910
- 12 William Warren Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2.1.1.1]
b. 1872 d. 1933 [ =>]
- 12 William Warren Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2.1.1.1]
- 11 William James Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2.1.1]
- 10 Thomas Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.2.1]
- 9 John Forehand [1.1.1.1.3.8.6.14.1]
- 8 Zilpha Stallings [1.1.1.1.3.8.6.15]
b. Abt 1748 d. 29 Apr 1796
- + John Lee b. Abt 1748 d. 1836
- + John Lee b. Abt 1748 d. 1836
- 8 Job Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16]
b. 1750 d. 31 Aug 1807
Mary Alston b. 5 Dec 1748 d. 1840
- 9 Josiah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1]
b. 1765 d. 1810
Mary Elizabeth Bryant b. 1775
- 10 John Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.1]
b. 1796 d. 1842
Elizabeth Staton b. 1803 d. 1900
- 11 Phillip Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.1.1]
b. 3 Aug 1827 d. 18 Jun 1865
Amada Long b. Dec 1830 d. Aft 1900
- 12 Meedy Alonzo Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.1.1.1]
b. Dec 1858 d. 16 Dec 1924 [ =>]
- 12 Meedy Alonzo Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.1.1.1]
- 11 Phillip Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.1.1]
- 10 Burrell Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2]
b. 1805 d. 1840
Rebecca Peele b. 1806 d. 1896
- 11 Eliza Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 14 Apr 1890
Elisha P Dearman b. 25 Oct 1819 d. 28 May 1882
- 12 Delila Dearman [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.1]
b. 1849
- 12 Delousa Dearman [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.2]
b. 1854
- 12 Isaac William Dearman, Sr [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.3]
b. 13 May 1854 d. 17 May 1919 [ =>]
- 12 John Albert Dearman [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.4]
b. 3 Feb 1865 d. 23 Oct 1928
- 12 Gideon Dearman [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.5]
b. 22 Mar 1870 d. 16 Aug 1938
- 12 Gilbert J Dearman [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.6]
b. 2 Mar 1872 d. 25 Feb 1945
- 12 Delila Dearman [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1.1]
- 11 Eliza Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.2.1]
- 10 John Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1.1]
- 9 Rebecca Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.2]
b. Abt 1771 d. 24 Oct 1835
Willie Keel b. Abt 1772
- 10 Tabitha Keel [1.1.1.1.3.8.6.16.2.1]
b. 1805
- 10 Tabitha Keel [1.1.1.1.3.8.6.16.2.1]
Thomas Tyler b. Abt 1770
- 10 Frances Tyler [1.1.1.1.3.8.6.16.2.2]
- 10 Letha Tyler [1.1.1.1.3.8.6.16.2.3]
- 10 Frances Tyler [1.1.1.1.3.8.6.16.2.2]
- 9 Job Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.3]
b. Abt 1772
- 9 Sarah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.4]
b. Abt 1773
- 9 Penelope Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.5]
b. Abt 1774
- 9 Malachi Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.6]
b. Abt 1775
- 9 Elvy Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.7]
b. Abt 1776
- 9 Nancy Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.8]
b. Abt 1777
- 9 Mary Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.9]
b. 1790 d. 1834
Eli J Deal b. 1790 d. 1864
- 10 Sarah Safronia Deal [1.1.1.1.3.8.6.16.9.1]
b. 1821 d. 1888
Isaac Fincannon b. 1815 d. 1896
- 11 Nancy E Fincannon [1.1.1.1.3.8.6.16.9.1.1]
b. 1840 d. 1922
Alfred Harrison Craig b. 1840 d. 1920
- 12 Harrison A Craig [1.1.1.1.3.8.6.16.9.1.1.1]
b. 4 May 1879 d. 19 Feb 1953 [ =>]
- 12 Harrison A Craig [1.1.1.1.3.8.6.16.9.1.1.1]
- 11 Nancy E Fincannon [1.1.1.1.3.8.6.16.9.1.1]
- 10 Sarah Safronia Deal [1.1.1.1.3.8.6.16.9.1]
- 9 Josiah Stallings [1.1.1.1.3.8.6.16.1]
- 8 Kader Stallings [1.1.1.1.3.8.6.1]
- 7 Thomas Rountree, Jr [1.1.1.1.3.8.7]
b. 1700 d. 1774
Mary
- 8 Thomas Rountree, III [1.1.1.1.3.8.7.1]
b. Bef 1773
- 8 Thomas Rountree, III [1.1.1.1.3.8.7.1]
- 7 Jethro Rountree [1.1.1.1.3.8.8]
b. Abt 1700
- 7 Christian Rountree [1.1.1.1.3.8.9]
b. Abt 1700
- 7 Moses Rountree [1.1.1.1.3.8.10]
b. Abt 1700
- 7 William Rountree [1.1.1.1.3.8.11]
b. 1702
- 8 Job Rountree, Sr [1.1.1.1.3.8.11.1]
b. 1735 d. 1782
- 9 Job Rountree, Jr [1.1.1.1.3.8.11.1.1]
b. 13 Mar 1761 d. 1846
- 10 Levi Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.1]
b. 1772 d. Abt 1841
- 10 Adah Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.2]
b. 1778 d. 25 Sep 1840
- + Job Wethersbee b. 1775 d. 1819
- + Job Wethersbee b. 1775 d. 1819
- 10 Louisiana Zealey Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.3]
b. 1800 d. Abt 1890
Harmon Baughmann b. 1790 d. 1855
- 11 Henry Baughmann [1.1.1.1.3.8.11.1.1.3.1]
b. 1 Mar 1829 d. 10 Jan 1879
Mary Beck b. 14 Apr 1836 d. 27 Oct 1917
- 12 Indiana E Baughmann [1.1.1.1.3.8.11.1.1.3.1.1]
b. 23 May 1858 d. 27 Jan 1943 [ =>]
- 12 Indiana E Baughmann [1.1.1.1.3.8.11.1.1.3.1.1]
- 11 Henry Baughmann [1.1.1.1.3.8.11.1.1.3.1]
- 10 Levi Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.1]
Mary Little
- 10 Captain William Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.4]
b. 18 Feb 1790 d. 9 Jun 1860
Sallie Jane b. Abt 1799
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.4.1]
b. Abt 1833
- 11 Laura Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.4.2]
b. Abt 1835
- 11 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.4.1]
- 10 Captain William Rountree [1.1.1.1.3.8.11.1.1.4]
- 9 Job Rountree, Jr [1.1.1.1.3.8.11.1.1]
- 8 Job Rountree, Sr [1.1.1.1.3.8.11.1]
- 7 Charles Rountree [1.1.1.1.3.8.12]
b. 1705 d. 7 Oct 1760
Judith Walton b. 1710
- 8 Christian Rountree [1.1.1.1.3.8.12.1]
b. 1736 d. 1763
- 8 Rachel Rountree [1.1.1.1.3.8.12.2]
b. 1742 d. 1807
- + Hardy Hunter b. 1742 d. Aug 1794
- + Hardy Hunter b. 1742 d. Aug 1794
- 8 Christian Rountree [1.1.1.1.3.8.12.1]
- 7 Joan Rountree [1.1.1.1.3.8.1]
- 6 Jesse Rountree [1.1.1.1.3.9]
b. Abt 1678 d. 1777
- 6 Charles Rountree [1.1.1.1.3.10]
b. 1680 d. 1759
Lydia McMann b. 1682 d. 1749
- 7 Charles Rountree [1.1.1.1.3.10.1]
b. 1710
Mollie Coleman b. 1712
- 8 Elizabeth Nellie Rowntree [1.1.1.1.3.10.1.1]
b. 1730 d. 1768
Benjamin Bush Vines b. 1723 d. 1780
- 9 Elizabeth Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.1]
b. 1745
William Attaway b. 1740
- 10 Sarah Attaway [1.1.1.1.3.10.1.1.1.1]
b. 1760
- 10 Sarah Attaway [1.1.1.1.3.10.1.1.1.1]
- 9 Jonathan Daniel Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2]
b. 1750 d. 1787
Sarah b. 1750 d. 1832
- 10 William Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2.1]
b. Abt 1782
Pinza?
- 11 Wilson Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2.1.1]
Martha Clanton
- 12 William Henry Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2.1.1.1]
[ =>]
- 12 William Henry Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2.1.1.1]
- 11 Wilson Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2.1.1]
- 10 William Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.2.1]
- 9 Isaiah Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3]
b. 1755 d. 15 Feb 1820
Sarah Attaway b. 1760 d. 1820
- 10 William Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3.1]
b. 1785 d. 1870
Winnifred Winney Mayfield b. 1790 d. 1870
- 11 Isaiah Bedford Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3.1.1]
b. 1812 d. 7 Jun 1874
Elizabeth Smith b. May 1816 d. 1897
- 12 Mary Etta Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3.1.1.1]
b. Jul 1859 d. 2 Apr 1939 [ =>]
- 12 Mary Etta Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3.1.1.1]
- 11 Isaiah Bedford Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3.1.1]
- 10 William Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.3.1]
- 9 Elizabeth Vines [1.1.1.1.3.10.1.1.1]
- 8 Charles Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2]
b. Abt 1763 d. 1815
- 9 Richard Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1]
b. 1813
Sarah McKeever b. 1827
- 10 Eliza Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1]
b. 1854
Alexander Rountree b. 1841 d. Mar 1906
- 11 Sara Jane Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1.1]
b. 16 Sep 1880
- 11 Joseph Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1.2]
b. 1887
- 11 Richard Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1.3]
b. 16 Jun 1893 d. 4 Jun 1947
- + Sadie Robertson b. 23 Jun 1905 d. Oct 1980
- + Sadie Robertson b. 23 Jun 1905 d. Oct 1980
- 11 Araminta Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1.4]
b. 1896 d. Dec 1929
- 11 Anna Eliza Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1.5]
b. Dec 1897
- 11 Sara Jane Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1.1]
- 10 Eliza Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1.1]
- 9 Richard Rountree [1.1.1.1.3.10.1.2.1]
- 8 Elizabeth Nellie Rowntree [1.1.1.1.3.10.1.1]
- 7 Thomas Rountree, Sr [1.1.1.1.3.10.2]
b. 10 Nov 1733 d. 23 Mar 1805
Eva Sturgess b. 1 Feb 1738 d. 1810
- 8 William Rountree [1.1.1.1.3.10.2.1]
b. 1 Oct 1760 d. 1796
- 8 John Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2]
b. 12 Oct 1762 d. 7 Dec 1841
Jelse Thompson b. 12 Feb 1775 d. 1849
- 9 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.1]
b. 27 May 1794 d. 7 Nov 1851
- + John Satterfield b. 29 Jan 1790 d. 4 Mar 1852
- + John Satterfield b. 29 Jan 1790 d. 4 Mar 1852
- 9 Thomas Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2]
b. 29 Mar 1796 d. 24 Apr 1864
Sarah Elizabeth Campbell b. 17 Feb 1796 d. 19 Apr 1864
- 10 Benjamin F Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1]
b. 12 Feb 1827 d. 11 May 1903
Nancy Eugenia Pigg b. 7 Jul 1850 d. 10 Apr 1894
- 11 Thomas J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1.1]
b. 17 Jul 1869 d. 20 Nov 1932
- 11 John Alexander Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1.2]
b. 19 Dec 1871 d. 28 Dec 1943
- 11 Sallie Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1.3]
b. 22 Aug 1876 d. 27 Oct 1895
- 11 Cora Eugenia (Genia) Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1.4]
b. 31 Jul 1879 d. 26 Feb 1946
- 11 Thomas J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1.1]
- 10 Captain John Alexander Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.2]
b. Nov 1832 d. 30 May 1910
Alabama Lynch Baugh b. 12 Jun 1849 d. 12 Mar 1937
- 11 Gertrude Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.2.1]
b. 1880 d. 1960
- + Kirtland
- + Kirtland
- 11 Gertrude Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.2.1]
- 10 Tennessee Sophronia Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.3]
b. 30 Jun 1833 d. 8 Jan 1919
- + Mumford Ewing Neely b. 14 Jun 1831 d. 1926
- + Mumford Ewing Neely b. 14 Jun 1831 d. 1926
- 10 Margaret A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.4]
b. 1839 d. 8 Jun 1889
- + Francis Burrow Sparkman b. 18 Feb 1830 d. 26 Jan 1903
- + Francis Burrow Sparkman b. 18 Feb 1830 d. 26 Jan 1903
- 10 Benjamin F Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.2.1]
- 9 Joseph T Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.3]
b. Abt 1798 d. Bef 1841
Frances O'Dell b. Abt 1805
- 10 James K P Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.3.1]
b. Abt 1838
- 10 Andrew G Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.3.2]
b. 1840
- 10 James K P Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.3.1]
- 9 Anna Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.4]
b. Abt 1801 d. May 1836
- + Finis Washington Shannon b. Abt 1796 d. 1832
- + Finis Washington Shannon b. Abt 1796 d. 1832
- 9 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.5]
b. Abt 1804 d. Bef 1841
- + Joseph Harmon Miller b. 1800
- + Joseph Harmon Miller b. 1800
- 9 Captain John T Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6]
b. 6 Apr 1805 d. 11 Apr 1882
Sarah Ann Scott b. 5 Sep 1817 d. 17 Feb 1852
- 10 Dr Scott LeFevre Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1]
b. 9 Jul 1836 d. 9 Jun 1909
- + Mary Josephine Thompson b. 25 Mar 1843 d. 23 Aug 1865
Georgia Anna Thompson b. 5 Mar 1847 d. 14 May 1910
- 11 Joseph LeFevre Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1]
b. 31 Jul 1866 d. 15 Apr 1943
Annie Boyce Matthews b. 14 Jun 1869 d. 28 Oct 1905
- 12 Evans L Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1.1]
b. 12 Oct 1895 d. 27 Aug 1900
- 12 Joseph Hamer Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1.2]
b. 15 Feb 1899 d. 27 Feb 1971 [ =>]
- 12 Dr Walter Boyce Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1.3]
b. 31 May 1902 d. Apr 1980 [ =>]
- 12 Annie Louise Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1.4]
b. 7 Oct 1905 d. 9 Apr 1906
- 12 Evans L Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1.1]
- + Maude Elizabeth Brantley b. 5 Jun 1872 d. 23 May 1953
- 11 John Asa Rountree, Sr [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.2]
b. 22 Mar 1867 d. 9 Jul 1936
Jennie Maude McIver b. 22 Oct 1875 d. 8 Mar 1963
- 12 Lieut John Asa Rountree, Jr [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.2.1]
b. 13 Aug 1896 d. 27 May 1983 [ =>]
- 12 Selene Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.2.2]
b. 4 Nov 1898 d. Apr 1978
- 12 Lt Colonel McIver Rountree, Sr [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.2.3]
b. 18 Jul 1911 d. 23 Dec 1976 [ =>]
- 12 Lieut John Asa Rountree, Jr [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.2.1]
- 11 Mary A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.3]
b. 1869
- 11 Josie Eugenia Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.4]
b. 17 Jan 1870 d. 11 Oct 1884
- 11 Carrie Lee Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.5]
b. 1871
- 11 Walter Scott Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.6]
b. 4 Sep 1873 d. 6 May 1940
Martha Lawrence Bradshaw b. 1895 d. 1985
- 12 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.6.1]
b. 24 Oct 1921 d. 3 Dec 1995
- 12 Jean Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.6.2]
b. 7 Feb 1923 d. 16 Jan 2009
- 12 Anne Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.6.3]
b. 16 Jun 1928 d. 19 Feb 2019
- 12 Living [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.6.4]
- 12 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.6.1]
- 11 John Harrison Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.7]
b. 6 Aug 1876 d. 3 May 1916
- 11 Roxanna Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.8]
b. 2 Sep 1878 d. 4 Aug 1908
- 11 Myrtle Georgia Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.9]
b. 11 Jan 1881 d. 3 Feb 1916
- + William Thomas Price b. 23 Aug 1875 d. 3 Jun 1939
- + William Thomas Price b. 23 Aug 1875 d. 3 Jun 1939
- 11 James Redmond Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.10]
b. 29 Oct 1883 d. 24 Aug 1939
- 11 Bessie M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.11]
b. Aug 1885
- + Neal S League b. 1885
- + Neal S League b. 1885
- 11 Charles Troup Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.12]
b. 21 Dec 1889 d. 16 Jan 1956
- + Sarah Mae Burleson b. 9 Dec 1892 d. 27 Sep 1973
- + Sarah Mae Burleson b. 9 Dec 1892 d. 27 Sep 1973
- 11 Joseph LeFevre Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1.1]
- + Mary Josephine Thompson b. 25 Mar 1843 d. 23 Aug 1865
- 10 Martha T Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.2]
b. 1839 d. 15 Nov 1882
- + Dr Terry Crittendon Smith b. 3 Feb 1837 d. 28 Nov 1928
- + Dr Terry Crittendon Smith b. 3 Feb 1837 d. 28 Nov 1928
- 10 P Caroline Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.3]
b. 1841
- 10 James R Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.4]
b. 1844 d. Bef 1854
- 10 Mary J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.5]
b. 3 May 1846 d. 9 Feb 1918
- + Pvt Robert E Brantley b. 30 Jan 1840 d. 6 Mar 1931
- + Pvt Robert E Brantley b. 30 Jan 1840 d. 6 Mar 1931
- 10 Salina Ann Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.6]
b. 1848 d. 25 Apr 1920
- + Orlando C Alley b. 14 Dec 1850 d. 15 May 1918
- + Orlando C Alley b. 14 Dec 1850 d. 15 May 1918
- 10 Louisa Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.7]
b. 1849 d. 1854
- 10 Dr Scott LeFevre Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.1]
Mary R McKee b. 4 Feb 1817 d. 20 Jun 1906
- 10 Virginia A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.8]
b. 16 Apr 1855 d. 3 Oct 1922
- + Charles Henry Gray b. 15 Sep 1856 d. 27 Apr 1940
- + Charles Henry Gray b. 15 Sep 1856 d. 27 Apr 1940
- 10 Virginia A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.6.8]
- 9 Jincy Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.7]
b. 1807
- + Joseph H Miller b. Abt 1803
- + Joseph H Miller b. Abt 1803
- 9 Louisa May Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.8]
b. 1810 d. 1880
- + James Colden Sparkman b. 1 Jan 1807 d. 12 Jan 1889
- + James Colden Sparkman b. 1 Jan 1807 d. 12 Jan 1889
- 9 Charles S Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9]
b. 1812
Ann Ophelia Crutcher b. 1827
- 10 Margaret J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9.1]
b. 15 Nov 1844 d. 14 Jun 1911
- + William Wiltshire Burnett b. 22 Jan 1829 d. 16 Mar 1873
- + William Wiltshire Burnett b. 22 Jan 1829 d. 16 Mar 1873
- 10 Mary A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9.2]
b. 1845
- 10 John P Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9.3]
b. 1847
- 10 Sarah E Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9.4]
b. 1849
- 10 Emily T Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9.5]
b. 1852
- 10 Margaret J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.9.1]
- 9 Salena B Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.10]
b. 1814 d. 1853
- + William M Keeton b. 1810 d. 1869
- + William M Keeton b. 1810 d. 1869
- 9 Aurilla Adaline Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.11]
b. 3 Mar 1817 d. 4 Dec 1864
- + John J Mangrum b. 16 Oct 1814 d. 17 Oct 1886
- + John J Mangrum b. 16 Oct 1814 d. 17 Oct 1886
- 9 William Dunardeus Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.12]
b. 1822
- 9 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.10.2.2.1]
- 8 Rachel Rountree [1.1.1.1.3.10.2.3]
b. 12 Mar 1765 d. 18 Feb 1821
- + William Jacobs b. 1780 d. 18 Feb 1821
- + William Jacobs b. 1780 d. 18 Feb 1821
- 8 Charles Rountree [1.1.1.1.3.10.2.4]
b. 24 Sep 1769 d. 3 Jan 1816
Nancy Robinson b. 15 Mar 1778 d. 24 May 1856
- 9 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.4.1]
b. 13 Sep 1800 d. 2 May 1872
- + Charles Wilson b. 1799 d. 1866
- + Charles Wilson b. 1799 d. 1866
- 9 David R Rountree [1.1.1.1.3.10.2.4.2]
b. 15 Aug 1802 d. 15 Jun 1881
- 9 Frances Rountree [1.1.1.1.3.10.2.4.3]
b. 18 Dec 1806 d. 16 Mar 1852
- 9 Jennett Rountree [1.1.1.1.3.10.2.4.4]
b. 12 Feb 1809 d. 12 Apr 1889
- 9 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.4.1]
- 8 Lydia Rountree [1.1.1.1.3.10.2.5]
b. 19 Jan 1770
- + John Cates b. 1772 d. 1816
- + John Cates b. 1772 d. 1816
- 8 Andrew Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6]
b. 23 Apr 1772 d. 14 Jul 1841
Mary Robinson b. 12 Mar 1782 d. 21 Jan 1864
- 9 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.1]
b. 1800 d. 1868
- + Jamison
- + Jamison
- 9 Thomas Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2]
b. 28 May 1801 d. 1 Jan 1870
Rhoda Donaldson
- 10 Cooper Bates Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.1]
b. 1830 d. 1911
- 10 Emily J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.2]
b. 1835
- 10 John Ferren Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.3]
b. 1837 d. 1907
- 10 Joseph Gustave Rountree, I [1.1.1.1.3.10.2.6.2.4]
b. 2 Jan 1838 d. 8 Oct 1880
Elizabeth Cornelia Stillwell b. 7 May 1860 d. 20 Apr 1946
- 11 Joseph Gustave Rountree, II [1.1.1.1.3.10.2.6.2.4.1]
b. 9 Dec 1879 d. 5 Aug 1962
Adele Kinkler b. 30 Mar 1886 d. 30 Jun 1934
- 12 Adele Kinkler Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.4.1.1]
b. 7 Jan 1905 d. 28 Oct 2000
- 12 Joseph Gustave Rountree, III [1.1.1.1.3.10.2.6.2.4.1.2]
b. 7 Jan 1914 d. 27 Mar 1993 [ =>]
- 12 Adele Kinkler Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.4.1.1]
- 11 Joseph Gustave Rountree, II [1.1.1.1.3.10.2.6.2.4.1]
- 10 Rhoda Melvina Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.5]
b. 15 Sep 1840 d. 5 Oct 1931
- + John Newton Montgomery, (Xfer) b. 13 May 1834 d. 21 Jun 1876
- + John Newton Montgomery, (Xfer) b. 13 May 1834 d. 21 Jun 1876
- 10 Cooper Bates Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.2.1]
- 9 David Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.3]
b. 1802 d. 1867
- + Mary Ann Rourke b. 1807 d. 1893
- + Mary Ann Rourke b. 1807 d. 1893
- 9 William Wallace Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.4]
b. 1804 d. 1872
- 9 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.5]
b. 21 Feb 1806 d. 1845
- + George Washington McKee b. 1810 d. 10 Sep 1875
- + George Washington McKee b. 1810 d. 10 Sep 1875
- 9 Jane Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.6]
b. 1808
- + Shaw
- + Shaw
- 9 John Jackson Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7]
b. 18 Aug 1815 d. 18 Oct 1888
Margaret McKee b. 4 May 1821 d. 5 Oct 1869
- 10 Charles W Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.1]
b. 21 Jan 1839 d. 31 Mar 1917
- 10 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.2]
b. Sep 1842 d. 12 Aug 1922
Carrie Askew b. 1851
- 11 Joe Mound Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.2.1]
b. 15 Apr 1877 d. 5 Jun 1951
- 11 Joe Mound Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.2.1]
- 10 Emily J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.3]
b. 1844
- 10 Mary A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.4]
b. 1 May 1846 d. 5 Jul 1930
- 10 Margaret Josephine Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.5]
b. 1848
- 10 John Marion Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6]
b. 30 Dec 1850 d. 18 May 1922
Melvina Frances Witherspoon b. 23 May 1857 d. 24 Sep 1932
- 11 Paul Hollis Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1]
b. 3 Sep 1878 d. 22 Jan 1914
Sarah Adeline Spivey b. 17 Sep 1880
- 12 Willie M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1.1]
b. Sep 1899
- 12 Hollis E Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1.2]
b. 24 Feb 1901 d. 8 Jan 1970 [ =>]
- 12 Charles Aubrey Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1.3]
b. 1904 [ =>]
- 12 Marvin Fulton Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1.4]
b. 14 Feb 1908 d. 14 Mar 1983 [ =>]
- 12 Viola Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1.5]
b. 1911
- 12 Willie M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1.1]
- 11 Maggie M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.2]
b. Jun 1888
- + William Dozier Locke b. 1890
- + William Dozier Locke b. 1890
- 11 John Minor Rountree, Jr [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.3]
b. 21 Jul 1893 d. Mar 1975
- 11 Paul Hollis Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.6.1]
- 10 Thomas Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.7]
b. 1852
- 10 Kansas Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.8]
b. 1855
- 10 Ida P Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.9]
b. 1860
- 10 Charles W Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.1]
Susan H Borders b. 1836
- 10 Ida R. Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.10]
b. 1874
- 10 John E Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.11]
b. 1878
- 10 Ida R. Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.7.10]
- 9 Mary Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.8]
b. 23 Apr 1817 d. 20 Jul 1865
- + Robert Rankin McKee b. 11 May 1820 d. 28 May 1893
- + Robert Rankin McKee b. 11 May 1820 d. 28 May 1893
- 9 Cicero Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.9]
b. 1818 d. 1851
- 9 Emily Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.10]
b. 27 Oct 1821 d. 26 Oct 1899
- + Nelson McKee b. 1818 d. 1863
- + Nelson McKee b. 1818 d. 1863
- 9 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.6.1]
- 8 Thomas Rountree, Jr [1.1.1.1.3.10.2.7]
b. 1 May 1776 d. 24 Apr 1864
- + Sara Victoria Robertson b. 17 Feb 1776 d. 19 Apr 1864
- + Sara Victoria Robertson b. 17 Feb 1776 d. 19 Apr 1864
- 8 Joseph Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8]
b. 14 Apr 1782 d. 25 Dec 1874
Nancy Nichols b. 6 Nov 1786 d. 31 Jan 1857
- 9 Louisa Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.1]
b. 16 Aug 1808 d. 10 Jun 1809
- 9 Junius Meredith Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2]
b. 20 Mar 1810 d. 22 Sep 1888
Martha Jane Miller b. Abt 1813
- 10 Mary Wilson Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.1]
b. 24 Nov 1832 d. 6 Mar 1862
- 10 Ophelia Virginia Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.2]
b. 22 May 1834 d. 3 Jul 1867
- 10 Sarah Joanna Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.3]
b. 9 Dec 1835 d. 19 Oct 1861
- 10 Naomi Eugenia Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.4]
b. 19 Mar 1838 d. 13 Apr 1881
- 10 Lafayette Marshall Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5]
b. 18 Apr 1840 d. 16 Feb 1931
Diana Blevins b. 23 Sep 1842 d. 26 Aug 1914
- 11 James Leslie Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1]
b. 2 May 1875 d. 29 Mar 1908
Florence Newsome b. 1879 d. 30 Nov 1941
- 12 Hazel Eileen Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1.1]
b. 21 Sep 1901 d. 21 Dec 1991
- 12 George A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1.2]
b. 12 Nov 1902 d. 25 Aug 1945
- 12 Marshall Neal Rountree, Sr [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1.3]
b. 13 Jun 1905 d. 14 Apr 1984 [ =>]
- 12 Leslie Claire Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1.4]
b. 3 Oct 1907 d. 30 Mar 2001
- 12 Hazel Eileen Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1.1]
- 11 Oscar R Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.2]
b. 14 Sep 1878 d. 28 Sep 1880
- 11 Salie May Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.3]
b. 30 Jun 1880 d. 28 Sep 1880
- 11 James Leslie Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.5.1]
- 10 Ann Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.6]
b. 20 Feb 1842 d. 25 May 1916
- + Captain George Thomas Beal b. 10 Nov 1832 d. 13 Jul 1910
- + Captain George Thomas Beal b. 10 Nov 1832 d. 13 Jul 1910
- 10 Nancy Matilda R Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.7]
b. 2 Sep 1844 d. 1888
- 10 Martha Jane Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.8]
b. 3 Apr 1847 d. 1888
- 10 Louisa Amanda M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.9]
b. 16 May 1849 d. 1888
- 10 Mary Wilson Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.2.1]
- 9 Zenas Marion Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3]
b. 8 Jun 1812 d. 13 Dec 1890
Elizabeth Massey b. Abt 1822 d. 30 Jul 1907
- 10 Newton Marion Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.1]
b. 5 Nov 1838 d. 4 Aug 1907
- 10 James H Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.2]
b. 1840
- 10 Clarissa F Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.3]
b. 1842
- 10 Nancy Jane Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4]
b. 30 Apr 1845 d. 27 Jul 1907
James Marion Wilhoit b. 12 Jan 1834 d. 8 Nov 1914
- 11 Sidney Edwin/Earl Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.1]
b. 3 Mar 1868 d. 22 Oct 1936
- 11 James Guy Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.2]
b. 12 Aug 1871 d. 7 May 1926
- 11 Andrew Hugh Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.3]
b. 9 Jan 1874 d. 2 Jan 1941
- 11 Ralph Royal Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.4]
b. 19 Mar 1876 d. 16 Dec 1952
- 11 Zenas Roy Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.5]
b. 2 Dec 1878 d. 9 Jan 1960
- 11 Elizabeth Jane Morris [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.6]
b. 13 Dec 1882 d. 2 Aug 1950
- 11 William Rush Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.7]
b. 29 Jun 1886 d. 19 Feb 1958
- 11 Sidney Edwin/Earl Wilhoit [1.1.1.1.3.10.2.8.3.4.1]
- 10 William W Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.5]
b. 1850
- 10 Florence Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.6]
b. 1853
- 10 Margaret Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.7]
b. 1855
- 10 Mary Alice Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.8]
b. 1858
- 10 Joseph Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.9]
b. 1862
- 10 Willis Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.10]
b. Abt 1866
- 10 Newton Marion Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.3.1]
- 9 Lucius Amandas Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4]
b. 27 Feb 1814 d. 3 Dec 1906
Rebecca F McClelland b. Abt 1828 d. 13 Aug 1903
- 10 Virginia F Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4.1]
b. 1846
- 10 Martha Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4.2]
b. 1848
- 10 Joseph E Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4.3]
b. 21 Oct 1854 d. 27 Jun 1860
- 10 Josephine Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4.4]
b. 16 May 1860 d. 7 Sep 1862
- 10 Clara Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4.5]
b. 12 Sep 1862 d. 3 Feb 1970
- 10 Virginia F Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.4.1]
- 9 Louisa Amanda Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.5]
b. 31 Aug 1816 d. 16 Mar 1886
- + James Harvey Slavens b. 30 Jul 1809 d. 23 Jun 1888
- + James Harvey Slavens b. 30 Jul 1809 d. 23 Jun 1888
- 9 Caroline Fetnah Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.6]
b. 13 Dec 1818 d. 6 Feb 1819
- 9 Marzavan Jerome Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.7]
b. 24 Mar 1820 d. 26 Oct 1900
Mary Lizzie Shackelford b. Abt 1824 d. 19 Nov 1893
- 10 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.7.1]
b. 1846
- 10 Bentley J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.7.2]
b. Feb 1850 d. 11 Sep 1906
- 10 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.7.1]
- + Mary Louise Winton b. 23 Apr 1823 d. 19 Nov 1893
- 9 Almus Linneaus Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8]
b. 28 Oct 1822 d. 25 Jan 1891
Delilah Mitchell b. 1825
- 10 William Jones Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.1]
b. 17 Oct 1847 d. 27 Jan 1934
Frances E Massey b. Aug 1857
- 11 Frank M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.1.1]
b. Sep 1876
- 11 Francis Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.1.2]
b. Jan 1885
- 11 David H Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.1.3]
b. Feb 1888
- 11 Frank M Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.1.1]
- 10 William Jones Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.1]
Elizabeth Ellen Hildreth b. 26 Jan 1838 d. 27 Feb 1906
- 10 Mary E A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.2]
b. Abt 1860
- 10 John A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.3]
b. Abt 1862
- 10 Susan J Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.4]
b. Abt 1865
- 10 Thomas H Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.5]
b. Abt 1867
- 10 Joseph Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.6]
b. Abt 1869
- 10 Richard Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.7]
b. Abt 1871
- 10 Daisy Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.8]
b. Abt 1873
- 10 Myrtle Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.9]
b. Abt 1875
- 10 Levitha Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.10]
b. Abt 1879
- 10 Mary E A Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.8.2]
- 9 Allen Jones Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.9]
b. 25 Dec 1824 d. 8 Jul 1848
- 9 Almarinda Caroline Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.10]
b. 9 Jul 1828 d. 12 Oct 1872
- + William B Massey b. 19 Mar 1824 d. 14 Mar 1888
- + William B Massey b. 19 Mar 1824 d. 14 Mar 1888
- 9 Louisa Rountree [1.1.1.1.3.10.2.8.1]
- 8 William Rountree [1.1.1.1.3.10.2.1]
- 7 Charles Rountree [1.1.1.1.3.10.1]
- 6 Moses Rountree, Sr [1.1.1.1.3.11]
b. 1682 d. 1755
Sarah Lilly b. 15 Jun 1691 d. Aft 1 Apr 1755
- 7 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.11.1]
b. 1698 d. Aft 1758
John Hollowell b. 1695
- 8 Thomas Hollowell [1.1.1.1.3.11.1.1]
b. 1739 d. 1821
- 8 Thomas Hollowell [1.1.1.1.3.11.1.1]
- 7 Ledy Rountree [1.1.1.1.3.11.2]
b. 1702
- 7 Ann Rountree [1.1.1.1.3.11.3]
b. 1702 d. Aft 1758
- 7 Moses Rountree, Jr [1.1.1.1.3.11.4]
b. 1710 d. 12 Sep 1758
- 7 Hannah Rountree [1.1.1.1.3.11.5]
b. 1711 d. 12 Sep 1758
- 7 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.11.6]
b. 1733 d. 1802
- + Abner Hollowell b. 1734 d. 1802
- + Abner Hollowell b. 1734 d. 1802
- 7 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.11.1]
- 6 William Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12]
b. 1699 d. 16 Sep 1766
Dorcas Dudley b. 1703 d. Bef 5 Oct 1765
- 7 Isabella Rowntree [1.1.1.1.3.12.1]
b. 1726 d. 1765
William Richard Goldsmith, ¶ b. 1740 d. 1834
- 8 Marie Massie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.1]
- 8 Martha Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.2]
d. 26 Jul 1854
- 8 Lewsy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.3]
- 8 Lewsender Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.4]
- 8 Milley Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.5]
- 8 William Thomas Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.1.6]
b. 24 Jun 1762 d. 21 Mar 1835
Elizabeth Mildred Rowntree b. 1767 d. 1846
- 9 Mary Ann Polly Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.1]
b. 1785 d. 24 Feb 1829
Joseph Newland Howard b. 1788 d. 1860
- 10 Wiley Ann Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.1]
b. 1813 d. 26 Oct 1896
- 10 Lewis Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.2]
b. 9 Sep 1813 d. 1875
- 10 William Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.3]
b. 3 Sep 1817 d. 10 Nov 1891
Elizabeth Wharton b. 21 Jan 1821 d. 6 Apr 1885
- 11 James Samuel Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.3.1]
b. 31 Dec 1847 d. 2 Apr 1931
Sarah Elizabeth Hill b. 17 Sep 1845 d. 12 Feb 1943
- 12 James Clayton Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.3.1.1]
b. 1 Oct 1869 d. 3 Mar 1891 [ =>]
- 12 James Clayton Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.3.1.1]
- 11 James Samuel Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.3.1]
- 10 Elijah Welborn Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4]
b. 10 Mar 1822 d. 30 Mar 1892
Frances Cornelia Batson b. 7 Nov 1836 d. 8 Jan 1889
- 11 William G. Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.1]
b. 1863
- 11 Mary S Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.2]
b. 1866
- 11 James Thomas Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.3]
b. 20 Nov 1867 d. 6 Aug 1893
- 11 Kizziah Marie Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4]
b. 10 Mar 1870 d. 13 Feb 1959
William Samuel Marchbanks b. 10 May 1868 d. 16 Aug 1958
- 12 Mamie Lee Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.1]
b. 18 Dec 1892 d. 27 Jan 1911
- 12 Margaret Cornelia Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.2]
b. 1895 d. 1976 [ =>]
- 12 Walter William Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.3]
b. 12 Jun 1900 d. 18 Jan 1978
- 12 Ruth Velma Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.4]
b. 8 Oct 1903 d. 22 Apr 1998
- 12 Wilburn Elijah Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.5]
b. 4 Oct 1905 d. 6 May 1940
- 12 Grace Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.6]
b. 8 Nov 1910 d. 13 Apr 1993
- 12 Kate Agnes Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.7]
b. 28 Nov 1912 d. 14 Aug 2014
- 12 Mamie Lee Marchbanks [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.4.1]
- 11 Dock Benjamin Few Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.5]
b. 5 Aug 1873 d. 22 Nov 1938
- 11 Wilburn Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.6]
b. 1878
- 11 William G. Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.4.1]
- 10 Fatima Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.5]
b. 1823 d. 10 Jul 1902
Arthur Nathaniel Batson b. 19 Jul 1821 d. 23 May 1907
- 11 Martha Jane Batson [1.1.1.1.3.12.1.6.1.5.1]
b. 29 Jun 1845 d. 14 Apr 1929
Richard Harrison Huff b. 1 Jan 1843 d. 29 Apr 1919
- 12 Hezekiah Lafayette Huff [1.1.1.1.3.12.1.6.1.5.1.1]
b. 17 Sep 1866 d. 12 Dec 1957 [ =>]
- 12 Hezekiah Lafayette Huff [1.1.1.1.3.12.1.6.1.5.1.1]
- 11 Martha Jane Batson [1.1.1.1.3.12.1.6.1.5.1]
- 10 Mary A Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.6]
b. 1823 d. 2 May 1889
- 10 Benjamin Franklin Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.7]
b. 23 Mar 1825 d. 2 May 1909
- 10 Wiley Ann Howard [1.1.1.1.3.12.1.6.1.1]
- 9 Thomas Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.1.6.2]
b. 19 Dec 1787 d. 28 Apr 1868
Sarah Sally Cook b. 17 Jan 1795 d. 24 Mar 1859
- 10 Nancy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.1]
b. 1815 d. 1891
- 10 William Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2]
b. 30 Apr 1819 d. 15 Apr 1911
- + Mary Louisa Stone b. 29 Oct 1817 d. 24 Aug 1852
Nancy Clairy Hair b. 17 Dec 1835 d. 28 Feb 1918
- 11 Fannie Hair Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.1]
b. 5 Apr 1855 d. 19 May 1873
- 11 Caroline Ione Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.2]
b. 13 Mar 1857 d. 5 Feb 1938
James Austin West b. 12 Jan 1856 d. 26 Oct 1923
- 12 William Goldsmith West [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.2.1]
b. 16 Sep 1876 d. 11 Nov 1919 [ =>]
- 12 Ione May West [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.2.2]
b. 4 May 1879 d. 20 Jul 1962
- 12 Sargeant Harley West, Sr [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.2.3]
b. May 1881 d. 28 Oct 1937 [ =>]
- 12 James Austin West, Jr. [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.2.4]
b. 16 Aug 1890 d. 23 Jul 1926
- 12 William Goldsmith West [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.2.1]
- 11 Sallie A. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.3]
b. Abt 1860
- 11 Hattie S Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.4]
b. Jun 1864
- 11 Peter H. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.5]
b. Abt 1866
- 11 Rosa H. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.6]
b. Abt 1869
- 11 James W Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.7]
b. Abt 1871
- 11 May Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.8]
b. Abt 1872
- 11 John S Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.9]
b. Jun 1874
- 11 Fannie Hair Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.2.1]
- + Mary Louisa Stone b. 29 Oct 1817 d. 24 Aug 1852
- 10 Thomas Goldsmith, Jr [1.1.1.1.3.12.1.6.2.3]
b. 29 May 1826 d. 14 Mar 1880
Mary Elizabeth Charles b. 9 Dec 1834 d. 30 Jun 1914
- 11 Charles Homer Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.3.1]
b. 8 Dec 1854 d. 1 May 1919
- 11 Charles Homer Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.3.1]
- 10 Nancy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.2.1]
- 9 John Alexander Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3]
b. 19 Dec 1787 d. 28 Jun 1825
Elizabeth Marchbanks b. 1789 d. 1830
- 10 William Alexander Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1]
b. 1812 d. 9 Mar 1864
Mary Jane Polly Buckner b. 1812 d. 1854
- 11 John Anderson Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.1]
b. 1836 d. 9 Dec 1891
Nancy Caroline McMahan b. 26 Mar 1833 d. 18 Jun 1913
- 12 Zebulon Vance Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.1.1]
b. 12 Jun 1860 d. 24 Oct 1938 [ =>]
- 12 Zebulon Vance Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.1.1]
- 11 Nancy Caroline Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.2]
b. 8 Apr 1837 d. 18 Sep 1895
- 11 Thomas A Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.3]
b. 1840
- 11 William M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.4]
b. 1842 d. 9 Mar 1864
- 11 James P Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.5]
b. 1844 d. 28 Jan 1865
- 11 Berry E Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.6]
b. 18 Sep 1846 d. 27 Oct 1929
- + Minerva Jane McKinney b. Abt 1847
- + Minerva Jane McKinney b. Abt 1847
- 11 Stephen Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.7]
b. 1848
- 11 Albert Lafayette Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8]
b. 4 Dec 1852 d. 18 Nov 1922
Ellender Carrie Shelton b. 6 May 1848 d. 4 Jul 1907
- 12 Letha Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.1]
b. 29 Aug 1876 d. 11 Jan 1946
- 12 Ida Mae Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.2]
b. 19 Jun 1877 d. 22 Oct 1925 [ =>]
- 12 Stephen Oliver Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.3]
b. 17 Aug 1881 d. 5 Sep 1958
- 12 William J Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.4]
b. 4 Sep 1887 d. 31 Jul 1947
- 12 Laura Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.5]
b. 24 Sep 1889 d. 14 Apr 1967
- 12 Sue Anna Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.6]
b. 31 Jul 1892 d. 13 Feb 1984
- 12 Letha Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.1]
Loruma Loary Lunsford b. 11 Jun 1883 d. 28 Feb 1941
- 12 Lillie Mae Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.7]
b. 29 Mar 1911 d. 30 Dec 1988
- 12 Henry Edison Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.8]
b. 28 Mar 1914 d. 9 Mar 1963
- 12 Robert Hampton Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.9]
b. 27 Feb 1915 d. 1985
- 12 Clara Myrtle Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.10]
b. 26 Sep 1918 d. 7 Sep 2013
- 12 Lillie Mae Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.8.7]
- 11 Doctor Y Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.9]
b. 1854
- 11 John Anderson Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.1]
Mary Ann McMahan b. Abt 1830
- 11 Franklin Pierce Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.10]
b. 8 Nov 1856 d. 13 Sep 1931
Rachel Mariana Duncan b. Abt 1855 d. Bef 1900
- 12 John William Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.10.1]
b. 27 Apr 1878 d. 9 Mar 1959 [ =>]
- 12 John William Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.10.1]
- 11 Harriet M C Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.11]
b. 1859
- 11 Marcus Ervin Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12]
b. 27 Aug 1860 d. 8 Aug 1947
Ollie Lavinia Mullinax b. 30 May 1875 d. 29 Jan 1963
- 12 Mary Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12.1]
b. Oct 1892
- 12 Birtha Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12.2]
b. Mar 1894
- 12 Ida Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12.3]
b. Apr 1896
- 12 Lennie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12.4]
b. Apr 1899
- 12 William Marion Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12.5]
b. 7 Mar 1907 d. 2 Sep 1962
- 12 Mary Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.12.1]
- 11 Lydia Matilda Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.13]
b. 11 Nov 1863 d. 22 Jun 1948
Kelsey Douglas Radford b. 25 Sep 1858 d. 20 Nov 1945
- 12 Jewel Edgar Radford [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.13.1]
b. 13 Sep 1898 d. 17 Oct 1979 [ =>]
- 12 Jewel Edgar Radford [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.13.1]
- 11 Franklin Pierce Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1.10]
- 10 Milly Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.2]
b. 1814 d. 1820
- 10 Elizabeth Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3]
b. 5 Jun 1818 d. 24 Sep 1909
James Alexander Bradley, (Xfer) b. 1813 d. 1891
- 11 William Turner Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.1]
b. 25 Sep 1847 d. 19 Mar 1926
Mary Louise Holcombe b. Abt 1852 d. 10 Oct 1920
- 12 Sue Estes Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.1.1]
b. 2 Feb 1876 d. 21 Jul 1962 [ =>]
- 12 Sue Estes Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.1.1]
- 11 Lucinda Susan Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.2]
b. 1852 d. 1922
Rufus Smith Penland b. 1845 d. 1908
- 12 Alexander Elmore Penland [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.2.1]
b. 1874 d. 1964 [ =>]
- 12 Rufus S Penland [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.2.2]
b. 1884 d. 1950 [ =>]
- 12 Thomas Noble Penland [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.2.3]
b. 2 Feb 1887 d. 9 Jul 1975 [ =>]
- 12 Alexander Elmore Penland [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.2.1]
- 11 Nelson Morgan Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3]
b. 12 May 1856 d. 3 Jan 1923
Adina C F Freeman b. Mar 1860 d. 1937
- 12 Alfred Robert Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.1]
b. 8 May 1878 d. 1958 [ =>]
- 12 Curtis E Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.2]
b. Nov 1882
- 12 Don D Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.3]
b. Aug 1886
- 12 Bertha L Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.4]
b. Jul 1888
- 12 Lula E Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.5]
b. 4 Dec 1890 d. 23 Aug 1980 [ =>]
- 12 Minnie M Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.6]
b. Feb 1894
- 12 Alfred Robert Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.3.1]
- 11 William Turner Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.3.1]
- 10 Massey Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.4]
b. 1820 d. 1825
- 10 Lucy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.5]
b. 1822 d. 1825
- 10 John Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.6]
b. 10 Jul 1824 d. 12 Dec 1911
Naomi Bryan Corn b. 2 Apr 1832 d. 25 Aug 1909
- 11 Mary Ann Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.6.1]
b. 20 Apr 1866 d. 4 Aug 1952
Thomas Bedford Faver b. 29 Feb 1864 d. 29 Jul 1948
- 12 May Malinda Faver [1.1.1.1.3.12.1.6.3.6.1.1]
b. 1888 d. 1972 [ =>]
- 12 Lon Bedford Faver [1.1.1.1.3.12.1.6.3.6.1.2]
b. 2 Dec 1906 d. 26 Feb 1972 [ =>]
- 12 May Malinda Faver [1.1.1.1.3.12.1.6.3.6.1.1]
- 11 Mary Ann Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.6.1]
- 10 Matilda Lucinda Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7]
b. 28 Jul 1824 d. 15 Oct 1903
John Alexander Robbins b. 1824 d. 1867
- 11 Wiley Marion Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1]
b. 5 Oct 1851 d. 13 Mar 1916
Mary Elizabeth Miracle Breach b. 3 Oct 1858 d. 2 Jul 1932
- 12 John Alexander Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.1]
b. 27 Jun 1873 d. 11 Nov 1956 [ =>]
- 12 Wilburn Thomas Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.2]
b. 29 Oct 1876 d. 16 Jan 1959
- 12 Nancy J. Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.3]
b. Aug 1879
- 12 Hiram Cleveland Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.4]
b. 25 Apr 1884 d. 1 Feb 1955
- 12 Rev Gale Ward Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.5]
b. 8 Jun 1893 d. 19 Jun 1979
- 12 Jonathan Garrett Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.6]
b. 16 Jan 1897 d. 20 Feb 1974
- 12 John Alexander Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1.1]
- 11 Mary Elizabeth Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.2]
b. 1857 d. 10 Sep 1896
Criswell H Bose Key b. 1851 d. Abt 1886
- 12 Elizabeth Key [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.2.1]
b. 11 Nov 1876 d. 9 Dec 1945 [ =>]
- 12 Elizabeth Key [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.2.1]
- 11 Wiley Marion Robbins [1.1.1.1.3.12.1.6.3.7.1]
- 10 Sarah Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.8]
b. 1826
Jonathan Wesley Bradley, (Xfer) b. 1815 d. 1864
- 11 Martha Jane Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.8.1]
b. 9 Feb 1858 d. 3 Dec 1934
James Alfred Cook b. 30 Jun 1860 d. 4 Jul 1940
- 12 Sarah Naomi Cook [1.1.1.1.3.12.1.6.3.8.1.1]
b. 31 Mar 1887 d. 7 Mar 1965 [ =>]
- 12 Sarah Naomi Cook [1.1.1.1.3.12.1.6.3.8.1.1]
- 11 Martha Jane Bradley [1.1.1.1.3.12.1.6.3.8.1]
- 10 William Alexander Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.3.1]
- 9 William Thomas Goldsmith, Jr [1.1.1.1.3.12.1.6.4]
b. 4 Mar 1796 d. 5 Sep 1852
Lucretia Lucy Johnson b. 1811 d. 15 Oct 1874
- 10 George Washington Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1]
Temperance Loveless
- 11 James A Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1]
b. 1851
Letha P b. 1853
- 12 Elery Macklin Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1.1]
b. 1875 d. 1939 [ =>]
- 12 Gertrude L Miller [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1.2]
b. 1885
- 12 Musella W Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1.3]
b. 1891
- 12 James H Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1.4]
b. 1894
- 12 Elery Macklin Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1.1]
- 11 James A Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1.1]
- 10 Elizabeth Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2]
b. 22 Nov 1828 d. 16 May 1899
Benjamin F Veal b. 11 Nov 1821 d. 3 Sep 1889
- 11 Elizabeth Louise Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.1]
b. 1850
- 11 Mary E Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.2]
b. 1854
- 11 Benjamin Hill Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3]
b. 15 Jan 1858 d. 5 Feb 1921
Lucy Caroline Peacock b. 19 Mar 1859 d. 21 Jun 1910
- 12 W Franklin Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3.1]
b. 12 Nov 1884 d. 18 Aug 1902
- 12 Hattie Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3.2]
b. May 1888 d. 1972
- 12 Toulmine Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3.3]
b. 2 Jul 1889 d. 5 Oct 1961
- 12 Sarah Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3.4]
b. Feb 1894 d. 1986
- 12 Lucy Harrison Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3.5]
b. Sep 1896 d. 1936
- 12 W Franklin Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.3.1]
- + Carrie Scott Benson b. 20 Feb 1874 d. 11 Oct 1947
- 11 Bartie Cornelia Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.4]
b. 30 Dec 1860 d. 8 Jan 1926
William Mason Ragsdale, Sr b. 30 Nov 1854 d. 21 Jul 1903
- 12 Benjamin Elijah Ragsdale [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.4.1]
b. 1889 d. 1953
- 12 William Mason Ragsdale, Jr [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.4.2]
b. 1891 d. 1960
- 12 Benjamin Elijah Ragsdale [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.4.1]
- 11 Ada Jane Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.5]
b. Feb 1864
- + Joseph T Hamilton b. Mar 1864
- + Joseph T Hamilton b. Mar 1864
- 11 Lucy G Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.6]
b. 30 Aug 1867 d. 6 Sep 1899
- + Julius O Wells b. 1866 d. 1931
- + Julius O Wells b. 1866 d. 1931
- 11 Annie Rebecca Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.7]
b. 23 Aug 1870 d. 5 Feb 1956
Ollie E Torrey b. May 1869
- 12 Benjamin Leslie Torrey [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.7.1]
b. 11 Jun 1896 d. 30 Aug 1945 [ =>]
- 12 Benjamin Leslie Torrey [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.7.1]
- 11 Elizabeth Louise Veal [1.1.1.1.3.12.1.6.4.2.1]
- 10 H L Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.3]
b. 1832
- 10 Emily T Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.4]
b. 1837
- 10 Mary Lee Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.5]
b. 19 Apr 1839 d. 4 Jan 1892
Lewis H Tumlin b. 19 May 1809 d. 2 Jan 1875
- 11 Lula T Tumlin [1.1.1.1.3.12.1.6.4.5.1]
b. May 1853 d. 1913
- 11 Lewis Henry Tumlin [1.1.1.1.3.12.1.6.4.5.2]
b. 1855 d. 1855
- 11 George Henry Tumlin [1.1.1.1.3.12.1.6.4.5.3]
b. 18 Apr 1856 d. 7 Jul 1890
- 11 Cora Marie Tumlin [1.1.1.1.3.12.1.6.4.5.4]
b. 1857 d. 1870
- 11 Lula T Tumlin [1.1.1.1.3.12.1.6.4.5.1]
- 10 George Washington Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.4.1]
- 9 Amelia Millie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.5]
b. 8 Sep 1800 d. 24 Jul 1863
Josiah Greer b. 11 Oct 1793 d. 2 Feb 1866
- 10 Elizabeth Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.1]
b. 20 Aug 1819 d. 1880
- 10 John Lafette Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.2]
b. 6 Nov 1820 d. 8 Mar 1882
- 10 Catherine Kate Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.3]
b. 1830 d. 4 Nov 1880
- 10 Benjamin Franklin Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.4]
b. 13 May 1833 d. 19 Dec 1914
- 10 Turner Goldsmith Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.5]
b. 5 Sep 1836 d. 2 May 1911
Cordelia Robinson b. 11 Feb 1851 d. 5 Jul 1926
- 11 Turner Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.5.1]
b. Jan 1881
- 11 Edwin Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.5.2]
b. Nov 1882
- 11 Kathrine Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.5.3]
b. Jul 1886 d. Aft 1930
- + George Heard Tunnell b. 31 Oct 1866 d. 8 Jan 1939
- + George Heard Tunnell b. 31 Oct 1866 d. 8 Jan 1939
- 11 Turner Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.5.1]
- 10 James Carson Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.6]
b. 27 May 1838 d. 25 May 1898
- 10 Lucy K Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.7]
b. 9 Nov 1839 d. 8 May 1902
- 10 Elizabeth Greer [1.1.1.1.3.12.1.6.5.1]
- 9 Elizabeth Bettie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.6]
b. 28 Sep 1802 d. 25 Jun 1892
- + Thomas McCrary b. Abt 1801
- + Thomas McCrary b. Abt 1801
- 9 Major Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7]
b. 28 Sep 1802 d. 25 Jun 1892
Maria Louisa Stokes b. 11 Oct 1812 d. 19 Apr 1887
- 10 William Thomas Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.1]
b. 1831 d. 25 May 1918
Mary Theodosia H b. 1862
- 11 Theodocia M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.1.1]
b. 1897
- 11 Vernon H Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.1.2]
b. 1902
- 11 Theodocia M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.1.1]
- 10 Lucy Elizabeth Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.2]
b. 1 Jan 1832 d. 1 Mar 1859
- 10 Maria Louisa Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.3]
b. 17 Feb 1833 d. 14 Aug 1898
- 10 John Henry Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.4]
b. 11 Nov 1835 d. 4 May 1919
- + Anna Hill Sheldon
Sarah Eliza Peers b. Abt 1842
- 11 M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.4.1]
b. 1859
- 11 M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.4.1]
- + Anna Hill Sheldon
- 10 Washington Lafayette Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.5]
b. 15 Jul 1837 d. 31 May 1866
- 10 James Manning Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6]
b. 29 Apr 1839 d. 15 Jun 1936
Ann Ellen Dent b. 8 Sep 1842 d. 29 Aug 1928
- 11 Joseph D. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6.1]
b. 1868
- 11 Ida R. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6.2]
b. 1870
- 11 Jennie V Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6.3]
b. 1873
- 11 James Manning Goldsmith, Jr [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6.4]
b. 1875 d. 5 Jul 1957
- 11 Annie D Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6.5]
b. 1877 d. 11 Aug 1933
- 11 Joseph D. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.6.1]
- 10 Jeremiah Wickliffe Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7]
b. 6 Mar 1841 d. 27 Aug 1925
Mary Eliza Meador b. 21 Dec 1847 d. 2 Oct 1884
- 11 Paul Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7.1]
b. 26 Jan 1875 d. 23 Jan 1922
Elizabeth Barnes Fitten b. 28 Feb 1878 d. 21 Nov 1947
- 12 John Fitten Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7.1.1]
b. 1902 d. 1966 [ =>]
- 12 Jere Wycliff Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7.1.2]
b. 20 Sep 1909 d. 5 Feb 1987 [ =>]
- 12 John Fitten Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7.1.1]
- 11 Dr John Meador Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7.2]
b. 6 Apr 1878 d. 26 Oct 1909
- 11 Paul Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.7.1]
- 10 Paul Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.8]
b. 18 Oct 1844 d. 3 Nov 1868
- 10 Frances Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.9]
b. 1847 d. 1850
- 10 Theodore Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.10]
b. 1849 d. 1850
- 10 William Thomas Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.7.1]
- 9 Sarah Sally Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.8]
b. 1805 d. Aft 1880
- 9 Nancy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.9]
b. 1807 d. 1891
- + James M Austin b. 1813 d. 18 Oct 1848
- + James M Austin b. 1813 d. 18 Oct 1848
- 9 Lucy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.10]
b. 1813
William Daugherty, Sr d. Abt 1839
- 10 William Daugherty, Jr [1.1.1.1.3.12.1.6.10.1]
b. Abt 1830
- 10 Benjamin Daugherty [1.1.1.1.3.12.1.6.10.2]
b. Abt 1830
- 10 William Daugherty, Jr [1.1.1.1.3.12.1.6.10.1]
- 9 Mary Ann Polly Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.6.1]
- 8 Marie Massie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.1.1]
- 7 Randall Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.2]
b. 1727 d. 15 Dec 1788
Sarah Nancy Richardson b. 1738 d. 18 Sep 1788
- 8 Rebecca Rountree [1.1.1.1.3.12.2.1]
b. 1753 d. 1798
Robert Wade b. 20 Jul 1755 d. Oct 1820
- 9 Benjamin Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.1]
b. 1780 d. 1850
Nancy Denny b. Abt 1781
- 10 Benjamin Cornelius Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.1.1]
b. 1836 d. 1915
Mary Elizabeth Wrenn b. Abt 1837
- 11 Nannie M Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.1.1.1]
b. 1866 d. 1949
Zachery Taylor Gentry b. Abt 1865
- 12 Hubert Bryce Gentry, Sr [1.1.1.1.3.12.2.1.1.1.1.1]
b. 1905 d. 1998 [ =>]
- 12 Hubert Bryce Gentry, Sr [1.1.1.1.3.12.2.1.1.1.1.1]
- 11 Nannie M Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.1.1.1]
- 10 Benjamin Cornelius Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.1.1]
- 9 John Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.2]
b. 1790 d. 1853
Polly King b. 1790 d. 1850
- 10 John Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.2.1]
b. 1819 d. 1903
Eliza A _____ b. 1825 d. 1902
- 11 Alford L Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.2.1.1]
b. 1851 d. 1918
- + Chloe Ann Craycraft b. 1857 d. 1928
- + Chloe Ann Craycraft b. 1857 d. 1928
- 11 Alford L Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.2.1.1]
- 10 John Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.2.1]
- 9 Benjamin Wade [1.1.1.1.3.12.2.1.1]
- 8 Randall Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.2.2]
b. 1758 d. 1837
- 8 Mary Rountree [1.1.1.1.3.12.2.3]
b. 14 Apr 1761 d. 10 May 1851
- + John Gordon b. 26 Sep 1763 d. 5 Feb 1839
- + John Gordon b. 26 Sep 1763 d. 5 Feb 1839
- 8 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.12.2.4]
b. 1762 d. Bef 18 Sep 1788
- + John Dennis b. Abt 1760
- + John Dennis b. Abt 1760
- 8 John Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5]
b. 1765 d. Bef Oct 1827
Lucinda Gordon b. 16 Jun 1767 d. 4 May 1853
- 9 Elizabeth Betsy Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.1]
b. 1787
- + Enoch Crim b. 1785 d. 1870
- + Enoch Crim b. 1785 d. 1870
- 9 Judith Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.2]
b. 9 Apr 1789 d. 31 May 1866
- + John B King b. 13 May 1783 d. 5 Jan 1859
- + John B King b. 13 May 1783 d. 5 Jan 1859
- 9 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.3]
b. 27 Sep 1791 d. 14 Sep 1872
- + Jesse Thomas b. 1780 d. 1844
- + Jesse Thomas b. 1780 d. 1844
- 9 Martha Patsy Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.4]
b. 1793 d. 1828
- + John Fleet b. Abt 1790
- + John Fleet b. Abt 1790
- 9 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.5]
b. 1795 d. 1864
Thacker Pendelton b. 1791 d. 1864
- 10 Mary Frances Pendelton [1.1.1.1.3.12.2.5.5.1]
b. 1830 d. Aft 1880
James M Crouch b. 1815 d. Abt 1866
- 11 Jonathan Crouch [1.1.1.1.3.12.2.5.5.1.1]
b. Feb 1844 d. 22 Jul 1933
Catherine Conley b. Abt 1845 d. Between 1870 and 1874
- 12 Sarah Ann Crouch [1.1.1.1.3.12.2.5.5.1.1.1]
b. 5 Apr 1868 d. 3 Nov 1925 [ =>]
- 12 Sarah Ann Crouch [1.1.1.1.3.12.2.5.5.1.1.1]
- + Martha Conley b. Abt 1856
- 11 Jonathan Crouch [1.1.1.1.3.12.2.5.5.1.1]
- 10 Mary Frances Pendelton [1.1.1.1.3.12.2.5.5.1]
- 9 Frances Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.6]
b. 1797
- + Laban Jones b. 1 Jan 1790 d. 14 Mar 1860
- + Laban Jones b. 1 Jan 1790 d. 14 Mar 1860
- 9 Sally Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.7]
b. 1799
- + Archibald Davenport b. 1792
- + Archibald Davenport b. 1792
- 9 Elizabeth Betsy Rountree [1.1.1.1.3.12.2.5.1]
- 8 Rebecca Rountree [1.1.1.1.3.12.2.1]
- 7 Dudley Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.3]
b. 2 Mar 1728 d. 26 Mar 1800
Susannah Roberts b. 28 Jan 1739
- 8 Samuel Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1]
b. 20 Oct 1756 d. 28 Sep 1805
Mary Polly Hughes b. 17 Jun 1754 d. 1 Aug 1835
- 9 Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1]
b. 5 Feb 1780 d. 14 Feb 1845
- 10 John I Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1]
b. 14 Feb 1834 d. 4 Nov 1884
Nancy Ellen Cannon b. 17 Jan 1836 d. 30 Nov 1916
- 11 Alice F Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.1]
b. 5 Feb 1858 d. 23 Jul 1931
- + G Porter Powell b. Mar 1842 d. 1904
- + G Porter Powell b. Mar 1842 d. 1904
- 11 Dudley Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.2]
b. 2 Oct 1859 d. 16 Jul 1906
- 11 Edward S Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.3]
b. 2 Oct 1859 d. 19 Nov 1939
Dora Winton Laughlin b. 15 Sep 1875 d. 14 Apr 1946
- 12 Earl Edward Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.3.1]
b. 28 Feb 1897 d. 28 Aug 1959 [ =>]
- 12 Ralph Shenault Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.3.2]
b. 11 Jun 1899 d. 30 Oct 1992
- 12 Sarah Elizabeth Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.3.3]
b. 23 Dec 1900 d. 25 Apr 1977
- 12 Winton Laughlin Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.3.4]
b. 18 Dec 1906 d. 27 Nov 1976 [ =>]
- 12 Earl Edward Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.3.1]
- 11 Lucas Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.4]
b. 1863
- 11 Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.5]
b. 1865
- 11 Charlie Bird Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.6]
b. 16 Dec 1867 d. 30 Oct 1953
Mildred J b. Jul 1867 d. Bef 1910
- 12 Carl Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.6.1]
b. 1902
- 12 Carl Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.6.1]
- 11 Ermine Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.7]
b. 1872
- + Robert Owens b. Abt 1868
- + Robert Owens b. Abt 1868
- 11 John Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.8]
b. 1874
- 11 Robert L Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.9]
b. 6 Nov 1876 d. 26 Aug 1964
Mary Lucile Shrock b. 10 Nov 1880 d. 16 Dec 1970
- 12 John Thomas Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.9.1]
b. 16 Jul 1905 d. 4 Dec 1963 [ =>]
- 12 Martha Ellen Rowntree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.9.2]
b. 16 Jul 1905 d. 16 Jan 1993
- 12 Robert Rowntree, Jr [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.9.3]
b. 29 Jan 1914 d. 22 Aug 1988 [ =>]
- 12 John Thomas Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.9.1]
- 11 Cathe L Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.10]
b. Jul 1880
- 11 Alice F Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1.1]
- 10 John I Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1.1]
- 9 Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1.1]
- 8 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.3.2]
b. Abt 1758 d. 1823
- + Blackmore Hughes b. 1742 d. 1810
- + Blackmore Hughes b. 1742 d. 1810
- 8 Nathaniel Rountree [1.1.1.1.3.12.3.3]
b. 16 May 1760 d. 1834
- + Elizabeth Worley b. 1760
- + Elizabeth Worley b. 1760
- 8 Mary Molly Rountree [1.1.1.1.3.12.3.4]
b. 1762 d. 30 Sep 1823
Stephen Turner b. 1750 d. 1800
- 9 Nancy Turner [1.1.1.1.3.12.3.4.1]
- 9 Susannah Turner [1.1.1.1.3.12.3.4.2]
b. 1795 d. Aft 1854
Alexander McKinney
- 10 Turner McKinney [1.1.1.1.3.12.3.4.2.1]
Nancy Ott
- 11 Eliza Jane McKinney [1.1.1.1.3.12.3.4.2.1.1]
b. 13 Apr 1844 d. 1932
Jared Crawford Stone b. 7 Mar 1840 d. 1925
- 12 Carrie Elizabeth Stone [1.1.1.1.3.12.3.4.2.1.1.1]
b. 1 Mar 1885 d. 19 Mar 1942 [ =>]
- 12 Carrie Elizabeth Stone [1.1.1.1.3.12.3.4.2.1.1.1]
- 11 Eliza Jane McKinney [1.1.1.1.3.12.3.4.2.1.1]
- 10 Turner McKinney [1.1.1.1.3.12.3.4.2.1]
- 9 Nancy Turner [1.1.1.1.3.12.3.4.1]
- 8 Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.3.5]
b. 1765 d. Abt 1784
- 8 Dudley Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.3.6]
b. 1768 d. 29 Nov 1839
Martha Richardson b. 10 Dec 1768
- 9 Turner Richardson Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1]
b. 18 Jan 1795 d. 21 Mar 1868
Mary Adeline Ferguson b. 1795 d. 11 Feb 1880
- 10 Perry Oliver Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1.1]
b. 12 Dec 1836 d. 13 Apr 1875
Sarah V Moore b. 1851 d. 1905
- 11 Glen Oliver Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1.1.1]
b. 12 Feb 1872 d. 10 Dec 1953
Alice Almeda Miller b. 5 Jun 1872 d. 20 Sep 1936
- 12 Bernice Olive Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1.1.1.1]
b. 5 Feb 1904 d. 30 May 1987 [ =>]
- 12 Bernice Olive Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1.1.1.1]
- 11 Glen Oliver Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1.1.1]
- 10 Perry Oliver Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1.1]
- 9 Elizabeth Betsy Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2]
b. 24 Aug 1798 d. 9 Mar 1884
George W Fitzhugh b. 1790 d. 17 Mar 1863
- 10 Martha Patsy Richardson Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.1]
b. 9 Feb 1818 d. 14 Feb 1901
John Wesley Kerby b. 1818
- 11 William D Kerby [1.1.1.1.3.12.3.6.2.1.1]
b. 1838
- 11 James G Kerby [1.1.1.1.3.12.3.6.2.1.2]
b. 1841
- 11 Francis Elizabeth Scott [1.1.1.1.3.12.3.6.2.1.3]
b. 6 Oct 1848 d. 19 Apr 1925
- 11 William D Kerby [1.1.1.1.3.12.3.6.2.1.1]
- 10 Mary Elizabeth Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.2]
b. 1819 d. 1897
- 10 Gabriel H Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.3]
b. 13 Feb 1827 d. 14 Nov 1888
- 10 Sarah Jane Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4]
b. 5 Dec 1829 d. 15 Jan 1914
James Madison Snider b. 2 Jun 1830 d. 21 Aug 1907
- 11 John P Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.1]
b. 24 Jan 1853 d. 24 Apr 1903
- 11 Mary E Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2]
b. 12 Mar 1855 d. 9 Apr 1898
Zachariah Taylor Coffey, IXfer) b. 20 Oct 1848 d. 21 Jun 1922
- 12 James A Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.1]
b. 12 Jan 1874 d. 14 Jan 1874
- 12 Atha Anna Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.2]
b. 28 Jul 1876 d. 1 Feb 1899
- 12 Lucy Jane Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.3]
b. 2 Dec 1878 d. 1 Aug 1962 [ =>]
- 12 Zilthai Ellen Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.4]
b. 22 Jan 1881 d. 9 Mar 1969
- 12 Salathiel Snider Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.5]
b. 15 Apr 1885 d. 31 Mar 1899
- 12 Josephine Alice Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.6]
b. 24 Aug 1887 d. 30 Jan 1975 [ =>]
- 12 Edith Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.7]
b. 22 Jul 1890 d. 20 Jul 1970
- 12 Myrtle Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.8]
b. 1893
- 12 Jesse Wolford Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.9]
b. 23 Jul 1895 d. 9 Jun 1944
- 12 James A Coffey [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.2.1]
- 11 Luticia Ann Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.3]
b. 1857 d. 1941
- + Jonathan B Spurgeon b. 1849 d. 1941
- + Jonathan B Spurgeon b. 1849 d. 1941
- 11 Martha Ellen Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.4]
b. 1862 d. 1948
- + William Wiley Wetsel b. 1855 d. 1940
- + William Wiley Wetsel b. 1855 d. 1940
- 11 James Harrison Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.5]
b. 20 Oct 1864 d. 10 Nov 1925
- 11 Gabriel Soloman Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.6]
b. 9 Apr 1867 d. 17 Feb 1942
- 11 Emma Catherine Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.7]
b. Abt 1870 d. 14 Mar 1959
William Simpson Orem b. 19 Oct 1863 d. 4 Aug 1933
- 12 J Alvin Orem [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.7.1]
b. Abt 1897
- 12 J Alvin Orem [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.7.1]
- 11 Susan Frances Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.8]
b. 30 Apr 1872 d. 9 May 1872
- 11 Missouri Jane Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.9]
b. 11 Nov 1873 d. 12 May 1963
- + Stokley T Armstrong b. 1873 d. 1951
- + Stokley T Armstrong b. 1873 d. 1951
- 11 John P Snider [1.1.1.1.3.12.3.6.2.4.1]
- 10 Francis Louisa Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5]
b. 22 Mar 1832 d. 13 Feb 1910
Voltaire R Rountree b. 3 Sep 1821 d. 3 Jan 1892
- 11 Ada S Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.1]
b. 17 Nov 1867 d. 23 Jul 1882
- 11 Ida Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.2]
b. 17 Nov 1867 d. 6 Sep 1937
- + Sterling Price Coffey b. 6 Jun 1862 d. 21 Sep 1944
- + Sterling Price Coffey b. 6 Jun 1862 d. 21 Sep 1944
- 11 Dudley Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.3]
b. 1 Feb 1869 d. 7 Mar 1923
Gertie England b. 1 Feb 1875 d. 22 May 1971
- 12 Ressie R Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.3.1]
b. 19 Aug 1894 d. 20 Sep 1986
- 12 Lela Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.3.2]
b. 25 Jan 1901 d. 27 Nov 1974
- 12 Ressie R Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.3.1]
- 11 Ada S Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.2.5.1]
- 10 Solomon Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.6]
b. 8 Aug 1834 d. 11 Jul 1916
- 10 Susan F Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.7]
b. 1837
- 10 Martha Patsy Richardson Fitzhugh [1.1.1.1.3.12.3.6.2.1]
- 9 Dudley R Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.3]
b. 1810 d. 1849
Frances _____ b. 1812
- 10 John Turner Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1]
b. 1844
Mary Jane Brown b. Dec 1851
- 11 Forest B Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.1]
b. Oct 1873
- 11 Ash Jehu Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.2]
b. 4 Oct 1879 d. 6 Feb 1961
Nellie L Roundtree b. 1887
- 12 Charles Leroy Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.2.1]
b. 3 Oct 1915 d. 5 Sep 1998 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.2.2]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.2.3]
- 12 Charles Leroy Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.2.1]
- 11 Lea R Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.3]
b. Jul 1882
- 11 Maggie A Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.4]
b. Oct 1891
- 11 Forest B Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1.1]
- 10 John Turner Roundtree [1.1.1.1.3.12.3.6.3.1]
- 9 James Harrison Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.4]
b. 1814 d. 25 Jan 1895
- 9 Turner Richardson Rountree [1.1.1.1.3.12.3.6.1]
- 8 Susannah Rountree [1.1.1.1.3.12.3.7]
b. 1772 d. 18 Sep 1853
- 8 Samuel Rountree [1.1.1.1.3.12.3.1]
- 7 William Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.4]
b. 1734 d. 1776
Jean Fenton b. Abt 1738
- 8 Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.4.1]
- 8 Samuel Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2]
Lucinda Tate b. 1760
- 9 Elisha T Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1]
b. 1787 d. 1842
Charlotte Marshall McQuinton
- 10 William Joseph Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1.1]
b. 1810 d. 1853
Marie Rosalee Maronge
- 11 Thomas Theophile Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1.1.1]
b. 1844 d. 1916
Euzelia Adelaide Marie Estivenne
- 12 Aubin Valmont Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1.1.1.1]
b. 1869 d. 1958 [ =>]
- 12 Aubin Valmont Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1.1.1.1]
- 11 Thomas Theophile Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1.1.1]
- 10 William Joseph Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1.1]
- 9 Elisha T Rountree [1.1.1.1.3.12.4.2.1]
- 8 Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.4.3]
- 8 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.4.4]
- 8 William Rountree, III [1.1.1.1.3.12.4.5]
b. 3 Jan 1763 d. 25 Feb 1852
- 8 Anna Rountree [1.1.1.1.3.12.4.6]
b. 1774 d. 1806
Stephen Johnson b. 1768 d. 1805
- 9 Fleming Carrinton Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1]
b. 1799 d. Sep 1860
Elizabeth J Watkins b. 25 Oct 1804 d. 4 Jun 1855
- 10 Thomas R Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1.1]
b. 1835 d. 9 Aug 1878
Martha Jane Johnson b. Apr 1830 d. 1909
- 11 Rufus Warrington Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1.1.1]
b. May 1862 d. 20 Dec 1913
Dora ELizaeth Eades b. Jul 1880 d. 4 Jun 1931
- 12 Bertha Mae Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1.1.1.1]
b. 24 Feb 1906 d. 28 Feb 1987 [ =>]
- 12 Bertha Mae Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1.1.1.1]
- 11 Rufus Warrington Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1.1.1]
- 10 Thomas R Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1.1]
- 9 Fleming Carrinton Johnson [1.1.1.1.3.12.4.6.1]
- 8 Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.4.1]
- 7 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.5]
b. 1740 d. 9 Aug 1783
Callum Bailey b. 1715 d. 8 Feb 1787
- 8 Nancy Bailey [1.1.1.1.3.12.5.1]
b. 12 Dec 1770 d. 1840
Allen Cambron b. 1746 d. Sep 1832
- 9 Henry Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1]
b. 1809 d. 22 Jul 1870
Sarah Casselgood b. 1820
- 10 Thomas Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.1]
b. 1831
- 10 Amanda Jane Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.2]
b. 1834
- 10 Joseph Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.3]
b. 1837
- 10 Jackson Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.4]
b. 1839
- 10 Sarah Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.5]
b. 1843
- 10 Mary Ann Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6]
b. 1844
Pvt William Bennett Malone b. 1839 d. 1873
- 11 John William Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1]
b. 14 Sep 1860 d. 14 Sep 1932
Martha Amanda Chappell b. 8 Aug 1852 d. 14 Jun 1927
- 12 Alonzo Columbus Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.1]
b. 14 May 1882 d. 16 Mar 1963
- 12 Angeline Ophelia Palmer [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.2]
b. 25 Aug 1883 d. 30 Jun 1967
- 12 Rose Ella Palmer [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.3]
b. 7 May 1885 d. 9 Oct 1959
- 12 Sallie Antine Forrister [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.4]
b. 20 Sep 1886 d. 26 Sep 1977
- 12 Mulice Melvina Pittman [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.5]
b. 1888 d. 1959
- 12 David Parks Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.6]
b. 14 Oct 1889 d. 10 Sep 1979
- 12 Martha Jane Peek [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.7]
b. 13 Dec 1891 d. 21 Oct 1985
- 12 Alonzo Columbus Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1.1]
- 11 Jane Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.2]
b. 1862
- 11 Bernett Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.3]
b. 1863
- 11 George W Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.4]
b. 1864
- 11 Frances Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.5]
b. 1866
- 11 Mary E Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.6]
b. 1870
- 11 Henry Nelson Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.7]
b. 6 Mar 1873 d. 17 Aug 1930
Susan Elvira Forrister b. 8 Jul 1873 d. 31 Oct 1942
- 12 Mary Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.7.1]
b. Apr 1896
- 12 Eunice Evie Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.7.2]
b. 9 Feb 1898 d. 11 Nov 1925 [ =>]
- 12 Alvin Henry Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.7.3]
b. 30 Sep 1903 d. 13 Feb 1988 [ =>]
- 12 Mary Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.7.1]
- 11 John William Malone [1.1.1.1.3.12.5.1.1.6.1]
- 10 Ephraim Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.7]
b. 1850
- 10 Eliza Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.8]
b. 1854
- 10 Thomas Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1.1]
- 9 Henry Cambron [1.1.1.1.3.12.5.1.1]
- 8 Nancy Bailey [1.1.1.1.3.12.5.1]
- 7 Turner Rountree [1.1.1.1.3.12.6]
b. 1742 d. 24 Dec 1797
Sarah Woodson b. 1744 d. Aft 1800
- 8 Sarah Sally Rountree [1.1.1.1.3.12.6.1]
b. 30 Dec 1769 d. Aug 1850
Henry Birdsong b. 30 Sep 1769 d. Aug 1850
- 9 William M Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1]
b. 1799 d. Aft 1860
- + Malinda Forth
Nancy Culp b. 1808 d. 1880
- 10 William Franklin Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1]
b. 19 Oct 1825 d. 6 Oct 1880
Charlotte Lottie Williams b. 4 May 1828 d. 2 Mar 1885
- 11 Mary Adelaide Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.1]
b. 29 Apr 1849 d. 1920
Taylor Morris b. Abt 1849
- 12 Almanna Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.1.1]
b. Abt 1868
- 12 Lee Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.1.2]
b. Abt 1870
- 12 Almanna Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.1.1]
- 11 Robert Lee Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.2]
b. 11 Nov 1864 d. 13 Dec 1903
Lucy Teague b. 16 Jun 1875 d. 6 Nov 1967
- 12 Robert Lee Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.2.1]
b. 1895 d. 1995 [ =>]
- 12 Robert Lee Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.2.1]
- 11 Josephine Catherine Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3]
b. 25 Jul 1869 d. 27 Sep 1927
George Barber Logsdon b. 4 Mar 1867 d. 13 Jun 1955
- 12 Myrtle Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.1]
b. 1892
- 12 Mary Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.2]
b. 1893
- 12 Lucy Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.3]
b. 1895
- 12 Jesse Bloomfield Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.4]
b. 25 Jun 1897 d. 30 Jul 1970 [ =>]
- 12 Mattie Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.5]
b. 1900
- 12 George Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.6]
b. 1904
- 12 Josie Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.7]
b. 1908
- 12 Maggie Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.8]
b. 1910
- 12 Myrtle Logsdon [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.3.1]
- 11 Mary Adelaide Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1.1]
- 10 John Calvin Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2]
b. 1833 d. 1865
Cornelia Ann Bivens b. 18 Nov 1837 d. 23 Nov 1907
- 11 Emma Augusta Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1]
b. 14 Mar 1861 d. 16 Jul 1920
William J Watt Morris b. Abt 1860
- 12 Anna Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.1]
b. 1882 d. 1884
- 12 Charles Benjamin Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.2]
b. 1885
- 12 Garrett Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.3]
b. 1886
- 12 Willie Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.4]
b. 1888
- 12 Joe W Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.5]
b. 1892
- 12 Watt Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.6]
b. 1896
- 12 Bertha Naomi Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.7]
b. 1896
- 12 Henry Washington Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.8]
b. 1896 d. 1965
- 12 Anna Morris [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1.1]
- 11 James Washington Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2]
b. 13 Jul 1867 d. 27 Oct 1950
Virginia Lee Lantrip b. 11 Dec 1868 d. 9 Nov 1906
- 12 William Allison Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.1]
b. 18 Nov 1891 d. 20 Feb 1975
- 12 Chester Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.2]
b. 4 Nov 1893 d. 3 Jun 1981
- 12 John Calvin Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.3]
b. 9 Sep 1895 d. 19 Aug 1981
- 12 Oliver Chilton Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.4]
b. 13 May 1898 d. 16 Apr 1977
- 12 Infant Son Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.5]
b. 1905 d. 1905
- 12 Cecil Harvey Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.6]
b. 9 Oct 1906 d. 18 Nov 1972
- 12 William Allison Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.2.1]
- 11 Emma Augusta Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.2.1]
- 10 Mariah Catherine Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.3]
b. 15 May 1836 d. 10 Feb 1911
- + George Washington Johnson b. 1835 d. 23 Dec 1911
- + George Washington Johnson b. 1835 d. 23 Dec 1911
- 10 Eliza Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.4]
b. 1838
- 10 Julia Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.5]
b. 1840
- 10 William Franklin Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1.1]
- + Malinda Forth
- 9 Elizabeth Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.2]
b. 1805 d. 1860
John Calvin May b. 1804 d. 1860
- 10 William Prather May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1]
b. Jan 1839 d. 1915
Cinthia W Key b. 12 Oct 1841 d. 22 Apr 1909
- 11 John M May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.1]
b. Nov 1858 d. 1933
- 11 Permelia Lucinda May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.2]
b. 23 Mar 1862 d. 11 Oct 1904
- + Raley b. Abt 1861
- + Raley b. Abt 1861
- 11 Calvin May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.3]
b. 12 Jul 1865 d. 20 Jun 1941
Elizabeth Lillie Jane Williams b. 22 May 1870 d. 16 Nov 1931
- 12 Viola Mabel May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.3.1]
b. 24 Nov 1899 d. 18 Feb 1991 [ =>]
- 12 Viola Mabel May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.3.1]
- 11 Viola Cecilia May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.4]
b. 7 May 1868 d. 27 Dec 1932
William Johnston Mahan b. 2 May 1856 d. 23 Aug 1941
- 12 Otis Fred Mahan [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.4.1]
b. 23 May 1886 d. 16 Feb 1958 [ =>]
- 12 Otis Fred Mahan [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.4.1]
- 11 Ida May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.5]
b. 1 Feb 1871 d. 19 Apr 1910
- 11 Mary M May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.6]
b. 18 Mar 1873 d. 9 May 1913
- 11 Nancy C May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.7]
b. 18 Mar 1873 d. 29 Dec 1945
- + McCammon b. Abt 1872
- + McCammon b. Abt 1872
- 11 Elbert May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.8]
b. 12 Jul 1875 d. 9 Sep 1933
- 11 Oscar Bertrum May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.9]
b. 8 May 1882 d. 16 Aug 1964
- 11 John M May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1.1]
- 10 William Prather May [1.1.1.1.3.12.6.1.2.1]
- 9 Miles Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3]
b. 1808
Patsy Wilson b. 1811 d. 1851
- 10 Ewing Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1]
b. 21 Nov 1827 d. 21 May 1900
Mary Angela Johnson b. 1827
- 11 Nancy E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.1]
b. 1855
- 11 Columbus M Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.2]
b. 1856
- 11 Martha E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.3]
b. 1858
- 11 Julettia A Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.4]
b. 1863
- 11 Sarah A Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.5]
b. 1865
- 11 James Warren Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6]
b. 1867
Liffie Elner Lefors b. 1864
- 12 William R Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.1]
b. 1889
- 12 Nora E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.2]
b. 1891
- 12 Columbus C Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.3]
b. 1893
- 12 German Jody Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.4]
b. 1895
- 12 Beuna V Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.5]
b. 1896
- 12 Jewel B Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.6]
b. 1900
- 12 Charlie D Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.7]
b. 1901
- 12 Bulah Ethel Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.8]
b. 14 Mar 1903 d. 4 Jul 1999 [ =>]
- 12 Gena B Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.9]
b. 1905
- 12 William R Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.6.1]
- 11 Nancy E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1.1]
- 10 Ewing Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.3.1]
- 9 Harvey Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4]
b. 1812 d. 1880
Julia Frances Culp b. 1817
- 10 Malvina Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.1]
b. 1835
- 10 John C Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2]
b. 1837 d. 1910
Anna Eliza Cail b. 1844
- 11 John Ervin Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1]
b. Jul 1861 d. 16 Mar 1945
Elizabeth Jennie Goats b. 28 Feb 1862 d. 1 Mar 1899
- 12 May E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.1]
b. Jun 1884
- 12 Lena Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.2]
b. Oct 1887
- 12 Sula Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.3]
b. Nov 1888
- 12 Willie C Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.4]
b. Oct 1889
- 12 David E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.5]
b. Dec 1890
- 12 Lillian Eaton Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.6]
b. 27 Feb 1893 d. 9 Sep 1967 [ =>]
- 12 Eff W Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.7]
b. Oct 1895
- 12 Nellie Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.8]
b. Oct 1898
- 12 May E Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1.1]
- 11 Andrew Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.2]
b. 1863
- 11 Mary Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.3]
b. 1866
- 11 John Ervin Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.2.1]
- 10 Miledge F Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.3]
b. 1839
- 10 Mary F Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.4]
b. 1842
- 10 Eliza Ann Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.5]
b. 1843
- 10 William H Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.6]
b. 1846
- 10 Sarah S Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.7]
b. 1848
- 10 Amanda Jane Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.8]
b. 1851
- 10 Catharine Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.9]
b. 1852
- 10 James A Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.10]
b. 1856
- 10 Malvina Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.4.1]
- 9 William M Birdsong [1.1.1.1.3.12.6.1.1]
- 8 Woodson Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2]
b. 30 Dec 1769 d. Dec 1849
Jane Brandon b. 1783 d. Dec 1850
- 9 Thomas Brandon Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.1]
b. 1793 d. 1874
Aphra Fowler
- 10 Eliza Vitura Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.1.1]
b. 1828 d. 1893
- + Thomas Joyner Abston b. 1820 d. 1911
- + Thomas Joyner Abston b. 1820 d. 1911
- 10 Nancy Oliva Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.1.2]
b. 1830
John Peace LeMay
- 11 Harriet Ann LeMay [1.1.1.1.3.12.6.2.1.2.1]
b. 1849
Winfield Scott Nichols
- 12 Lilian Vitura Nichols [1.1.1.1.3.12.6.2.1.2.1.1]
b. 1869
- 12 Lilian Vitura Nichols [1.1.1.1.3.12.6.2.1.2.1.1]
- 11 Harriet Ann LeMay [1.1.1.1.3.12.6.2.1.2.1]
- 10 Eliza Vitura Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.1.1]
- 9 James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2]
b. 1799
- 10 James Woodson Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1]
b. 14 Feb 1820 d. 18 Apr 1905
Mary Elizabeth Burns b. Feb 1819 d. 1914
- 11 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1]
b. 1844 d. 1899
Georgiana May McLendon b. Mar 1857 d. 23 Apr 1909
- 12 Jesse James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1.1]
b. 1 May 1885 d. 24 Jun 1939 [ =>]
- 12 Virginia Jennie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1.2]
b. Aug 1890 [ =>]
- 12 Andrew Lawrence Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1.3]
b. 11 Aug 1891 d. 6 Aug 1969 [ =>]
- 12 Woodson Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1.4]
b. Oct 1892
- 12 Melvin Lenard Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1.5]
b. 16 Nov 1895 d. 2 Nov 1953 [ =>]
- 12 Jesse James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1.1]
- 11 Thomas B Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.2]
b. 1 May 1846 d. 15 Dec 1932
- 11 Benjamin Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.3]
b. 1 Feb 1848 d. 4 Jul 1921
Nancy Elizabeth McWilliams b. 1842 d. 10 Jun 1886
- 12 Mary Kezia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.3.1]
b. 7 Aug 1871 d. 21 Dec 1933
- 12 James Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.3.2]
b. 14 Oct 1873 d. 22 Jul 1958 [ =>]
- 12 Kader W Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.3.3]
b. 1876
- 12 Mary Kezia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.3.1]
- 11 Joseph M Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.4]
b. 14 Apr 1850 d. 12 Apr 1896
Narcissa Davenport Daniels b. 10 Dec 1853 d. 22 Nov 1954
- 12 Joseph L. Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.4.1]
b. 20 Aug 1876 d. 11 Feb 1961
- 12 William Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.4.2]
b. 20 Aug 1876 d. 29 Sep 1960
- 12 Robert Aaron Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.4.3]
b. 29 May 1888 d. 11 Aug 1966
- 12 Joseph L. Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.4.1]
- 11 James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.5]
b. Nov 1853
- 11 Nancy A Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.6]
b. Nov 1853
- + William Wilson b. May 1856
- + William Wilson b. May 1856
- 11 John Wesley Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7]
b. 22 May 1855 d. 17 Aug 1934
Nancy Elizabeth Evans b. Nov 1855 d. 25 Aug 1938
- 12 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.1]
b. 12 Aug 1875 d. 23 Jan 1945
- 12 Lethia Ellen Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.2]
b. Abt 1878 d. 25 Jun 1956
- 12 James Y Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.3]
b. Abt 1879
- 12 Jesse Turner Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.4]
b. 24 Sep 1881 d. 29 Sep 1965
- 12 William Jubith Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.5]
b. 31 Jan 1884 d. 24 Jul 1964 [ =>]
- 12 Louvenia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.6]
b. Feb 1889 d. 25 Sep 1957
- 12 Joseph Neville Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.7]
b. 15 Oct 1893 d. 5 Jun 1966
- 12 Thomas B Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.8]
b. 7 Apr 1898 d. 7 Jul 1967
- 12 David Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.9]
b. 23 Jan 1902 d. 27 Apr 1970
- 12 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.7.1]
- 11 Lizzie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.8]
b. 1858
- 11 Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.9]
b. 1865
- 11 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1.1]
- 10 James Woodson Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.2.1]
- 9 Robert Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3]
b. 1800 d. Aft 1860
- 10 Asa W Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1]
b. Abt 1820 d. 1880
- + Mary Ann Knight
Harriett Elizabeth Carmichael b. 1810
- 11 Emeline Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1.1]
b. 1841
- 11 Alabama Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1.2]
b. 1843
- 11 Aphra Ann Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1.3]
b. 1845
- + Bluford Alexander Sharp b. 4 Sep 1840 d. 31 Mar 1917
- + Bluford Alexander Sharp b. 4 Sep 1840 d. 31 Mar 1917
- 11 Narcissa Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1.4]
b. 1847
- 11 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1.5]
b. 1848
- 11 Emeline Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1.1]
- + Mary Ann Knight
- 10 Asa W Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.3.1]
- 9 Benjamin Woodson Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.6.2.4]
b. 1809 d. 1873
Amanda Mandy Young b. 1823
- 10 Docksy A Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.1]
b. 1857
- 10 Missouri J Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.2]
b. 1858
- 10 Robert Young Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.3]
b. 16 Feb 1860 d. 23 Apr 1942
Eva May Wise Finley b. 1884
- 10 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.4]
b. 1862
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.5]
b. 1864
- 10 Benjamin Woodson Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6]
b. 23 Mar 1866 d. 15 Sep 1940
Ella Dee b. 12 Dec 1874 d. 24 Oct 1944
- 11 Virginia Y Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.1]
b. 1903
- 11 Wallace W Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.2]
b. 1904
- 11 Robert W Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.3]
b. 1906
- 11 Russell G Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.4]
b. 1908
- 11 John D Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.5]
b. 2 Oct 1908 d. 19 Dec 1942
- 11 James Monroe Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.6]
b. 5 Mar 1910 d. 23 Jan 1981
- + Melba b. 9 Mar 1924 d. 16 May 1984
- + Melba b. 9 Mar 1924 d. 16 May 1984
- 11 Erma J Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.7]
b. 1913
- 11 Sam Moss Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.8]
b. 14 Jul 1916 d. 12 Jan 1989
- + Eva Mae
- + Eva Mae
- 11 Virginia Y Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.6.1]
- 10 Emily Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.7]
b. 1869
- + Johnson b. Abt 1868
- + Johnson b. Abt 1868
- 10 Docksy A Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.4.1]
- 9 James Woodson Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5]
b. 14 Feb 1820 d. 18 Apr 1905
Mary Elizabeth Burns b. Feb 1819 d. 1914
- 10 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1]
b. 1844 d. 1899
Georgiana May McLendon b. Mar 1857 d. 23 Apr 1909
- 11 Jesse James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1]
b. 1 May 1885 d. 24 Jun 1939
Willie Mae Stevens b. 7 Jan 1885 d. 15 Jul 1971
- 12 Ernest Leonard Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.1]
b. 28 Jan 1905 d. 14 Jun 1974
- 12 William Marvin Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.2]
b. 14 Sep 1906 d. 1 Apr 1972 [ =>]
- 12 Jessie Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.3]
b. 23 Dec 1908 d. 12 Jul 1992
- 12 James Val Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.4]
b. 11 Nov 1910 d. 6 Jan 1934
- 12 L C Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.5]
b. 10 Oct 1913 d. 7 Jan 1995 [ =>]
- 12 Garland B Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.6]
b. 22 Jul 1915 d. 24 Feb 1979 [ =>]
- 12 Clara Emogene Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.7]
b. 6 Dec 1918 d. 30 May 2002
- 12 Gracie Alice Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.8]
b. 9 Apr 1921 d. 9 Oct 1974
- 12 Ernest Leonard Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1.1]
- 11 Virginia Jennie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.2]
b. Aug 1890
Ivey Carter b. 1885
- 12 Bessie Carter [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.2.1]
b. 1910
- 12 Irine Carter [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.2.2]
b. 1913
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.2.3]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.2.4]
- 12 Bessie Carter [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.2.1]
- 11 Andrew Lawrence Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3]
b. 11 Aug 1891 d. 6 Aug 1969
Ila Florence Moody b. 8 Nov 1898 d. 7 Mar 1988
- 12 Elsie Aline Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.1]
b. 19 Jul 1918 d. 17 Mar 2005
- 12 Raymond Leslie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.2]
b. 2 Dec 1921 d. 15 Dec 1995
- 12 Georgia Marie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.3]
b. 27 Jan 1922 d. 18 Dec 2003
- 12 Reta Fay Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.4]
b. 26 Feb 1924 d. 28 Feb 1986 [ =>]
- 12 Andrew Lawrence Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.5]
b. 25 Sep 1927 d. 9 Jun 1977
- 12 Coy Eugene Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.6]
b. 25 Sep 1927 d. 28 Sep 1995
- 12 Elsie Aline Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.3.1]
- 11 Woodson Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.4]
b. Oct 1892
- 11 Melvin Lenard Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.5]
b. 16 Nov 1895 d. 2 Nov 1953
Cumi Z Rutherford b. 23 Aug 1899 d. 26 Aug 1986
- 12 Algie Oliver Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.5.1]
b. 5 May 1917 d. 11 Oct 1991
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.5.2]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.5.3]
- 12 Algie Oliver Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.5.1]
- 11 Jesse James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1.1]
- 10 Thomas B Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.2]
b. 1 May 1846 d. 15 Dec 1932
- 10 Benjamin Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3]
b. 1 Feb 1848 d. 4 Jul 1921
Nancy Elizabeth McWilliams b. 1842 d. 10 Jun 1886
- 11 Mary Kezia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.1]
b. 7 Aug 1871 d. 21 Dec 1933
- + Samuel L Flowers b. 1867 d. 1958
- + Jonathan Hardy Eason b. 24 Jul 1875 d. 23 Jan 1960
- + Samuel L Flowers b. 1867 d. 1958
- 11 James Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2]
b. 14 Oct 1873 d. 22 Jul 1958
Oreally Doucette b. 18 Jan 1876 d. 23 Mar 1953
- 12 John D Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2.1]
b. 2 Jan 1903
- 12 Hettie Alma Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2.2]
b. 22 Jun 1905 d. 13 Feb 1997
- 12 Nettie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2.3]
b. 5 Jan 1910 d. Apr 1985
- 12 Benjamin Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2.4]
b. 1 Sep 1912 d. 4 Apr 1997
- 12 Edgar Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2.5]
b. 4 Dec 1914 d. 12 Apr 2001 [ =>]
- 12 John D Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.2.1]
- 11 Kader W Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.3]
b. 1876
- 11 Mary Kezia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.3.1]
- 10 Joseph M Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.4]
b. 14 Apr 1850 d. 12 Apr 1896
Narcissa Davenport Daniels b. 10 Dec 1853 d. 22 Nov 1954
- 11 Joseph L. Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.4.1]
b. 20 Aug 1876 d. 11 Feb 1961
- 11 William Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.4.2]
b. 20 Aug 1876 d. 29 Sep 1960
- 11 Robert Aaron Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.4.3]
b. 29 May 1888 d. 11 Aug 1966
- 11 Joseph L. Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.4.1]
- 10 James Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.5]
b. Nov 1853
- 10 Nancy A Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.6]
b. Nov 1853
- + William Wilson b. May 1856
- + William Wilson b. May 1856
- 10 John Wesley Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7]
b. 22 May 1855 d. 17 Aug 1934
Nancy Elizabeth Evans b. Nov 1855 d. 25 Aug 1938
- 11 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.1]
b. 12 Aug 1875 d. 23 Jan 1945
- + Issac Jackson Flowers b. 15 Dec 1862 d. 22 Feb 1916
- + Issac Jackson Flowers b. 15 Dec 1862 d. 22 Feb 1916
- 11 Lethia Ellen Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.2]
b. Abt 1878 d. 25 Jun 1956
- + Josiah Littleton Flower b. 2 Jan 1869 d. 12 May 1948
- + Josiah Littleton Flower b. 2 Jan 1869 d. 12 May 1948
- 11 James Y Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.3]
b. Abt 1879
- 11 Jesse Turner Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.4]
b. 24 Sep 1881 d. 29 Sep 1965
- 11 William Jubith Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.5]
b. 31 Jan 1884 d. 24 Jul 1964
Callie Young b. 28 Oct 1888 d. 3 May 1976
- 12 Bessie Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.5.1]
b. 26 Jun 1910 d. 16 Jul 2003
- 12 Nancy Eugenia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.5.2]
b. 13 Jan 1913 d. 7 Jul 1989
- 12 Alma Evelyn Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.5.3]
b. 16 Mar 1920 d. 23 Jan 1996 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.5.4]
- 12 Bessie Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.5.1]
- 11 Louvenia Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.6]
b. Feb 1889 d. 25 Sep 1957
- + Charles Roberts b. Abt 1886
- + Charles Roberts b. Abt 1886
- 11 Joseph Neville Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.7]
b. 15 Oct 1893 d. 5 Jun 1966
- + Nida b. Abt 1892
- + Nida b. Abt 1892
- 11 Thomas B Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.8]
b. 7 Apr 1898 d. 7 Jul 1967
- + Catherine b. 19 Aug 1898 d. 9 Aug 1993
- + Catherine b. 19 Aug 1898 d. 9 Aug 1993
- 11 David Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.9]
b. 23 Jan 1902 d. 27 Apr 1970
- + Cleone Brady b. 3 Nov 1902 d. 28 Sep 2000
- + Cleone Brady b. 3 Nov 1902 d. 28 Sep 2000
- 11 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.7.1]
- 10 Lizzie Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.8]
b. 1858
- 10 Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.9]
b. 1865
- 10 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.5.1]
- 9 Thomas Brandon Rountree [1.1.1.1.3.12.6.2.1]
- 8 Molly Ann Rountree [1.1.1.1.3.12.6.3]
b. 23 Aug 1771 d. 28 Mar 1856
Thomas Blassingame b. 1766 d. 1804
- 9 Elizabeth Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.1]
b. 1795 d. 1862
- + Nathan Byers b. 1795 d. 1860
- + Nathan Byers b. 1795 d. 1860
- 9 Jesse Augustus Blassingame, Sr [1.1.1.1.3.12.6.3.2]
b. 1796 d. 20 Jan 1855
Mary Polly Walker b. 1801 d. 15 Aug 1849
- 10 Mahala Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.1]
b. 1819 d. 4 Sep 1842
William L Walker b. 1805 d. 1850
- 11 John Freeman Walker [1.1.1.1.3.12.6.3.2.1.1]
b. 24 Jun 1836 d. 27 Nov 1897
Elizabeth E James b. 1844
- 12 Mary Etta Walker [1.1.1.1.3.12.6.3.2.1.1.1]
b. 17 Aug 1875 d. 27 Jul 1954 [ =>]
- 12 Mary Etta Walker [1.1.1.1.3.12.6.3.2.1.1.1]
- 11 John Freeman Walker [1.1.1.1.3.12.6.3.2.1.1]
- 10 Wiliam Alexander Blassingame, Sr [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2]
b. 24 Apr 1822 d. 27 Sep 1899
Martha Phillips b. 10 Mar 1822 d. 17 May 1901
- 11 Monroe Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.1]
b. 1844
- 11 William Alexander Blassingame, Jr [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.2]
b. 25 Dec 1845 d. 30 Jan 1909
Mattie L. Toole b. 19 Feb 1848 d. 19 Dec 1882
- 12 Infant of Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.2.1]
b. 27 Jun 1883 d. 27 Jun 1883
- 12 Cora Lee Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.2.2]
b. 7 Jul 1887 d. 4 Oct 1888
- 12 Infant of Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.2.1]
- 11 Mary A Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.3]
b. 1847
- 11 Mary Ann Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.4]
b. 10 Nov 1847 d. 14 Jan 1918
George Washington Grace b. 6 Feb 1830 d. 2 Nov 1901
- 12 Daisy Pearl Grace [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.4.1]
b. 20 Jun 1882 d. 19 Nov 1950 [ =>]
- 12 Bertha Dale Grace [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.4.2]
b. 23 Jun 1884 d. 4 Nov 1931 [ =>]
- 12 Albert Thomas Grace, I [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.4.3]
b. 9 Apr 1887 d. 24 Jan 1963 [ =>]
- 12 Daisy Pearl Grace [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.4.1]
- 11 Martha Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.5]
b. 1856
- 11 Monroe Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.2.1]
- 10 Jesse Augustus Blassingame, Jr [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3]
b. 28 Apr 1826 d. 10 Apr 1887
Mary Jane Ogle b. 27 Feb 1836 d. 29 Apr 1908
- 11 Alfred Harding Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.1]
b. 28 Dec 1854 d. 25 Sep 1928
Harriet S Cole b. 1873 d. 1948
- 12 Kate C Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.1.1]
b. 20 Oct 1916 d. 21 Sep 2010 [ =>]
- 12 Kate C Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.1.1]
- 11 Albert Anderson Blasingame, Sr [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.2]
b. 12 Jan 1858 d. 28 Feb 1923
- 11 Lee Augustus Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.3]
b. 1861 d. 24 Dec 1936
- 11 Nancy Sophronia Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.4]
b. 22 Mar 1865 d. 8 Nov 1920
- + Peterson b. Abt 1864
- + Peterson b. Abt 1864
- 11 Mary E Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.5]
b. 25 Dec 1868 d. 12 Jan 1869
- 11 Johnnad A Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.6]
b. 27 Nov 1872 d. 17 Jan 1875
- 11 William Ogle Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.7]
b. 11 Nov 1875 d. 21 Oct 1953
- 11 Jesse Augustus Blassingame, III [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.8]
b. 24 Jun 1877 d. 15 Jul 1931
- 11 Gertrude B Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.9]
b. 1880 d. 13 Nov 1923
- + Aten b. Abt 1879
- + Aten b. Abt 1879
- 11 Alfred Harding Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.3.1]
- 10 Elizabeth Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.4]
b. 1828 d. 1860
James M Harris b. 1814 d. 1860
- 11 Archibald B Harris [1.1.1.1.3.12.6.3.2.4.1]
b. 1849 d. 1920
Martha Colville b. 1858 d. 1946
- 12 Dora Harris [1.1.1.1.3.12.6.3.2.4.1.1]
b. 1896 d. 1985 [ =>]
- 12 Dora Harris [1.1.1.1.3.12.6.3.2.4.1.1]
- 11 Archibald B Harris [1.1.1.1.3.12.6.3.2.4.1]
- 10 Sarah Jane Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5]
b. 1837 d. Aft 1880
George Washington Elrod b. 1832 d. Aft 1880
- 11 Samuel Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.1]
b. 28 Nov 1871 d. 9 Apr 1925
Lucy Ward b. 8 Jul 1876 d. 11 Jul 1926
- 12 Newel Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.1.1]
b. 3 Mar 1896 d. May 1955 [ =>]
- 12 Newel Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.1.1]
- 11 Robert Lee Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.2]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Dec 1935
Mittie Mae Hanna
- 12 Virginia Velma Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.2.1]
b. 18 Jan 1904 d. 13 Dec 1977 [ =>]
- 12 Virginia Velma Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.2.1]
- 11 Samuel Elrod [1.1.1.1.3.12.6.3.2.5.1]
- 10 Mary Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.6]
b. 1840
- 10 Diana Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.7]
b. May 1845 d. 22 Sep 1904
- + Lewis Watson Harrison b. Oct 1839 d. 27 Dec 1929
- + Lewis Watson Harrison b. Oct 1839 d. 27 Dec 1929
- 10 Missouri Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.8]
b. 1846
- 10 Mahala Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.2.1]
- + Lucinda Glasscock b. Abt 1811 d. 1880
- 9 Benjamin Franklin Blassingame, Sr [1.1.1.1.3.12.6.3.3]
b. Abt 1797 d. 26 Dec 1880
Elizabeth Jane Musick b. 1807 d. 1880
- 10 Benjamin Franklin Blassingame, Jr [1.1.1.1.3.12.6.3.3.1]
b. 8 Jul 1829 d. 14 Feb 1891
Sarah Jane Treadwell b. 10 Jan 1831 d. 13 Jan 1885
- 11 Rusk Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.3.1.1]
b. 8 Jul 1857 d. 27 Apr 1898
Martha Eugnie Pittman b. 17 Aug 1863 d. 20 Dec 1930
- 12 Franklin Rusk Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.3.1.1.1]
b. 23 Aug 1894 d. 26 Oct 1956 [ =>]
- 12 Franklin Rusk Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.3.1.1.1]
- 11 Rusk Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.3.1.1]
- 10 Benjamin Franklin Blassingame, Jr [1.1.1.1.3.12.6.3.3.1]
- 9 Woodson Martin Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.4]
b. 1798 d. 14 Apr 1856
Mary b. Sep 1806 d. 28 Feb 1866
- 10 Katherine Martha Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1]
b. 3 Dec 1825 d. 12 Apr 1881
William Henderson Fikes b. 19 Nov 1819 d. 19 Nov 1894
- 11 Christopher Columbus Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.1]
b. 12 Mar 1847 d. 8 Mar 1881
Mary Wade Barrett
- 12 Benjamin Monroe Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.1.1]
b. 14 Jul 1872 d. 13 Aug 1969 [ =>]
- 12 Benjamin Monroe Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.1.1]
- 11 Calvin Henderson Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.2]
b. 19 Aug 1853 d. 22 Apr 1944
Martha Morris
- 12 Marion Monroe Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.2.1]
b. 26 Mar 1879 d. 1 May 1940 [ =>]
- 12 Marion Monroe Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.2.1]
- 11 John Woodson Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.3]
b. 28 Dec 1860 d. 30 Apr 1954
Belle Hermon b. 28 Dec 1871 d. Oct 1900
- 12 Madeline Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.3.1]
b. 31 Aug 1890 d. 9 Jul 1969 [ =>]
- 12 Madeline Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.3.1]
- 11 Christopher Columbus Fikes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1.1]
- 10 Frances J Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.4.2]
b. May 1837 d. 25 Oct 1928
William Kendrick Holmes b. 2 Nov 1826 d. 1 May 1910
- 11 William Woodson Holmes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.2.1]
b. 9 Mar 1862 d. 30 Jan 1934
Mary Ella Harris b. 9 Mar 1874 d. 30 May 1958
- 12 Velma L Holmes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.2.1.1]
b. 1912
- 12 Carey Woodard Holmes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.2.1.2]
b. 21 Sep 1914 d. 11 Nov 1993 [ =>]
- 12 Velma L Holmes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.2.1.1]
- 11 William Woodson Holmes [1.1.1.1.3.12.6.3.4.2.1]
- 10 Katherine Martha Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.4.1]
- 9 Sally R Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.5]
b. 1800 d. Bef 1840
Stokely Donelson Massengale b. 1796 d. Bef 1850
- 10 Elzira Massengale [1.1.1.1.3.12.6.3.5.1]
b. 19 Mar 1832 d. Abt 1881
George C Jenkins b. 23 Jul 1830 d. 16 Jul 1905
- 11 William Austin Jenkins [1.1.1.1.3.12.6.3.5.1.1]
b. 28 Aug 1854 d. 24 Mar 1947
Missouri Aldora Usry b. 9 Jan 1852 d. 22 Jun 1915
- 12 James Ovel Jenkins [1.1.1.1.3.12.6.3.5.1.1.1]
b. 16 May 1890 d. 19 Dec 1961 [ =>]
- 12 James Ovel Jenkins [1.1.1.1.3.12.6.3.5.1.1.1]
- 11 William Austin Jenkins [1.1.1.1.3.12.6.3.5.1.1]
- 10 Elzira Massengale [1.1.1.1.3.12.6.3.5.1]
- 9 Thomas Jefferson Blasingame, Sr [1.1.1.1.3.12.6.3.6]
b. 1805 d. 1880
Jane Emily Musick b. 1810 d. 1880
- 10 Margaret A Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.1]
b. 1830
- 10 Elvira Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.2]
b. 1832
- 10 Elmira Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.3]
b. 1835
- 10 Noah T Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.4]
b. 1838
- 10 Algeline Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.5]
b. 1840
- 10 George W Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.6]
b. 1844
- 10 Frances Elizabeth Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7]
b. 2 Dec 1848 d. 6 Oct 1921
Charles Emile Holst b. 18 Feb 1850 d. 22 Apr 1927
- 11 James E Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.1]
b. Jan 1877
- 11 Willie O Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.2]
b. Aug 1878
- 11 Marvin E Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.3]
b. Sep 1882
- 11 Frances L Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.4]
b. Oct 1885
- 11 Ema J Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.5]
b. Feb 1886
- 11 Otelious Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6]
b. 7 Aug 1889 d. 5 Dec 1970
Martha Alene Elmore b. 29 May 1890 d. 24 Apr 1953
- 12 Mabel Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.1]
b. 30 Apr 1910 d. 6 Feb 1993
- 12 Fay Marjorie Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.2]
b. 25 Feb 1913 d. 6 Oct 2001
- 12 Alene Otelious Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.3]
b. 4 Feb 1917 d. 23 Nov 1998 [ =>]
- 12 Charles Elmore Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.4]
b. 6 Nov 1919 d. 6 Sep 1984 [ =>]
- 12 Brice Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.5]
b. 29 Jan 1922 d. 29 Jan 1922
- 12 William John M Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.6]
b. 12 Dec 1924 d. 4 Jan 1925
- 12 Stella Virginia Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.7]
b. 16 Jan 1927 d. 28 Apr 2013 [ =>]
- 12 Mabel Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.6.1]
- 11 James E Holst [1.1.1.1.3.12.6.3.6.7.1]
- 10 Thomas Jefferson Blasingame, Jr [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8]
b. 1 Nov 1853 d. 28 Feb 1934
Emily Viola Williamson b. 21 Jan 1862 d. 1 Nov 1933
- 11 James Daniel Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.1]
b. 28 Dec 1880 d. 4 Apr 1915
Lyda Clemtine Carter b. 7 Mar 1885 d. 2 Sep 1959
- 12 George Waye Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.1.1]
b. 4 Apr 1911 d. 15 Jan 1984 [ =>]
- 12 George Waye Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.1.1]
- 11 Newton Alvin Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.2]
b. 5 Aug 1887 d. 16 Jun 1965
Esther May Winn b. 26 Jun 1891 d. 14 Oct 1980
- 12 Rex Alwyn Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.2.1]
b. 21 Apr 1919 d. 4 Jun 1973 [ =>]
- 12 Rex Alwyn Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.2.1]
- 11 James Daniel Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.8.1]
- 10 Margaret A Blasingame [1.1.1.1.3.12.6.3.6.1]
- 9 Elizabeth Blassingame [1.1.1.1.3.12.6.3.1]
- + Larkin Venable b. 18 Sep 1771 d. 28 Mar 1835
- 8 William Rountree [1.1.1.1.3.12.6.4]
b. 1780 d. 1835
- 8 Sarah Sally Rountree [1.1.1.1.3.12.6.1]
- 7 Richardson Rountree [1.1.1.1.3.12.7]
b. 1745 d. 20 Mar 1819
Matilda Anderson b. Abt 1746
- 8 James Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1]
b. 1761 d. 8 Nov 1848
Nancy Stevens b. 1764 d. 1835
- 9 William H Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1]
b. 13 Feb 1784 d. 1877
Kesiah Gaston b. 1793 d. 1877
- 10 Reverend Robert L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1]
b. 14 May 1810 d. 18 Feb 1899
Sarah Griffin b. 1818
- 11 Sylvester G Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.1]
b. 12 Jun 1835 d. 10 Jul 1835
- 11 Thomas W Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.2]
b. 10 Sep 1837 d. 28 Oct 1860
Elizabeth Elender Smith b. 10 Apr 1840
- 12 Sallie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.2.1]
b. 1861
- 12 Sallie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.2.1]
- 11 Robert Duskin Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3]
b. 25 Jul 1840 d. 14 Jan 1922
Rebecca Lou Lane b. 20 Dec 1846 d. 22 Nov 1910
- 12 Robert Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3.1]
b. Jul 1870
- 12 Mary B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3.2]
b. 1871
- 12 John Britton Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3.3]
b. 4 Apr 1874 d. 30 Jan 1934 [ =>]
- 12 Sam Houston Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3.4]
b. 2 Jul 1876 [ =>]
- 12 Kerrie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3.5]
b. 1879
- 12 Robert Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.3.1]
- 11 Samuel D Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.4]
b. 5 May 1843 d. 5 Aug 1862
- 11 Mary P Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.5]
b. 2 Oct 1846
- 11 William Fowler Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6]
b. 10 Jun 1849 d. 7 Aug 1923
Florence Lester b. 1852
- 12 Ida Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.1]
b. 4 Dec 1870
- 12 Robert L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.2]
b. 1872 [ =>]
- 12 Ida Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.1]
- + Maria V George b. Abt 1855
Melissa Warren b. 1857 d. 1932
- 12 Edward Neal Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.3]
b. 19 Nov 1876
- 12 Edward Neal Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.3]
Mary Ellen Hassell b. Feb 1850
- 12 Mary Etta Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.4]
b. 16 Nov 1877 d. 13 Dec 1968 [ =>]
- 12 Sally Ada Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.5]
b. 16 Nov 1877 d. 17 Apr 1936 [ =>]
- 12 Laura Florence Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.6]
b. 21 Aug 1891 d. 25 Dec 1930
- 12 Mary Etta Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.4]
Mary Harris b. 6 Sep 1879 d. 2 Apr 1940
- 12 Bertha Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.7]
b. 18 Jun 1905 d. 6 Mar 1977
- 12 Willie Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.8]
b. 14 Feb 1906 d. 15 Jul 1998
- 12 Perry Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.9]
b. 17 Nov 1908 d. 26 Sep 1942
- 12 Hester Ann Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.10]
b. 27 Oct 1909 d. 2 Feb 1929
- 12 Robert Clyde Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.11]
b. 15 Jan 1912 d. 29 Apr 1971
- 12 Isaac Newton Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.12]
b. 11 Dec 1915 d. 10 Nov 1975
- 12 Bertha Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.6.7]
- 11 Margaret J Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.7]
b. 11 Mar 1851 d. 18 Sep 1852
- 11 Joseph S Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.8]
b. 1 Jan 1854 d. 1 Sep 1855
- 11 Martha A Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.9]
b. 7 Jan 1856 d. 12 Jul 1944
Harris Taylor Pickens b. 29 Feb 1848 d. 15 Feb 1928
- 12 Fred Lee Pickens, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.9.1]
b. 7 Jul 1879 d. 13 Jul 1946 [ =>]
- 12 Ethel Mae Pickens [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.9.2]
b. 27 Jan 1882 d. 16 Feb 1923
- 12 Robert Arthur Pickens [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.9.3]
b. 27 Jun 1883 d. 22 Mar 1934
- 12 Ray Pickens [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.9.4]
b. 11 Sep 1895 d. 27 Aug 1942
- 12 Fred Lee Pickens, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.9.1]
- 11 John Fletcher Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10]
b. 4 Jul 1858 d. 16 Nov 1931
Bettie Pierce Howard b. 1 Aug 1872 d. 2 Sep 1963
- 12 John Fletcher Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.1]
b. 10 May 1890 d. 8 May 1965 [ =>]
- 12 Joe Dee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.2]
b. 10 Nov 1891 d. May 1968 [ =>]
- 12 Carl Everett Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.3]
b. 16 Jun 1894 d. 22 Mar 1981
- 12 Barb E Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.4]
b. 1895
- 12 Emma Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.5]
b. 1900
- 12 Authur E Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.6]
b. 1901
- 12 Mary E Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.7]
b. 1904
- 12 Horace Grady Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.8]
b. 16 Jan 1910 d. 3 Dec 1987
- 12 John Fletcher Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.10.1]
- 11 Lucy L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.11]
b. 9 Nov 1862
- 11 Sylvester G Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1.1]
- 10 Ann Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.2]
b. 1813
- 10 James Sylvester Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3]
b. 1815 d. 1886
Martha Elizabeth Allen b. Jan 1824 d. 1897
- 11 Laura F Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.1]
b. 28 Nov 1845 d. 19 Jan 1914
- + Julius A Miller b. 30 Aug 1841 d. 24 Feb 1923
- + Julius A Miller b. 30 Aug 1841 d. 24 Feb 1923
- 11 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2]
b. 15 Sep 1848 d. 7 Dec 1926
Pvt George Washington Duncan b. 16 Jul 1848 d. 11 Mar 1928
- 12 Robert Alexander Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.1]
b. 25 Jan 1870 d. 3 Oct 1937 [ =>]
- 12 Edwin Scruggs Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.2]
b. Mar 1871 d. 30 Sep 1932 [ =>]
- 12 Ella Valora Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.3]
b. 2 Aug 1873 d. 25 Nov 1968
- 12 James Sylvester Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.4]
b. 30 Aug 1875 d. 10 May 1943
- 12 Birdie Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.5]
b. Abt 1878 d. 3 Apr 1936
- 12 Minnie L. Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.6]
b. Abt 1880
- 12 Willia Mae Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.7]
b. 5 Nov 1883 d. 29 Oct 1972 [ =>]
- 12 Hutley Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.8]
b. Mar 1886
- 12 Jeff W Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.9]
b. Jun 1888
- 12 Alena Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.10]
b. Jul 1890
- 12 Robert Alexander Duncan [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.2.1]
- 11 Robert Alexander Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3]
b. 10 Mar 1850 d. 1931
Amanda Elizabeth Cox b. 25 Aug 1855 d. 14 Nov 1939
- 12 Maude Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.1]
b. 12 Nov 1876 d. 26 Oct 1895
- 12 Emma B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.2]
b. Feb 1877
- 12 Brand Luke Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.3]
b. 10 Oct 1878 d. 14 Nov 1924
- 12 Lena Moss Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.4]
b. 22 Aug 1881 d. 14 Dec 1969 [ =>]
- 12 Robert Luther Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.5]
b. 14 Feb 1883 d. 1966 [ =>]
- 12 R L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.6]
b. Abt 1884
- 12 Alice Edna Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.7]
b. 10 May 1885 d. 1979
- 12 Samuel Jones Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.8]
b. 6 Nov 1887 d. May 1968 [ =>]
- 12 Edgar Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.9]
b. 1 Apr 1888
- 12 Ruby Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.10]
b. Oct 1891
- 12 Charlie M Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.11]
b. Mar 1894
- 12 Perce Clide Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.12]
b. Sep 1897
- 12 Maude Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.3.1]
- 11 William Hunt Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4]
b. Jan 1854 d. 11 Jul 1933
Julia Ann Covey b. 17 Feb 1865 d. 21 Feb 1920
- 12 James Homer Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.1]
b. 7 Dec 1884 d. 23 Sep 1966 [ =>]
- 12 William Herman Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.2]
b. 8 Sep 1889 d. 25 Sep 1966
- 12 Dewitt Talmage Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.3]
b. 18 Apr 1892
- 12 Janette Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.4]
b. 1 Dec 1895 d. Feb 1923
- 12 George Dewey Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.5]
b. 10 May 1898 d. 2 Apr 1959 [ =>]
- 12 Conley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.6]
b. Mar 1900 d. Bef 1910
- 12 Connie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.7]
b. 29 Sep 1902 d. 9 Jan 1990
- 12 Luther Ervan "Lute" Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.8]
b. 4 Aug 1905 d. 30 Apr 1990
- 12 James Homer Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.4.1]
- 11 Lucy J Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.5]
b. 11 Oct 1856 d. 2 Oct 1891
- + Charles J Embrey b. 14 Jan 1857 d. 4 Dec 1910
- + Charles J Embrey b. 14 Jan 1857 d. 4 Dec 1910
- 11 Albert George Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.6]
b. 22 Jan 1858 d. 6 Feb 1888
Virginia Lodie Harrison b. 7 Nov 1862 d. 6 Jan 1942
- 12 Charley C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.6.1]
b. 1881 d. 1881
- 12 Bessie Viola Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.6.2]
b. 13 Jan 1883 d. 27 Dec 1968
- 12 Lillie A Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.6.3]
b. 1885 d. 1885
- 12 Albert Watson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.6.4]
b. 9 Feb 1887 d. 25 Nov 1967 [ =>]
- 12 Charley C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.6.1]
- 11 Henrietta Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.7]
b. 17 Apr 1860 d. 6 Mar 1886
- + William Franklin Willson b. 1 Jan 1856 d. 26 Aug 1934
- + William Franklin Willson b. 1 Jan 1856 d. 26 Aug 1934
- 11 George F Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.8]
b. 1862 d. 1935
- 11 Dr James Longstreet Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9]
b. Dec 1866 d. 23 May 1935
Lula Thrasher b. Abt 1868 d. 1894
- 12 Odell Byron Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.1]
b. 10 Apr 1889 d. 26 Feb 1966 [ =>]
- 12 Odell Byron Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.1]
Tenora "Nora" Sullivan b. 15 Feb 1878 d. 17 May 1955
- 12 Son Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.2]
[ =>]
- 12 Tompsie Pearl Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.3]
b. 15 Aug 1895 d. 14 May 1955
- 12 Saddie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.4]
b. 1900
- 12 William Everidge Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.5]
b. 2 Dec 1904 d. 4 Apr 1985
- 12 Hattie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.6]
b. 1906
- 12 Bascom Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.7]
b. 7 Aug 1907 d. 29 Jun 1993 [ =>]
- 12 Max B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.8]
b. 3 Jul 1917 d. 25 Mar 1988
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.9]
- 12 Son Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.9.2]
- 11 Laura F Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.3.1]
- 10 Reverend Robert L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1.1]
- 9 Matilda Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.2]
b. 1785
- 9 Richardson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3]
b. 1793 d. May 1856
Ann Gaston b. 1781 d. Bef 1877
- 10 Dr William Gaston Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1]
b. 24 Oct 1824 d. 27 Aug 1874
Kesiah Bennett b. 12 Apr 1828 d. 23 Feb 1884
- 11 John Richardson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.1]
b. 17 Oct 1849 d. 8 Jun 1927
Loula Elizabeth McAnulty b. 8 Jan 1861 d. 10 Jul 1925
- 12 Edgar Wesley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.1.1]
b. 12 Jan 1879 d. 5 Jun 1933 [ =>]
- 12 Mina Louise Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.1.2]
b. 20 Aug 1881 d. 12 Jun 1952
- 12 Efale Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.1.3]
b. 1 Dec 1884 d. 9 Apr 1965
- 12 Edgar Wesley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.1.1]
- 11 William Gaston Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2]
b. 8 Apr 1852 d. 26 Oct 1913
Callie Dania Johnson b. 6 Oct 1853 d. 22 Feb 1928
- 12 Iola Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2.1]
b. 6 Jan 1878 d. 28 Nov 1951 [ =>]
- 12 Lottie Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2.2]
b. 28 Nov 1879 d. 14 Feb 1952 [ =>]
- 12 William Hardie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2.3]
b. 15 May 1883 d. 29 May 1950 [ =>]
- 12 Eleanor Elna Correl Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2.4]
b. 24 Aug 1885 d. 20 Oct 1942
- 12 Otis Johnson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2.5]
b. 20 Mar 1890 d. Nov 1961 [ =>]
- 12 Iola Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.2.1]
- 11 Elisha Micajah Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3]
b. 10 Jan 1860 d. 11 Sep 1945
Mary Ida McAnulty b. Jun 1867 d. 1946
- 12 Verna Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.1]
b. Mar 1891
- 12 Lillie Gertrude Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.2]
b. 15 Aug 1892 d. 17 Feb 1968
- 12 Walter Louie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.3]
b. 10 Jul 1895 d. 22 Sep 1968 [ =>]
- 12 Alline Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.4]
b. Abt 1901
- 12 Harry M Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.5]
b. 15 Dec 1902 d. 19 Jun 2001
- 12 Mabel Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.6]
b. Abt 1906
- 12 Verna Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.3.1]
- 11 Mary Ann Sara Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.4]
b. 10 Dec 1860 d. 27 Dec 1860
- 11 Jeff Davis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5]
b. 29 Sep 1861 d. 28 Apr 1947
Mary Ada Griffin b. 15 Mar 1877 d. 5 May 1952
- 12 Homer Gray Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.1]
b. 18 Sep 1896 d. 28 May 1972
- 12 Villa May Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.2]
b. 9 Jun 1899 d. 18 Sep 1980
- 12 William Gaston Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.3]
b. 23 Oct 1901 d. 25 Apr 1992 [ =>]
- 12 Mattie Viola Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.4]
b. 19 May 1905 d. 16 Feb 1972 [ =>]
- 12 Buna Beatrice Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.5]
b. 1 Aug 1908 d. 2 May 2006
- 12 Jeff Delbert Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.6]
b. 12 Jul 1914 d. 23 May 1982 [ =>]
- 12 Homer Gray Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.5.1]
- 11 John Richardson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1.1]
- 10 Dr William Gaston Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.3.1]
- 9 Mary Polly Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.4]
b. Abt 1794
- + Vaughn
- + Vaughn
- 9 John Hawkins Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5]
b. 25 Jan 1795 d. Aug 1874
Ann Brandon b. 19 Jan 1799 d. Aug 1876
- 10 James Jefferson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.1]
b. 11 Apr 1824
Malinda Carolina Kelly b. Jul 1825 d. 1910
- 11 John Miles Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.1.1]
b. 14 Dec 1866 d. 7 Apr 1934
Mary Elizabeth Crow b. 15 Jan 1873 d. 24 Jun 1953
- 12 Drayton Kennebrew Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.1.1.1]
b. 28 Nov 1898 d. 17 Jun 1926 [ =>]
- 12 Drayton Kennebrew Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.1.1.1]
- 11 John Miles Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.1.1]
- 10 George W Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.2]
b. 2 Sep 1828 d. 11 Sep 1906
Amanda Ellen Johnson b. 1842 d. 11 May 1925
- 11 Jefferson Davis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.2.1]
b. Jun 1861 d. 11 Oct 1945
Martha Margaret Arnett b. 1859 d. 1910
- 12 Dudley Davis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.2.1.1]
b. 4 Jul 1884 d. 10 Dec 1978 [ =>]
- 12 Dudley Davis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.2.1.1]
- 11 Jefferson Davis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.2.1]
- 10 Maryann Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.3]
b. 1830 d. 15 Feb 1909
- 10 Rhoda Rebecca Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4]
b. 26 Nov 1835 d. 21 Oct 1901
John F Stanley b. 1835 d. 5 Apr 1887
- 11 Mintora E Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.1]
b. 26 Sep 1855 d. 29 Oct 1862
- 11 Ellen Jane Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2]
b. 10 Dec 1859 d. 1 Dec 1927
Samuel Jonathan Posey b. 5 Apr 1858 d. 3 Dec 1930
- 12 John Stanley Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.1]
b. 29 Oct 1880 d. 13 Dec 1955 [ =>]
- 12 Claudia Alice Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.2]
b. 2 Apr 1883 d. 4 Oct 1953
- 12 Alma Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.3]
b. Dec 1885
- 12 Thomas Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.4]
b. Apr 1888
- 12 Laura Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.5]
b. Dec 1890
- 12 Gaither Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.6]
b. Jul 1892
- 12 Agatha Lula Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.7]
b. 4 Jul 1893 d. 20 Dec 1977
- 12 Edward Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.8]
b. Jan 1896
- 12 John Stanley Posey [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.2.1]
- 11 Mary F Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.3]
b. 19 Apr 1862 d. 20 Dec 1940
- 11 Annie Laura Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.4]
b. 1866 d. 30 Aug 1917
- + J O Lassiter b. Abt 1865
- + J O Lassiter b. Abt 1865
- 11 Alice Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.5]
b. 11 Dec 1868 d. 15 Jan 1950
- 11 Willie Elizabeth Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.6]
b. 30 May 1872 d. 24 Feb 1958
- + Luther Houston Davis b. Abt 1871
- + Luther Houston Davis b. Abt 1871
- 11 John R Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.7]
b. 2 Oct 1875 d. 2 Oct 1875
- 11 Mintora E Stanley [1.1.1.1.3.12.7.1.5.4.1]
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.5]
b. 1838
- 10 Francis Marion Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.6]
b. 9 Aug 1840 d. 15 Feb 1909
- 10 Martha Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.7]
b. 1843 d. 31 May 1886
- 10 James Jefferson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.5.1]
- 9 Turner Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6]
b. 1797 d. Aft 1860
Clara Smith b. 1796 d. 27 Apr 1875
- 10 John Smith Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1]
b. 1 Oct 1830
Emily Francis Lanford b. 21 Jun 1830 d. 21 Nov 1902
- 11 John Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.1]
b. 1853
- 11 Emily Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.2]
b. 1855
- 11 James Turner Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.3]
b. 23 Jan 1856 d. 1932
Mattie Rowena Bearden b. 16 May 1862 d. 22 Dec 1910
- 12 Carl Bearden Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.3.1]
b. 24 Jun 1884 d. 25 Aug 1965 [ =>]
- 12 Herbert Earl Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.3.2]
b. 11 Sep 1891 d. 10 Nov 1946 [ =>]
- 12 Carl Bearden Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.3.1]
- 11 Mollie Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.4]
b. 1858
- 11 Dean Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.5]
b. 1859
- 11 Dora Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.6]
b. 1862
- 11 William Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.7]
b. 1868
- 11 John Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1.1]
- 10 James Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.2]
b. 1838
- 10 Mary Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.3]
b. 1840
- 10 John Smith Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.6.1]
- 9 Jesse Henry Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.7]
b. 1805 d. 18 Jul 1862
Mary Boggs b. 1811 d. 1844
- 10 Robert M Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1]
b. 20 Nov 1834 d. 5 Aug 1906
Sarah Jane Fowler b. 1837 d. 1920
- 11 Robert Thomas Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1]
b. 6 Sep 1855 d. 27 Aug 1931
Anna Annie Eliza Taylor b. 30 Apr 1862 d. 20 Oct 1949
- 12 James Robert Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.1]
b. 28 Nov 1882 d. 16 Feb 1954 [ =>]
- 12 Ruth Viola Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.2]
b. 29 Dec 1884 d. 26 Mar 1960 [ =>]
- 12 Lawrence Edgar Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.3]
b. 20 May 1887 d. 15 Jan 1963 [ =>]
- 12 Roy Thomas Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.4]
b. 17 Apr 1890 d. 22 Nov 1984 [ =>]
- 12 Annie Janie Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.5]
b. 12 Feb 1896 d. 1924
- 12 Myrtle Bludworth Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.6]
b. 21 May 1907 d. 18 May 1908
- 12 James Robert Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1.1]
- 11 Giles M Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2]
b. 27 Jul 1860 d. 31 Aug 1924
Elizabeth Caroline Brown b. 1866 d. 1 Mar 1954
- 12 Rolie Jackson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.1]
b. 8 Sep 1887 d. 18 May 1889
- 12 Ross Mills Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.2]
b. 21 Sep 1889 d. 1 Jan 1945 [ =>]
- 12 Robert Pliny Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.3]
b. 12 Nov 1891 d. 12 Oct 1964 [ =>]
- 12 Alfred McClennon Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.4]
b. 27 Jan 1894 d. 8 Nov 1947
- 12 William Jennings Bryan Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.5]
b. 11 Aug 1895 d. 15 Aug 1936
- 12 Birdie B Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.6]
b. 28 Aug 1898 d. 18 Jan 1899
- 12 Grace Pearl Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.7]
b. 31 Dec 1899 d. 25 May 2000
- 12 Gertrude Minnie Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.8]
b. 17 Jan 1903 d. 2 Aug 1994 [ =>]
- 12 Esther Gladys Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.9]
b. 10 May 1906 d. 16 Oct 1976 [ =>]
- 12 Rolie Jackson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.2.1]
- 11 Lonzo Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.3]
b. Abt 1866
- 11 R M Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.4]
b. 1869 d. Bef 1880
- 11 Mittie Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.5]
b. Abt 1874
- 11 Lawrence F Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.6]
b. 2 May 1874 d. 27 May 1880
- 11 Ross M Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.7]
b. 16 Feb 1877 d. 27 May 1880
- 11 Robert Thomas Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1.1]
- 10 Jacob Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.2]
b. 1835 d. 18 Mar 1862
- 10 John McKinzy Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3]
b. 14 Jun 1841 d. 15 Feb 1923
Margaret Paralee Gentry b. Jul 1851
- 11 Walker Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3.1]
b. Abt 1871
- 11 Mattie V Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3.2]
b. Abt 1873
- 11 William J Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3.3]
b. Oct 1876
- 11 Julia E Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3.4]
b. Abt 1878
- 11 Benjamin F Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3.5]
b. Abt 1880
- 11 Walker Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.3.1]
- 10 James Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.4]
b. 1845
- 10 Robert M Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.1]
Nancy J Boggs b. 1820 d. 1870
- 10 Mary Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.5]
b. 1848
- 10 Sarah Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.6]
b. 1854
- 10 Jesse Henry Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7]
b. Feb 1858 d. 20 Aug 1933
Sarah H Shadden b. Jan 1865
- 11 Virgil Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.1]
b. Mar 1885
- 11 Arthur Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.2]
b. Aug 1887
- 11 Inous Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.3]
b. Jan 1892
- 11 Curtis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.4]
b. 21 Jun 1894 d. 26 Mar 1975
- + Mary Ruth Taylor b. 13 Aug 1903 d. 18 Jan 1998
- + Mary Ruth Taylor b. 13 Aug 1903 d. 18 Jan 1998
- 11 Delia Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.5]
b. Aug 1896
- 11 Otis Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.6]
b. Abt 1900
- 11 Mildred Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.7]
b. Abt 1902
- 11 Corinne Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.8]
b. Abt 1904
- 11 William S Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.9]
b. Abt 1910
- 11 Virgil Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.7.1]
- 10 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.8]
b. Feb 1858
- 10 Mary Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.7.5]
- 9 William H Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1.1]
- 8 William Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2]
b. 1765 d. 1 Jan 1837
- + Nancy Turner
Sally Haupt b. 1773
- 9 Chesley B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1]
b. 1790 d. 19 Mar 1833
Lucinda Catherine Sessums b. 1801 d. 1873
- 10 Thomas Paines Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1]
b. 1817 d. 31 Aug 1897
Eveline A Johnson b. 1824
- 11 Henry Clay Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.1]
b. Nov 1842 d. 26 Oct 1926
Mary Kate Johnson b. 1849 d. 17 May 1900
- 12 Leonidas Johnson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.1.1]
b. 15 Jul 1868 d. 2 May 1923
- 12 Leonidas Johnson Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.1.1]
- + Sarah Ann
- 11 Leonidas A Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2]
b. 1844 d. Bef 1880
Anna E b. 1833
- 12 Chesley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.1]
b. Abt 1854
- 12 Lee Anna Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.2]
b. Abt 1858
- 12 Ida L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.3]
b. Abt 1862
- 12 Carrie S. Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.4]
b. Abt 1864
- 12 Mary S Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.5]
b. Abt 1866
- 12 Lella Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.6]
b. 28 Nov 1868 [ =>]
- 12 Chesley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.2.1]
- 11 James Oscar Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3]
b. Sep 1848 d. 8 Dec 1937
Lutie Routh b. Abt 1861
- 12 Oscar J Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.1]
b. 1 Sep 1877 d. 19 Aug 1910
- 12 Mona Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.2]
b. 17 Feb 1879 d. 14 Oct 1965
- 12 Montie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.3]
b. Feb 1881
- 12 Thomas P Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.4]
b. Feb 1883 d. Dec 1974
- 12 Stephen Austin Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.5]
b. 4 Apr 1885 d. 9 Oct 1968 [ =>]
- 12 Cora Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.6]
b. Jul 1888
- 12 Mason Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.7]
b. 4 Nov 1888 d. 6 Jul 1968
- 12 Mellie Ruth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.8]
b. 29 Mar 1897 d. 30 Aug 1977
- 12 Oscar J Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.3.1]
- 11 W B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.4]
b. 1851
- 11 Charlie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.5]
b. 1852
- 11 Eliza Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.6]
b. 1854
- 11 Sam H Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.7]
b. 1855
- 11 L D Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.8]
b. 1857
- 11 Henry Clay Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1.1]
- 10 Catherine Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2]
b. 1 Aug 1824 d. 1 Oct 1860
Marion C Brown, Sr b. Abt 1820
- 11 Marion C Brown, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.1]
b. 1842 d. 19 Sep 1863
- 11 Marion C Brown, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.1]
Walter Alvis Parish b. 2 Nov 1805 d. 27 Jul 1866
- 11 Joel Leonidas Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2]
b. 2 Dec 1846 d. 11 Apr 1899
Susan Boyd Gambrell b. 2 Jul 1852 d. 25 Mar 1936
- 12 Allie W Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.1]
b. Oct 1873
- 12 John Edward Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.2]
b. 14 Nov 1880 d. 13 Jan 1932 [ =>]
- 12 Katie B Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.3]
b. Apr 1883
- 12 Sam Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.4]
b. Mar 1885
- 12 Sue Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.5]
b. Sep 1887
- 12 Mosell Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.6]
b. Jul 1890
- 12 Lilla Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.7]
b. Nov 1896
- 12 Allie W Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2.1]
- 11 Leonidas E Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.3]
b. 1848
- 11 John Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.4]
b. 1850
- 11 Joel Leonidas Parish [1.1.1.1.3.12.7.2.1.2.2]
- 10 Leonidas C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.3]
b. 1827 d. 11 Dec 1875
- 10 John McKinley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.4]
b. 24 Aug 1829 d. 30 Jan 1888
- + Mary Jane Lowe d. 1858
- + Eliza
- + Mary Jane Lowe d. 1858
- 10 Thomas Paines Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1.1]
- 9 Seaborn Jones Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2]
b. 13 Aug 1792 d. 1885
Docia Gray b. 1793 d. 1830
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.1]
- 10 Wiley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.2]
- 10 Patsey Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.3]
b. 1815
- 10 Alvatine Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4]
b. 12 May 1816 d. 5 Aug 1895
Burgess Colburn b. 1818 d. 1848
- 11 William J Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.1]
b. 1844
- 11 Franklin M Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.2]
b. 1844
- 11 Chesley Burgess Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3]
b. 29 Nov 1846 d. 14 May 1901
Belle Fennell Rivers b. 23 Jun 1855 d. 12 Dec 1948
- 12 John W Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3.1]
b. Dec 1877
- 12 Frank Eldridge Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3.2]
b. 6 Oct 1882 d. 22 Oct 1956 [ =>]
- 12 Maggie L Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3.3]
b. Nov 1885
- 12 Harry Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3.4]
b. May 1887
- 12 Mattie J Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3.5]
b. Jul 1890
- 12 John W Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.3.1]
- 11 William J Colburn [1.1.1.1.3.12.7.2.2.4.1]
- + John P Smith b. 17 Nov 1810 d. 10 Jan 1908
- 10 William Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5]
b. 17 Feb 1818 d. 26 May 1872
Martha Rogers b. 1817
- 11 Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.1]
b. 1840 d. 15 Dec 1886
- 11 Seaborn Leonidas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2]
b. 30 Dec 1841 d. 17 Nov 1907
Belinda Mildred Parvin b. 11 Oct 1844 d. 18 May 1890
- 12 Martha Belinda Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.1]
b. 19 Jul 1864 d. 8 Mar 1927 [ =>]
- 12 William Jesse Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.2]
b. Apr 1867 d. 22 Apr 1943 [ =>]
- 12 Martisha Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.3]
b. 10 May 1869 d. 14 Dec 1955 [ =>]
- 12 Lela Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.4]
b. 20 Mar 1871 d. 11 Jul 1937 [ =>]
- 12 Minnie Alice Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.5]
b. 15 Dec 1872 [ =>]
- 12 John Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.6]
b. 27 Apr 1874 d. 6 Apr 1937 [ =>]
- 12 Mary Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.7]
b. 26 Jul 1876 d. 18 May 1896 [ =>]
- 12 Seaborn Frank Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.8]
b. 3 Jan 1879 d. 4 Nov 1977 [ =>]
- 12 Bennie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.9]
b. 1894
- 12 Martha Belinda Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.2.1]
- + Sarah Ann Price b. Jul 1850 d. Aft 1900
- 11 Matilda Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.3]
b. 13 Jan 1843 d. 30 Mar 1862
- 11 Benjamin B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.4]
b. 7 Jan 1845 d. 15 Dec 1886
- 11 Mary Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.5]
b. 1846
- 11 Harriett A Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6]
b. 1847 d. 1914
Robert Jerome Ferguson b. Mar 1849 d. 1934
- 12 William Gray Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.1]
b. 14 Feb 1872 d. 8 Jul 1951
- 12 Martha Mattie Rountree Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.2]
b. Jul 1877 d. 31 Oct 1932
- 12 Hattie Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.3]
b. May 1879
- 12 Onie Mae Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.4]
b. Jun 1880 d. 1922
- 12 Ben Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.5]
b. Nov 1881
- 12 Jesse Stokes Ferguson, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.6]
b. 26 Oct 1883 d. 1957 [ =>]
- 12 Frank H Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.7]
b. Aug 1885 d. 6 Mar 1961 [ =>]
- 12 Bome Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.8]
b. Jul 1890
- 12 William Gray Ferguson [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.6.1]
- 11 William Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.7]
b. May 1850
- 11 Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.8]
b. 1853
- 11 Martha Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.9]
b. 1854 d. 21 Jun 1921
- + Andrew J Easterling b. Oct 1851
- + Andrew J Easterling b. Oct 1851
- 11 Charles Allen Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10]
b. Dec 1855 d. 15 Mar 1916
Mary Calvin Brooks b. May 1865
- 12 Lida Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.1]
b. Sep 1886
- 12 Ben B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.2]
b. Feb 1890
- 12 Charles Allen Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.3]
b. Jul 1893 [ =>]
- 12 Susie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.4]
b. Mar 1895
- 12 William Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.5]
b. Abt 1904
- 12 Ontgrey Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.6]
b. Abt 1906
- 12 Lida Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.10.1]
- 11 John Gray Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.11]
b. 24 Jun 1860 d. 24 Dec 1946
- + Helen Watkins b. 7 Mar 1861 d. 18 Dec 1942
- + Helen Watkins b. 7 Mar 1861 d. 18 Dec 1942
- 11 Annie Eliza Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.12]
b. Abt 1863
- 11 Henry Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.5.1]
- 10 Chesley "Charles" B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6]
b. 1820
Eliza F Byrd b. 1831
- 11 Infant Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.1]
- 11 Mary Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.2]
b. 1852
- 11 William Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.3]
b. Abt 1855
- 11 Buchanan Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.4]
b. 16 Nov 1856 d. 18 Aug 1861
- 11 Ettie Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.5]
b. Oct 1859
- 11 Eddie B. Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.6]
b. Abt 1860
- 11 Hugh W. Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.7]
b. Abt 1863
- 11 Eugenia Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.8]
b. Abt 1866
- 11 Eliza Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.9]
b. Abt 1868
- 11 Infant Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.6.1]
- 10 Susan Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7]
b. 20 Jul 1822 d. 2 Oct 1898
John A W Starnes b. 18 Oct 1816 d. 1891
- 11 Harriet B. Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.1]
b. Abt 1849
- 11 Mary A. Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.2]
b. Abt 1850 d. 1926
- 11 Martha B. Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.3]
b. Abt 1853
- 11 Pherbia Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.4]
b. Abt 1854
- 11 Elizabeth (Lizzie) Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.5]
b. 27 Aug 1855 d. 13 Nov 1942
- 11 Eliza B Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.6]
b. Abt 1857 d. Aft 1910
- 11 Sallie G. Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.7]
b. Abt 1859
- 11 Harriet B. Starnes [1.1.1.1.3.12.7.2.2.7.1]
- 10 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.8]
b. 1824 d. 1830
- 10 Harriet Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.9]
b. 1827 d. 1880
William McDaniel b. Abt 1826
- 11 Samuel McDaniel [1.1.1.1.3.12.7.2.2.9.1]
b. Abt 1857
- 11 Seburn McDaniel [1.1.1.1.3.12.7.2.2.9.2]
b. Abt 1858
- 11 Andrew McDaniel [1.1.1.1.3.12.7.2.2.9.3]
b. Abt 1861
- 11 John McDaniel [1.1.1.1.3.12.7.2.2.9.4]
b. Abt 1862
- 11 Samuel McDaniel [1.1.1.1.3.12.7.2.2.9.1]
- 10 Frances M Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.10]
b. 1828 d. 1840
- 10 Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.11]
b. 1830 d. 1840
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.1]
- + Adaline Flippin b. 1811 d. 24 Jun 1834
Elizabeth B Rogers b. 1801 d. 22 Jul 1864
- 10 Rebecca Matticia Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12]
b. 5 May 1834 d. Jan 1902
Henry Burfett Ledbetter b. 1831 d. 1863
- 11 Lila Gray Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1]
b. 22 Jun 1855 d. 19 Mar 1916
Rufus Alonzo Robison b. 7 Oct 1850 d. 2 Mar 1926
- 12 Mary Araminta Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.1]
b. 5 Oct 1877 d. 7 May 1970 [ =>]
- 12 Virginia V Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.2]
b. 10 Mar 1879 d. 10 Aug 1910
- 12 Norris Quitman Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.3]
b. 21 Feb 1881 d. 18 Apr 1942 [ =>]
- 12 Thomas Henry Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.4]
b. 10 Apr 1883 d. Sep 1975
- 12 Nannie Ebergess Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.5]
b. 4 Dec 1885 d. 27 Oct 1966 [ =>]
- 12 Charlie C Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.6]
b. 8 Jul 1890
- 12 Rufus L Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.7]
b. 10 Apr 1892 d. 13 Aug 1980
- 12 Dick Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.8]
b. 26 Oct 1895
- 12 Bunton Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.9]
b. 1898 d. 8 Jul 1900
- 12 Nolan Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.10]
b. 12 Mar 1900 d. 1 Jan 1928
- 12 Mary Araminta Robison [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1.1]
- 11 Seaborn Gardner Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2]
b. 3 Feb 1860 d. 25 Mar 1904
Mamie W Ledbetter b. Mar 1867
- 12 Lorine Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2.1]
b. 24 Dec 1888 d. 10 Oct 1939 [ =>]
- 12 Marguerite Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2.2]
b. Mar 1891
- 12 Seaborn E Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2.3]
b. Feb 1894
- 12 Annita Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2.4]
b. Aug 1897
- 12 Mamie Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2.5]
b. Aug 1899
- 12 Lorine Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.2.1]
- 11 Lila Gray Ledbetter [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12.1]
- 10 Thomas Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.13]
b. 27 Nov 1836
- 10 Wiley Berry Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14]
b. 13 Feb 1838 d. 21 Aug 1918
Elizabeth Autamisa Holbrook b. 4 Aug 1837 d. 10 Mar 1910
- 11 William Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1]
b. 23 Jun 1860 d. 10 May 1945
Ida Pauline Smith b. 12 Apr 1861 d. 11 Jul 1932
- 12 James Wiley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.1]
b. Jul 1884 d. 16 Aug 1957 [ =>]
- 12 Thomas William Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.2]
b. 27 Sep 1886 d. 19 Dec 1962 [ =>]
- 12 Charlie L Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.3]
b. May 1889
- 12 Robert Smith Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.4]
b. 11 Nov 1891 d. 23 May 1970 [ =>]
- 12 Benjamin Franklin Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.5]
b. 2 Jul 1894 d. 30 Jun 1983 [ =>]
- 12 Lonie Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.6]
b. 29 Aug 1897 d. 7 Oct 1984 [ =>]
- 12 Josie Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.7]
b. 20 Sep 1900 d. 20 Aug 1981
- 12 Maborn Bruce Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.8]
b. 20 Jan 1903 d. 20 Sep 1984 [ =>]
- 12 James Wiley Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1.1]
- 11 Wiley Columbus Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.2]
b. 14 Feb 1862 d. 26 Oct 1902
Josephine Alma Grugen b. 21 Dec 1872 d. 8 Nov 1958
- 12 Wiley C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.2.1]
b. 26 May 1893 d. 11 Mar 1954 [ =>]
- 12 Ben Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.2.2]
b. 26 Apr 1895 d. 23 May 1902
- 12 Josie Viola Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.2.3]
b. Jan 1898 d. 1906
- 12 Wiley C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.2.1]
- 11 Benjamin F Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3]
b. 11 May 1863
Ella Long b. Abt 1875
- 12 Mary E Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.1]
b. Apr 1892
- 12 Lucile N Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.2]
b. Feb 1895
- 12 Lennie D Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.3]
b. Apr 1900
- 12 John D Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.4]
b. Abt 1909
- 12 Monroe Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.5]
b. Abt 1910
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.6]
- 12 Mary E Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.3.1]
- 11 Robert Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.4]
b. 20 Feb 1868 d. 7 Nov 1909
Eva Euphelia Goswick b. 28 Nov 1877 d. 24 Apr 1974
- 12 Kian Fleming Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.4.1]
b. 27 Sep 1899 d. 22 Oct 1972
- 12 Kian Fleming Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.4.1]
- 11 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.5]
b. 28 Mar 1870 d. 7 Oct 1871
- 11 Nina May Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.6]
b. 3 May 1872 d. 16 Jun 1963
- + Jesse L Harvey b. Nov 1864
- + Jesse L Harvey b. Nov 1864
- 11 Nona Ray Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.7]
b. 12 Nov 1874
- + Robert A Patterson b. Abt 1872
- + Robert A Patterson b. Abt 1872
- 11 Seaborn Rogers Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.8]
b. 20 Feb 1877 d. 28 Aug 1947
Ola Williams b. 27 Aug 1881 d. 4 Feb 1909
- 12 Raymond Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.8.1]
b. 24 May 1903 d. 27 Mar 1920
- 12 Raymond Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.8.1]
Olive Ethel Mowcomber b. 14 Sep 1877 d. 25 May 1951
- 12 Seaborn Rogers Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.8.2]
b. 19 Mar 1912 d. 2 Jan 2000
- 12 Dr Wiley Berry Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.8.3]
b. 15 Oct 1915 d. 27 Mar 1987 [ =>]
- 12 Seaborn Rogers Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.8.2]
- 11 William Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.14.1]
- 10 Reuben Rogers Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15]
b. 25 Dec 1839 d. 7 Mar 1924
Sarah Jane Floyd b. 14 Mar 1844 d. 16 May 1877
- 11 Joseph Allen Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1]
b. 27 Aug 1866 d. 11 Jun 1950
Gebanna Smith b. 2 Apr 1870 d. 19 May 1953
- 12 Reuben Richard Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1.1]
b. 5 May 1889 d. 30 Nov 1971
- 12 Don Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1.2]
b. 28 Nov 1890 d. 6 Dec 1954
- 12 Bessie M Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1.3]
b. May 1894
- 12 William Jennings Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1.4]
b. 22 Oct 1896 d. 7 May 1973 [ =>]
- 12 Seaborn Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1.5]
b. 14 Nov 1900 d. 26 Mar 1984
- 12 Reuben Richard Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1.1]
- 11 Reuben Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.2]
b. Sep 1868 d. 30 May 1954
Ida B Bryan d. Bef 1910
- 12 Lawrence Keith Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.2.1]
b. 2 Jan 1898 d. 9 Apr 1978
- 12 Charles Elliott Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.2.2]
b. Sep 1899 d. 30 Jan 1951
- 12 Ruby R Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.2.3]
b. 29 Aug 1902 d. 4 Aug 1993
- 12 Lawrence Keith Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.2.1]
- 11 Elizabeth Burgess Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3]
b. 10 Aug 1871 d. 10 Dec 1952
William Pleasant Ross b. 24 Oct 1868 d. 20 Apr 1940
- 12 Baby Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.1]
b. 16 Mar 1891 d. 16 Mar 1891
- 12 Lillie Ita Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.2]
b. 1 Feb 1892 d. 26 Aug 1984
- 12 Edward Earl Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.3]
b. 28 Oct 1893 d. 12 Oct 1956
- 12 Reuben Creed Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.4]
b. 8 Mar 1895 d. 21 Aug 1969
- 12 William C Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.5]
b. 26 Jun 1897
- 12 Gladden Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.6]
b. 31 Aug 1898 d. 3 Sep 1898
- 12 Cecil Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.7]
b. 1899 d. Cecil was a child when he died
- 12 Lloyd Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.8]
b. 26 Jun 1900 d. 27 Aug 1975
- 12 Alma Imogene Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.9]
b. 25 Sep 1902 d. 4 Sep 1990 [ =>]
- 12 Grady Thompson Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.10]
b. 25 Oct 1904 d. 11 Jan 1967 [ =>]
- 12 Sarah Jane Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.11]
b. 8 Oct 1906 d. 1 Oct 1979
- 12 Martha Eliza Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.12]
b. 3 Sep 1910 d. 4 Oct 1934
- 12 Robert Joseph Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.13]
b. 17 Nov 1912 d. 8 Mar 2000
- 12 Baby Ross [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.3.1]
- 11 Joseph Allen Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.1]
Ruth L Moss b. Dec 1857 d. 1926
- 11 Nancy Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.4]
b. 23 Nov 1879 d. 10 Dec 1924
- 11 Eva Etta Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.5]
b. 9 Dec 1883 d. 8 Jan 1971
James Warner Fulton b. 1886
- 12 Virgil Fulton [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.5.1]
b. 1908
- 12 Reuben Fulton [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.5.2]
b. 1910
- 12 Virgil Fulton [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.5.1]
- 11 Bertha May Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.6]
b. 11 Apr 1888 d. 19 Jun 1956
- 11 Wylie James Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.7]
b. 13 Sep 1893 d. 7 Aug 1959
- + Maudice Dobie b. 22 Jul 1905 d. 9 Oct 1963
Mettie May Taylor b. 1895 d. 1924
- 12 Reuben Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.7.1]
b. 1924 d. 1982 [ =>]
- 12 Reuben Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.7.1]
- + Maudice Dobie b. 22 Jul 1905 d. 9 Oct 1963
- 11 Nancy Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.15.4]
- 10 Sarah Gray Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16]
b. 29 Jul 1841 d. 14 Mar 1915
Andrew Barney Cook b. 3 Apr 1836 d. 13 Nov 1902
- 11 Louisa Rebecca Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1]
b. 1 Nov 1857 d. 19 Jan 1920
George Washington Witt b. 14 Feb 1853 d. 4 Dec 1943
- 12 Andrew William Drew Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.1]
b. 12 May 1874 d. 16 Aug 1965 [ =>]
- 12 Fred W Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.2]
b. 31 Jul 1876 d. 14 Jul 1961 [ =>]
- 12 George Alfonzo Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.3]
b. 19 Aug 1878 d. 5 Feb 1975 [ =>]
- 12 Elizabeth Gray Bessie Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.4]
b. 5 Nov 1880 d. 27 Nov 1967 [ =>]
- 12 Margaret Bell Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.5]
b. 31 Dec 1882 d. 29 Aug 1977 [ =>]
- 12 Illa Mae Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.6]
b. 4 Mar 1885 d. 7 Mar 1988 [ =>]
- 12 Sallie Myrtle Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.7]
b. 15 Jan 1888 d. 23 Sep 1982
- 12 Annie Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.8]
b. 10 Jul 1890 d. 5 Apr 1983 [ =>]
- 12 Maggie B Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.9]
b. Dec 1892
- 12 Virgie Louisa Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.10]
b. 25 Sep 1893 d. 1 Nov 1961 [ =>]
- 12 Sadie Marie Pet Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.11]
b. 10 Jan 1896 d. 25 Jun 1982 [ =>]
- 12 Mildred Cook Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.12]
b. 7 Jun 1900 d. 9 Apr 1973 [ =>]
- 12 Eva Lou Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.13]
b. 3 Apr 1902 d. 11 Aug 1997 [ =>]
- 12 Andrew William Drew Witt [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1.1]
- 11 Elizabeth Virginia Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2]
b. 14 Sep 1859 d. 14 Dec 1952
John Alexander Keith b. 11 Jun 1854 d. 27 Dec 1937
- 12 Annie Lou Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.1]
b. 1871 d. 1879
- 12 Andrew Alex Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.2]
b. 1877 d. 1896
- 12 Minnie May Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.3]
b. 8 Mar 1880 d. 20 Apr 1967
- 12 Flora Valena Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.4]
b. 3 Oct 1882 d. 21 Oct 1976 [ =>]
- 12 Tina Lois Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.5]
b. 16 Jul 1885 d. 5 Feb 1974 [ =>]
- 12 Sarah Mabel Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.6]
b. 15 Feb 1888 d. 12 Feb 1978
- 12 Mary Jesse Anna Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.7]
b. 9 Nov 1890 d. 23 Nov 1971
- 12 Warren Floyd Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.8]
b. 22 Apr 1893 d. 17 Jan 1967 [ =>]
- 12 Nell Evelyn Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.9]
b. 8 Aug 1896 d. 6 Jul 1982
- 12 Reuben Cook Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.10]
b. 8 Jan 1899 d. 18 Sep 1992
- 12 Eugene Maurice Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.11]
b. 30 May 1902 d. 6 Feb 1960
- 12 Annie Lou Keith [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.2.1]
- 11 Samuel Asa Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.3]
b. 26 Apr 1866 d. 26 Apr 1894
- 11 Florence Josephine Josie Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.4]
b. 12 Nov 1869 d. 6 Jul 1943
William A Priest b. 24 May 1861 d. 26 Jan 1914
- 12 Roy Cook Priest [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.4.1]
b. 18 Feb 1889 d. 14 Feb 1978
- 12 Jewel J Priest [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.4.2]
b. 16 Mar 1891 d. 7 Oct 1976
- 12 Robert Barney Priest [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.4.3]
b. 11 Apr 1899 d. 11 Jan 1971
- 12 Willie Jo Priest [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.4.4]
b. 19 Jan 1904 d. 19 Dec 1978
- 12 Roy Cook Priest [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.4.1]
- 11 Flora Winifred Priscilla Illa Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.5]
b. 3 Feb 1871 d. 1 Oct 1946
Sandy Clinton Tabb b. 11 Feb 1867 d. 2 Mar 1952
- 12 Oscar Cook Tabb [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.5.1]
b. 17 Jun 1897 d. 2 Sep 1967
- 12 Carroll Clinton Tabb [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.5.2]
b. 9 Nov 1898 d. 4 Jan 1968 [ =>]
- 12 Agnes Virginia Tabb [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.5.3]
b. 27 Jul 1906 d. 12 Oct 2000
- 12 Oscar Cook Tabb [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.5.1]
- 11 Annie Jeffie Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6]
b. 2 Apr 1873 d. 26 Mar 1916
David Calvin Myers b. Jan 1865 bur. Mission Garden of Memories Cemetery
- 12 David Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.1]
b. Dec 1894
- 12 Cook Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.2]
b. 23 Dec 1897 d. 11 Dec 1922
- 12 Grace Anna Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.3]
b. 23 Jun 1899 d. 12 Jan 1979
- 12 Maye E Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.4]
b. 1902
- 12 Hulette S Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.5]
b. 1905
- 12 Ordway Cambell Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.6]
b. 1 Feb 1907 d. 2 Dec 1959
- 12 David Myers [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.6.1]
- 11 Doctor Alfonso Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.7]
b. 17 Aug 1875 d. Dec 1964
- + Louise Cheever b. 1890
- + Louise Cheever b. 1890
- 11 Reuben Rogers Rountree Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.8]
b. 8 Oct 1877 d. 1 Dec 1973
Edna Ola Keith b. 29 Dec 1881 d. 28 Feb 1972
- 12 Andrew B Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.8.1]
b. 17 Sep 1923 d. 30 Aug 2006
- 12 Andrew B Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.8.1]
- 11 Eva Leanna Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.9]
b. 30 Oct 1879 d. 17 Jul 1973
James John Herff Buchanan b. 1 Feb 1886 d. 20 May 1944
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.9.1]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.9.1]
- 11 Saddie Gray Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.10]
b. 3 Feb 1882 d. Nov 1976
Bolivar C Barrier b. Abt 1876
- 12 Barney C Barrier [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.10.1]
b. Abt 1904
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.10.2]
- 12 Barney C Barrier [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.10.1]
- 11 Louisa Rebecca Cook [1.1.1.1.3.12.7.2.2.16.1]
- 10 Seaborn Jones Rountree, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17]
b. 1 Sep 1843 d. 17 Sep 1902
Mary C Floyd b. 22 Dec 1848 d. 16 May 1898
- 11 Virginia Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1]
b. 11 Feb 1869 d. 21 Sep 1964
Reverend Benjamin Franklin Fronabarger, Sr b. 10 Mar 1860 d. 27 Apr 1934
- 12 Elva Faye Fronabarger [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1.1]
b. 19 Nov 1888 d. 23 Apr 1965
- 12 Luther Cecil Fronabarger [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1.2]
b. 16 Nov 1890 d. 24 Oct 1970
- 12 Benjamin Franklin Fronabarger, Jr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1.3]
b. 26 Jul 1893 d. 8 May 1960
- 12 Mary L Fronabarger [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1.4]
b. 31 Oct 1898 d. 2 Aug 1951
- 12 Elva Faye Fronabarger [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1.1]
- 11 Mary Catherine Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.2]
b. 29 Jul 1874 d. 12 May 1934
- + Vernon Sivley Holcomb b. 20 Sep 1856 d. 3 Sep 1945
- + Vernon Sivley Holcomb b. 20 Sep 1856 d. 3 Sep 1945
- 11 Virginia Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.17.1]
- 10 Joseph Rogers Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18]
b. 29 May 1845 d. 1882
Ellen Wommack b. Abt 1850
- 11 Brenda Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.1]
b. 1875
- 11 Beulah Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.2]
b. 13 Sep 1876 d. 19 Jun 1967
- 11 William Jones Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.3]
b. 1 Feb 1877 d. 14 Aug 1958
Beulla Kate Stephenson b. 25 Jan 1878 d. 17 Jun 1942
- 12 Earl Wayne Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.3.1]
b. 16 Jun 1901 d. 20 Oct 1958 [ =>]
- 12 Rex Lee Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.3.2]
b. 21 Nov 1912 d. 11 Nov 1937
- 12 Earl Wayne Rountree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.3.1]
- 11 Bulah Kate Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.4]
b. 25 Jan 1878 d. 17 Jun 1942
- 11 Curtis J Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.5]
b. Oct 1881
- 11 Brenda Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.18.1]
- 10 Rebecca Matticia Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.2.12]
- 9 Nancy Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.3]
b. 1794 d. 1826
- 9 Mildred Nelly Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.4]
b. 1795 d. 1860
Zedekiah Tate b. 1782 d. 1835
- 10 Napolean B Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.1]
b. Abt 1808 d. 1838
- 10 Richard Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.2]
b. Abt 1810
- + Sarah Yancey b. Abt 1817
- + Sarah Yancey b. Abt 1817
- 10 Elmyra T Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.3]
b. Abt 1812
William G Burton d. Bef 1830
- 11 Virginia Burton [1.1.1.1.3.12.7.2.4.3.1]
b. 1835
- 11 Erma Amanda Burton [1.1.1.1.3.12.7.2.4.3.2]
b. 1836 d. 25 Aug 1880
- + Jesse Thomas Whitehead b. 26 Aug 1839 d. 26 Aug 1865
- + Jesse Thomas Whitehead b. 26 Aug 1839 d. 26 Aug 1865
- 11 Frances Burton [1.1.1.1.3.12.7.2.4.3.3]
b. 1843
- 11 Virginia Burton [1.1.1.1.3.12.7.2.4.3.1]
- 10 Waddy Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.4]
b. Abt 1814
- 10 Benjamin Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.5]
b. Abt 1823
- 10 John S Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.6]
b. Abt 1825 d. 1891
- 10 Hiram Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.7]
b. Abt 1828
- 10 Franklin Sidney Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.8]
b. Abt 1832
- 10 Eliza Caroline Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.9]
b. Abt 1833
- 10 Napolean B Tate [1.1.1.1.3.12.7.2.4.1]
- 9 William Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.5]
b. 1800 d. 1836
- 9 Chesley B Rountree [1.1.1.1.3.12.7.2.1]
- + Harriett Sherrod
- + Nancy Turner
- 8 Elizabeth Mildred Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.3]
b. 1767 d. 1846
William Thomas Goldsmith, Sr b. 24 Jun 1762 d. 21 Mar 1835
- 9 Mary Ann Polly Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.1]
b. 1785 d. 24 Feb 1829
Joseph Newland Howard b. 1788 d. 1860
- 10 Wiley Ann Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.1]
b. 1813 d. 26 Oct 1896
- 10 Lewis Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.2]
b. 9 Sep 1813 d. 1875
- 10 William Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.3]
b. 3 Sep 1817 d. 10 Nov 1891
Elizabeth Wharton b. 21 Jan 1821 d. 6 Apr 1885
- 11 James Samuel Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.3.1]
b. 31 Dec 1847 d. 2 Apr 1931
Sarah Elizabeth Hill b. 17 Sep 1845 d. 12 Feb 1943
- 12 James Clayton Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.3.1.1]
b. 1 Oct 1869 d. 3 Mar 1891 [ =>]
- 12 James Clayton Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.3.1.1]
- 11 James Samuel Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.3.1]
- 10 Elijah Welborn Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4]
b. 10 Mar 1822 d. 30 Mar 1892
Frances Cornelia Batson b. 7 Nov 1836 d. 8 Jan 1889
- 11 William G. Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.1]
b. 1863
- 11 Mary S Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.2]
b. 1866
- 11 James Thomas Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.3]
b. 20 Nov 1867 d. 6 Aug 1893
- 11 Kizziah Marie Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4]
b. 10 Mar 1870 d. 13 Feb 1959
William Samuel Marchbanks b. 10 May 1868 d. 16 Aug 1958
- 12 Mamie Lee Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.1]
b. 18 Dec 1892 d. 27 Jan 1911
- 12 Margaret Cornelia Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.2]
b. 1895 d. 1976 [ =>]
- 12 Walter William Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.3]
b. 12 Jun 1900 d. 18 Jan 1978
- 12 Ruth Velma Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.4]
b. 8 Oct 1903 d. 22 Apr 1998
- 12 Wilburn Elijah Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.5]
b. 4 Oct 1905 d. 6 May 1940
- 12 Grace Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.6]
b. 8 Nov 1910 d. 13 Apr 1993
- 12 Kate Agnes Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.7]
b. 28 Nov 1912 d. 14 Aug 2014
- 12 Mamie Lee Marchbanks [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.4.1]
- 11 Dock Benjamin Few Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.5]
b. 5 Aug 1873 d. 22 Nov 1938
- 11 Wilburn Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.6]
b. 1878
- 11 William G. Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.4.1]
- 10 Fatima Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.5]
b. 1823 d. 10 Jul 1902
Arthur Nathaniel Batson b. 19 Jul 1821 d. 23 May 1907
- 11 Martha Jane Batson [1.1.1.1.3.12.7.3.1.5.1]
b. 29 Jun 1845 d. 14 Apr 1929
Richard Harrison Huff b. 1 Jan 1843 d. 29 Apr 1919
- 12 Hezekiah Lafayette Huff [1.1.1.1.3.12.7.3.1.5.1.1]
b. 17 Sep 1866 d. 12 Dec 1957 [ =>]
- 12 Hezekiah Lafayette Huff [1.1.1.1.3.12.7.3.1.5.1.1]
- 11 Martha Jane Batson [1.1.1.1.3.12.7.3.1.5.1]
- 10 Mary A Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.6]
b. 1823 d. 2 May 1889
- 10 Benjamin Franklin Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.7]
b. 23 Mar 1825 d. 2 May 1909
- 10 Wiley Ann Howard [1.1.1.1.3.12.7.3.1.1]
- 9 Thomas Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.3.2]
b. 19 Dec 1787 d. 28 Apr 1868
Sarah Sally Cook b. 17 Jan 1795 d. 24 Mar 1859
- 10 Nancy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.1]
b. 1815 d. 1891
- 10 William Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2]
b. 30 Apr 1819 d. 15 Apr 1911
- + Mary Louisa Stone b. 29 Oct 1817 d. 24 Aug 1852
Nancy Clairy Hair b. 17 Dec 1835 d. 28 Feb 1918
- 11 Fannie Hair Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.1]
b. 5 Apr 1855 d. 19 May 1873
- 11 Caroline Ione Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.2]
b. 13 Mar 1857 d. 5 Feb 1938
James Austin West b. 12 Jan 1856 d. 26 Oct 1923
- 12 William Goldsmith West [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.2.1]
b. 16 Sep 1876 d. 11 Nov 1919 [ =>]
- 12 Ione May West [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.2.2]
b. 4 May 1879 d. 20 Jul 1962
- 12 Sargeant Harley West, Sr [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.2.3]
b. May 1881 d. 28 Oct 1937 [ =>]
- 12 James Austin West, Jr. [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.2.4]
b. 16 Aug 1890 d. 23 Jul 1926
- 12 William Goldsmith West [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.2.1]
- 11 Sallie A. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.3]
b. Abt 1860
- 11 Hattie S Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.4]
b. Jun 1864
- 11 Peter H. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.5]
b. Abt 1866
- 11 Rosa H. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.6]
b. Abt 1869
- 11 James W Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.7]
b. Abt 1871
- 11 May Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.8]
b. Abt 1872
- 11 John S Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.9]
b. Jun 1874
- 11 Fannie Hair Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.2.1]
- + Mary Louisa Stone b. 29 Oct 1817 d. 24 Aug 1852
- 10 Thomas Goldsmith, Jr [1.1.1.1.3.12.7.3.2.3]
b. 29 May 1826 d. 14 Mar 1880
Mary Elizabeth Charles b. 9 Dec 1834 d. 30 Jun 1914
- 11 Charles Homer Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.3.1]
b. 8 Dec 1854 d. 1 May 1919
- 11 Charles Homer Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.3.1]
- 10 Nancy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.2.1]
- 9 John Alexander Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3]
b. 19 Dec 1787 d. 28 Jun 1825
Elizabeth Marchbanks b. 1789 d. 1830
- 10 William Alexander Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1]
b. 1812 d. 9 Mar 1864
Mary Jane Polly Buckner b. 1812 d. 1854
- 11 John Anderson Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.1]
b. 1836 d. 9 Dec 1891
Nancy Caroline McMahan b. 26 Mar 1833 d. 18 Jun 1913
- 12 Zebulon Vance Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.1.1]
b. 12 Jun 1860 d. 24 Oct 1938 [ =>]
- 12 Zebulon Vance Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.1.1]
- 11 Nancy Caroline Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.2]
b. 8 Apr 1837 d. 18 Sep 1895
- 11 Thomas A Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.3]
b. 1840
- 11 William M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.4]
b. 1842 d. 9 Mar 1864
- 11 James P Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.5]
b. 1844 d. 28 Jan 1865
- 11 Berry E Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.6]
b. 18 Sep 1846 d. 27 Oct 1929
- + Minerva Jane McKinney b. Abt 1847
- + Minerva Jane McKinney b. Abt 1847
- 11 Stephen Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.7]
b. 1848
- 11 Albert Lafayette Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8]
b. 4 Dec 1852 d. 18 Nov 1922
Ellender Carrie Shelton b. 6 May 1848 d. 4 Jul 1907
- 12 Letha Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.1]
b. 29 Aug 1876 d. 11 Jan 1946
- 12 Ida Mae Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.2]
b. 19 Jun 1877 d. 22 Oct 1925 [ =>]
- 12 Stephen Oliver Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.3]
b. 17 Aug 1881 d. 5 Sep 1958
- 12 William J Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.4]
b. 4 Sep 1887 d. 31 Jul 1947
- 12 Laura Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.5]
b. 24 Sep 1889 d. 14 Apr 1967
- 12 Sue Anna Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.6]
b. 31 Jul 1892 d. 13 Feb 1984
- 12 Letha Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.1]
Loruma Loary Lunsford b. 11 Jun 1883 d. 28 Feb 1941
- 12 Lillie Mae Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.7]
b. 29 Mar 1911 d. 30 Dec 1988
- 12 Henry Edison Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.8]
b. 28 Mar 1914 d. 9 Mar 1963
- 12 Robert Hampton Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.9]
b. 27 Feb 1915 d. 1985
- 12 Clara Myrtle Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.10]
b. 26 Sep 1918 d. 7 Sep 2013
- 12 Lillie Mae Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.8.7]
- 11 Doctor Y Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.9]
b. 1854
- 11 John Anderson Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.1]
Mary Ann McMahan b. Abt 1830
- 11 Franklin Pierce Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.10]
b. 8 Nov 1856 d. 13 Sep 1931
Rachel Mariana Duncan b. Abt 1855 d. Bef 1900
- 12 John William Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.10.1]
b. 27 Apr 1878 d. 9 Mar 1959 [ =>]
- 12 John William Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.10.1]
- 11 Harriet M C Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.11]
b. 1859
- 11 Marcus Ervin Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12]
b. 27 Aug 1860 d. 8 Aug 1947
Ollie Lavinia Mullinax b. 30 May 1875 d. 29 Jan 1963
- 12 Mary Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12.1]
b. Oct 1892
- 12 Birtha Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12.2]
b. Mar 1894
- 12 Ida Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12.3]
b. Apr 1896
- 12 Lennie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12.4]
b. Apr 1899
- 12 William Marion Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12.5]
b. 7 Mar 1907 d. 2 Sep 1962
- 12 Mary Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.12.1]
- 11 Lydia Matilda Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.13]
b. 11 Nov 1863 d. 22 Jun 1948
Kelsey Douglas Radford b. 25 Sep 1858 d. 20 Nov 1945
- 12 Jewel Edgar Radford [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.13.1]
b. 13 Sep 1898 d. 17 Oct 1979 [ =>]
- 12 Jewel Edgar Radford [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.13.1]
- 11 Franklin Pierce Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1.10]
- 10 Milly Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.2]
b. 1814 d. 1820
- 10 Elizabeth Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3]
b. 5 Jun 1818 d. 24 Sep 1909
James Alexander Bradley, (Xfer) b. 1813 d. 1891
- 11 William Turner Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.1]
b. 25 Sep 1847 d. 19 Mar 1926
Mary Louise Holcombe b. Abt 1852 d. 10 Oct 1920
- 12 Sue Estes Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.1.1]
b. 2 Feb 1876 d. 21 Jul 1962 [ =>]
- 12 Sue Estes Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.1.1]
- 11 Lucinda Susan Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.2]
b. 1852 d. 1922
Rufus Smith Penland b. 1845 d. 1908
- 12 Alexander Elmore Penland [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.2.1]
b. 1874 d. 1964 [ =>]
- 12 Rufus S Penland [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.2.2]
b. 1884 d. 1950 [ =>]
- 12 Thomas Noble Penland [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.2.3]
b. 2 Feb 1887 d. 9 Jul 1975 [ =>]
- 12 Alexander Elmore Penland [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.2.1]
- 11 Nelson Morgan Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3]
b. 12 May 1856 d. 3 Jan 1923
Adina C F Freeman b. Mar 1860 d. 1937
- 12 Alfred Robert Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.1]
b. 8 May 1878 d. 1958 [ =>]
- 12 Curtis E Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.2]
b. Nov 1882
- 12 Don D Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.3]
b. Aug 1886
- 12 Bertha L Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.4]
b. Jul 1888
- 12 Lula E Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.5]
b. 4 Dec 1890 d. 23 Aug 1980 [ =>]
- 12 Minnie M Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.6]
b. Feb 1894
- 12 Alfred Robert Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.3.1]
- 11 William Turner Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.3.1]
- 10 Massey Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.4]
b. 1820 d. 1825
- 10 Lucy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.5]
b. 1822 d. 1825
- 10 John Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.6]
b. 10 Jul 1824 d. 12 Dec 1911
Naomi Bryan Corn b. 2 Apr 1832 d. 25 Aug 1909
- 11 Mary Ann Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.6.1]
b. 20 Apr 1866 d. 4 Aug 1952
Thomas Bedford Faver b. 29 Feb 1864 d. 29 Jul 1948
- 12 May Malinda Faver [1.1.1.1.3.12.7.3.3.6.1.1]
b. 1888 d. 1972 [ =>]
- 12 Lon Bedford Faver [1.1.1.1.3.12.7.3.3.6.1.2]
b. 2 Dec 1906 d. 26 Feb 1972 [ =>]
- 12 May Malinda Faver [1.1.1.1.3.12.7.3.3.6.1.1]
- 11 Mary Ann Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.6.1]
- 10 Matilda Lucinda Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7]
b. 28 Jul 1824 d. 15 Oct 1903
John Alexander Robbins b. 1824 d. 1867
- 11 Wiley Marion Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1]
b. 5 Oct 1851 d. 13 Mar 1916
Mary Elizabeth Miracle Breach b. 3 Oct 1858 d. 2 Jul 1932
- 12 John Alexander Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.1]
b. 27 Jun 1873 d. 11 Nov 1956 [ =>]
- 12 Wilburn Thomas Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.2]
b. 29 Oct 1876 d. 16 Jan 1959
- 12 Nancy J. Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.3]
b. Aug 1879
- 12 Hiram Cleveland Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.4]
b. 25 Apr 1884 d. 1 Feb 1955
- 12 Rev Gale Ward Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.5]
b. 8 Jun 1893 d. 19 Jun 1979
- 12 Jonathan Garrett Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.6]
b. 16 Jan 1897 d. 20 Feb 1974
- 12 John Alexander Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1.1]
- 11 Mary Elizabeth Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.2]
b. 1857 d. 10 Sep 1896
Criswell H Bose Key b. 1851 d. Abt 1886
- 12 Elizabeth Key [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.2.1]
b. 11 Nov 1876 d. 9 Dec 1945 [ =>]
- 12 Elizabeth Key [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.2.1]
- 11 Wiley Marion Robbins [1.1.1.1.3.12.7.3.3.7.1]
- 10 Sarah Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.8]
b. 1826
Jonathan Wesley Bradley, (Xfer) b. 1815 d. 1864
- 11 Martha Jane Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.8.1]
b. 9 Feb 1858 d. 3 Dec 1934
James Alfred Cook b. 30 Jun 1860 d. 4 Jul 1940
- 12 Sarah Naomi Cook [1.1.1.1.3.12.7.3.3.8.1.1]
b. 31 Mar 1887 d. 7 Mar 1965 [ =>]
- 12 Sarah Naomi Cook [1.1.1.1.3.12.7.3.3.8.1.1]
- 11 Martha Jane Bradley [1.1.1.1.3.12.7.3.3.8.1]
- 10 William Alexander Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.3.1]
- 9 William Thomas Goldsmith, Jr [1.1.1.1.3.12.7.3.4]
b. 4 Mar 1796 d. 5 Sep 1852
Lucretia Lucy Johnson b. 1811 d. 15 Oct 1874
- 10 George Washington Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1]
Temperance Loveless
- 11 James A Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1]
b. 1851
Letha P b. 1853
- 12 Elery Macklin Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1.1]
b. 1875 d. 1939 [ =>]
- 12 Gertrude L Miller [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1.2]
b. 1885
- 12 Musella W Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1.3]
b. 1891
- 12 James H Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1.4]
b. 1894
- 12 Elery Macklin Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1.1]
- 11 James A Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1.1]
- 10 Elizabeth Jane Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2]
b. 22 Nov 1828 d. 16 May 1899
Benjamin F Veal b. 11 Nov 1821 d. 3 Sep 1889
- 11 Elizabeth Louise Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.1]
b. 1850
- 11 Mary E Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.2]
b. 1854
- 11 Benjamin Hill Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3]
b. 15 Jan 1858 d. 5 Feb 1921
Lucy Caroline Peacock b. 19 Mar 1859 d. 21 Jun 1910
- 12 W Franklin Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3.1]
b. 12 Nov 1884 d. 18 Aug 1902
- 12 Hattie Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3.2]
b. May 1888 d. 1972
- 12 Toulmine Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3.3]
b. 2 Jul 1889 d. 5 Oct 1961
- 12 Sarah Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3.4]
b. Feb 1894 d. 1986
- 12 Lucy Harrison Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3.5]
b. Sep 1896 d. 1936
- 12 W Franklin Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.3.1]
- + Carrie Scott Benson b. 20 Feb 1874 d. 11 Oct 1947
- 11 Bartie Cornelia Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.4]
b. 30 Dec 1860 d. 8 Jan 1926
William Mason Ragsdale, Sr b. 30 Nov 1854 d. 21 Jul 1903
- 12 Benjamin Elijah Ragsdale [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.4.1]
b. 1889 d. 1953
- 12 William Mason Ragsdale, Jr [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.4.2]
b. 1891 d. 1960
- 12 Benjamin Elijah Ragsdale [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.4.1]
- 11 Ada Jane Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.5]
b. Feb 1864
- + Joseph T Hamilton b. Mar 1864
- + Joseph T Hamilton b. Mar 1864
- 11 Lucy G Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.6]
b. 30 Aug 1867 d. 6 Sep 1899
- + Julius O Wells b. 1866 d. 1931
- + Julius O Wells b. 1866 d. 1931
- 11 Annie Rebecca Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.7]
b. 23 Aug 1870 d. 5 Feb 1956
Ollie E Torrey b. May 1869
- 12 Benjamin Leslie Torrey [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.7.1]
b. 11 Jun 1896 d. 30 Aug 1945 [ =>]
- 12 Benjamin Leslie Torrey [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.7.1]
- 11 Elizabeth Louise Veal [1.1.1.1.3.12.7.3.4.2.1]
- 10 H L Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.3]
b. 1832
- 10 Emily T Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.4]
b. 1837
- 10 Mary Lee Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.5]
b. 19 Apr 1839 d. 4 Jan 1892
Lewis H Tumlin b. 19 May 1809 d. 2 Jan 1875
- 11 Lula T Tumlin [1.1.1.1.3.12.7.3.4.5.1]
b. May 1853 d. 1913
- 11 Lewis Henry Tumlin [1.1.1.1.3.12.7.3.4.5.2]
b. 1855 d. 1855
- 11 George Henry Tumlin [1.1.1.1.3.12.7.3.4.5.3]
b. 18 Apr 1856 d. 7 Jul 1890
- 11 Cora Marie Tumlin [1.1.1.1.3.12.7.3.4.5.4]
b. 1857 d. 1870
- 11 Lula T Tumlin [1.1.1.1.3.12.7.3.4.5.1]
- 10 George Washington Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.4.1]
- 9 Amelia Millie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.5]
b. 8 Sep 1800 d. 24 Jul 1863
Josiah Greer b. 11 Oct 1793 d. 2 Feb 1866
- 10 Elizabeth Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.1]
b. 20 Aug 1819 d. 1880
- 10 John Lafette Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.2]
b. 6 Nov 1820 d. 8 Mar 1882
- 10 Catherine Kate Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.3]
b. 1830 d. 4 Nov 1880
- 10 Benjamin Franklin Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.4]
b. 13 May 1833 d. 19 Dec 1914
- 10 Turner Goldsmith Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.5]
b. 5 Sep 1836 d. 2 May 1911
Cordelia Robinson b. 11 Feb 1851 d. 5 Jul 1926
- 11 Turner Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.5.1]
b. Jan 1881
- 11 Edwin Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.5.2]
b. Nov 1882
- 11 Kathrine Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.5.3]
b. Jul 1886 d. Aft 1930
- + George Heard Tunnell b. 31 Oct 1866 d. 8 Jan 1939
- + George Heard Tunnell b. 31 Oct 1866 d. 8 Jan 1939
- 11 Turner Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.5.1]
- 10 James Carson Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.6]
b. 27 May 1838 d. 25 May 1898
- 10 Lucy K Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.7]
b. 9 Nov 1839 d. 8 May 1902
- 10 Elizabeth Greer [1.1.1.1.3.12.7.3.5.1]
- 9 Elizabeth Bettie Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.6]
b. 28 Sep 1802 d. 25 Jun 1892
- + Thomas McCrary b. Abt 1801
- + Thomas McCrary b. Abt 1801
- 9 Major Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7]
b. 28 Sep 1802 d. 25 Jun 1892
Maria Louisa Stokes b. 11 Oct 1812 d. 19 Apr 1887
- 10 William Thomas Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.1]
b. 1831 d. 25 May 1918
Mary Theodosia H b. 1862
- 11 Theodocia M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.1.1]
b. 1897
- 11 Vernon H Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.1.2]
b. 1902
- 11 Theodocia M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.1.1]
- 10 Lucy Elizabeth Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.2]
b. 1 Jan 1832 d. 1 Mar 1859
- 10 Maria Louisa Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.3]
b. 17 Feb 1833 d. 14 Aug 1898
- 10 John Henry Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.4]
b. 11 Nov 1835 d. 4 May 1919
- + Anna Hill Sheldon
Sarah Eliza Peers b. Abt 1842
- 11 M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.4.1]
b. 1859
- 11 M Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.4.1]
- + Anna Hill Sheldon
- 10 Washington Lafayette Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.5]
b. 15 Jul 1837 d. 31 May 1866
- 10 James Manning Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6]
b. 29 Apr 1839 d. 15 Jun 1936
Ann Ellen Dent b. 8 Sep 1842 d. 29 Aug 1928
- 11 Joseph D. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6.1]
b. 1868
- 11 Ida R. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6.2]
b. 1870
- 11 Jennie V Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6.3]
b. 1873
- 11 James Manning Goldsmith, Jr [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6.4]
b. 1875 d. 5 Jul 1957
- 11 Annie D Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6.5]
b. 1877 d. 11 Aug 1933
- 11 Joseph D. Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.6.1]
- 10 Jeremiah Wickliffe Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7]
b. 6 Mar 1841 d. 27 Aug 1925
Mary Eliza Meador b. 21 Dec 1847 d. 2 Oct 1884
- 11 Paul Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7.1]
b. 26 Jan 1875 d. 23 Jan 1922
Elizabeth Barnes Fitten b. 28 Feb 1878 d. 21 Nov 1947
- 12 John Fitten Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7.1.1]
b. 1902 d. 1966 [ =>]
- 12 Jere Wycliff Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7.1.2]
b. 20 Sep 1909 d. 5 Feb 1987 [ =>]
- 12 John Fitten Goldsmith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7.1.1]
- 11 Dr John Meador Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7.2]
b. 6 Apr 1878 d. 26 Oct 1909
- 11 Paul Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.7.1]
- 10 Paul Turner Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.8]
b. 18 Oct 1844 d. 3 Nov 1868
- 10 Frances Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.9]
b. 1847 d. 1850
- 10 Theodore Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.10]
b. 1849 d. 1850
- 10 William Thomas Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.7.1]
- 9 Sarah Sally Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.8]
b. 1805 d. Aft 1880
- 9 Nancy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.9]
b. 1807 d. 1891
- + James M Austin b. 1813 d. 18 Oct 1848
- + James M Austin b. 1813 d. 18 Oct 1848
- 9 Lucy Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.10]
b. 1813
William Daugherty, Sr d. Abt 1839
- 10 William Daugherty, Jr [1.1.1.1.3.12.7.3.10.1]
b. Abt 1830
- 10 Benjamin Daugherty [1.1.1.1.3.12.7.3.10.2]
b. Abt 1830
- 10 William Daugherty, Jr [1.1.1.1.3.12.7.3.10.1]
- 9 Mary Ann Polly Goldsmith [1.1.1.1.3.12.7.3.1]
- 8 Rebecca Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.4]
b. 1769 d. 4 Jan 1858
Cushman Ruggles Edson b. 11 Dec 1762
- 9 Dicey Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.4.1]
b. Abt 1790
- 9 Dicey Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.4.1]
Batte Birdsong b. 1753 d. 20 Aug 1813
- 9 John Birdsong Rountree [1.1.1.1.3.12.7.4.2]
b. 1792 d. 24 Jun 1872
- + Martha Collins b. 1 Mar 1827
- + Martha Collins b. 1 Mar 1827
- 9 John Birdsong Rountree [1.1.1.1.3.12.7.4.2]
Ezekiel Pennington b. Abt 1768 d. Abt 1799
- 9 Richardson Pennington [1.1.1.1.3.12.7.4.3]
b. Abt 1797
- 10 Richard Pennington [1.1.1.1.3.12.7.4.3.1]
b. Abt 1824
- 10 Richard Pennington [1.1.1.1.3.12.7.4.3.1]
- 9 Henry Pennington [1.1.1.1.3.12.7.4.4]
b. Sep 1799
- 9 Richardson Pennington [1.1.1.1.3.12.7.4.3]
Samuel Stalnaker, ¶ b. 1762 d. 1826
- 9 Martha Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.5]
- 9 Clary Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.6]
b. 1803
- + Samuel Hemphill b. 1785 d. 1860
- + Samuel Hemphill b. 1785 d. 1860
- 9 Mildred Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.7]
b. 1804 d. 2 May 1859
Robert Alton b. 1802
- 10 Mary Ann Alton [1.1.1.1.3.12.7.4.7.1]
Robert A Quarles
- 11 Nancy Mildred Quarles [1.1.1.1.3.12.7.4.7.1.1]
W B Powell
- 12 Albert Thomas Powell [1.1.1.1.3.12.7.4.7.1.1.1]
b. Abt 1881 [ =>]
- 12 Albert Thomas Powell [1.1.1.1.3.12.7.4.7.1.1.1]
- 11 Nancy Mildred Quarles [1.1.1.1.3.12.7.4.7.1.1]
- 10 Mary Ann Alton [1.1.1.1.3.12.7.4.7.1]
- 9 Sebron Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8]
b. 27 Oct 1807 d. 9 Feb 1887
Amanda F Harris b. 26 Mar 1823 d. 24 Apr 1870
- 10 Martha E Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8.1]
b. 1847
- 10 E A Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8.2]
b. 1849
- 10 S L Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8.3]
b. 1854
- 10 T E Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8.4]
b. 1857
- 10 Sebron Christie Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8.5]
b. 25 Apr 1859 d. 31 May 1925
- + Mary Caroline Aiton b. 4 Mar 1862 d. 13 Jul 1938
- + Mary Caroline Aiton b. 4 Mar 1862 d. 13 Jul 1938
- 10 Martha E Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.8.1]
- 9 Martha Stalnaker [1.1.1.1.3.12.7.4.5]
- 8 Mary Molly Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.5]
b. 1772 d. 6 Oct 1851
Major Elijah Lige Wilbourn b. 1 Jun 1763 d. 1 Jun 1819
- 9 Martha Patsy Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.1]
b. 1 Jun 1791 d. 1 Jun 1875
Benjamin Hays b. 1 Jun 1807 d. 8 Feb 1867
- 10 Thomas Benjamin Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1]
b. 1835
Nancy Elizabeth Martin b. 1834 d. 1909
- 11 Julia Vandalia Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.1]
b. 20 Jun 1864 d. 2 May 1934
- 11 Benjamin Frank Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.2]
b. Sep 1867
- 11 William Andrew Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.3]
b. 1868 d. 1940
- 11 Thomas Enoch Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4]
b. 12 Feb 1870 d. 22 Dec 1945
Minnie L Baumgardner b. 14 Nov 1872 d. Aug 1968
- 12 Alvin Adolphus Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.1]
b. 12 Apr 1892 d. 9 Feb 1975
- 12 Laura Elmira Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.2]
b. 23 Aug 1892 d. 12 Mar 1952
- 12 Clyde Thomas Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.3]
b. 5 Mar 1894
- 12 Zola Elizabeth Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.4]
b. 21 Mar 1896
- 12 Ruby Lela Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.5]
b. 17 Aug 1898
- 12 Doyle Dakota Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.6]
b. 28 Apr 1902
- 12 Gladys Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.7]
b. 10 Nov 1904
- 12 Esther Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.8]
b. 29 Jan 1912 d. 1914
- 12 Alvin Adolphus Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.4.1]
- 11 Julia Vandalia Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1.1]
- 10 Harvey W Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.2]
b. 1837
- 10 Thomas Benjamin Hays [1.1.1.1.3.12.7.5.1.1]
- 9 Sabra Ann Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.2]
b. 1792 d. 26 Jun 1864
Hiram Gibbs, Sr b. 30 Aug 1785 d. 9 Sep 1844
- 10 Dr Jasper Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.1]
b. 2 Jun 1810 d. 20 Aug 1877
- 10 Thomas Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.2]
b. 6 Jan 1812 d. 18 May 1872
- 10 Mary Ann Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.3]
b. 16 Nov 1814 d. 9 Oct 1864
- + Canfield
- + Canfield
- 10 William Wilbourn Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.4]
b. 6 Apr 1816 d. 7 Jan 1844
- 10 Lucinda Benson Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.5]
b. 28 Mar 1818 d. 22 Sep 1884
- 10 Sanford St John Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.6]
b. 7 Jul 1819 d. 30 Sep 1886
- 10 Angeline Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.7]
b. 18 Dec 1822 d. 6 Mar 1846
- 10 Hiram Gibbs, Jr [1.1.1.1.3.12.7.5.2.8]
b. 26 Jan 1829 d. 17 Dec 1869
- 10 Dr Jasper Gibbs [1.1.1.1.3.12.7.5.2.1]
- 9 Dorcas Lucinda Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.3]
b. 1794 d. 1873
John Drayton Nance b. 26 Nov 1792 d. 21 Oct 1836
- 10 Harvey Elijah Wilbourn Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1]
b. 25 Mar 1834 d. 23 Feb 1917
Elsie Mary Hillyer b. 4 Jan 1844 d. 17 Jan 1876
- 11 Ida Wilbourn Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.1]
b. 18 Aug 1867 d. Abt 1945
William Mason Henry b. 1 Oct 1861 d. 18 Jun 1925
- 12 Madge Henry [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.1.1]
- 12 Madge Henry [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.1.1]
- 11 Ida Wilbourn Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.1]
Nancy Ann Embry b. 20 Feb 1842 d. 20 Mar 1888
- 11 Lula F Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.2]
b. 9 Jun 1862 d. 1 Jan 1890
- + Dr William Wesley Boyd b. 15 Jul 1853 d. 28 Feb 1928
- + Dr William Wesley Boyd b. 15 Jul 1853 d. 28 Feb 1928
- 11 Eddie C Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.3]
b. 22 Jun 1865 d. 15 Sep 1910
Sarah Love Bryan b. 28 Sep 1868 d. 4 Nov 1924
- 12 Charles Wilborn Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.3.1]
b. 27 Aug 1896 d. 21 Jan 1907
- 12 Charles Wilborn Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.3.1]
- + Hattie Maxwell b. 1882 d. 1918
- 11 Senis Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.4]
b. 1872
- 11 Caroline Lee Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.5]
b. 11 Oct 1873 d. 31 Dec 1915
William Adolphus Bryan b. 24 Jul 1870 d. 24 Dec 1931
- 12 Terrell Bryan [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.5.1]
- 12 Nancy L Bryan [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.5.2]
b. 16 Jan 1902 d. Dec 1975 [ =>]
- 12 Terrell Bryan [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.5.1]
- 11 Annie Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.6]
b. 18 Sep 1876 d. 20 Dec 1953
- 11 John D Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.7]
b. 1878
- 11 Lula F Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1.2]
- 10 Harvey Elijah Wilbourn Nance [1.1.1.1.3.12.7.5.3.1]
- 9 Major William Rountree Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4]
b. 15 Dec 1796 d. 10 Jan 1868
Chloe Mariah Sanders b. 25 Feb 1807 d. 21 Sep 1875
- 10 Madison Wallace Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4.1]
b. 28 Jan 1830 d. 15 Oct 1861
- 10 Caroline Virginia Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4.2]
b. 1834 d. 1860
- 10 C C Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4.3]
b. 1836
- 10 Miles W Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4.4]
b. 1838 d. Aft 1900
- + Annie Henry Ross b. 12 Mar 1846 d. 18 Dec 1870
- + Annie Henry Ross b. 12 Mar 1846 d. 18 Dec 1870
- 10 Victoria Josephine Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4.5]
b. 1840 d. 25 Sep 1845
- 10 Madison Wallace Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.4.1]
- 9 Nancy Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.5]
b. 1800 d. 1860
- + Fleming Brown Nance b. 15 Oct 1794 d. Abt 1832
- + Fleming Brown Nance b. 15 Oct 1794 d. Abt 1832
- 9 Mildred Rountree Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.6]
b. 10 Feb 1801 d. 2 May 1874
Alexander Pruet b. 14 Apr 1794 d. 16 Sep 1867
- 10 Carson Wilburn Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.1]
b. 12 Jun 1819 d. 15 Aug 1904
- 10 Jeffery Wilbourne Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2]
b. 20 Dec 1822 d. 17 Sep 1903
Mary Ann Riley b. 12 Dec 1824 d. 28 Mar 1862
- 11 Lucretia Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2.1]
b. 26 Jan 1849 d. 24 Dec 1929
Columbus Taylor b. 12 Oct 1844 d. 1 Nov 1912
- 12 William Oscar Taylor [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2.1.1]
b. 10 Dec 1873 d. 19 Jan 1923
- 12 Gertrude Taylor [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2.1.2]
b. 24 Apr 1878 d. 3 Aug 1975
- 12 William Oscar Taylor [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2.1.1]
- 11 Susie Elizabeth Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2.2]
b. 30 Jul 1860 d. 27 Jul 1942
- + Charles Wiley Martin b. 18 Nov 1859 d. 10 Nov 1943
- + Charles Wiley Martin b. 18 Nov 1859 d. 10 Nov 1943
- 11 Lucretia Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.2.1]
- 10 Mary Ann Lucretia Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.3]
b. 31 Oct 1824 d. 2 Aug 1849
- 10 Sanford Ellison Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.4]
b. 11 Feb 1828 d. 26 Dec 1864
- 10 George James Obediah Elijah Wilbourne Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.5]
b. 16 Jan 1830 d. 14 Jan 1865
- 10 Madison Floyd Pruet, Sr [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6]
b. 7 Aug 1832 d. 9 Mar 1914
Julia Ann Castleberry b. 1835 d. 1862
- 11 Sarah A S Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.1]
b. 1854
- 11 Anna L Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.2]
b. 1857
- 11 Madison Floyd Pruet, Jr [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.3]
b. 1858 d. 5 Jul 1918
- 11 Elizabeth M Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.4]
b. 1861
- 11 Sarah A S Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.1]
Nancy Jane Lawrence b. 1842 d. 1890
- 11 Julia Etta F Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.5]
b. 4 Jul 1865 d. 29 May 1905
Robert Fulton Brown b. 4 Sep 1865 d. 2 Mar 1941
- 12 Addie May Brown [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.5.1]
b. 1895 d. Bef 1975
- 12 Robert Neal Brown [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.5.2]
b. 10 Nov 1896 d. 10 Aug 1978 [ =>]
- 12 Addie May Brown [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.5.1]
- 11 Nancy J Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.6]
b. Abt 1866
- 11 Olive Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.7]
b. 1869
- 11 Arra A Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.8]
b. 1870
- 11 William Alexander Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.9]
b. Sep 1871 d. 1924
Iva Clara Skinner b. 4 Mar 1877 d. 27 Jun 1964
- 12 Ive Bernice Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.9.1]
b. 21 Dec 1911 d. 28 Mar 1998 [ =>]
- 12 Ive Bernice Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.9.1]
- 11 Martha A Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.10]
b. 1876
- 11 Ida J Pruett [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.11]
b. Mar 1879
Horace Langford b. 6 May 1878
- 12 Percy L Langford [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.11.1]
b. 1903
- 12 Larence W Langford [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.11.2]
b. 1905
- 12 Percy L Langford [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.11.1]
- 11 John Claude Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.12]
b. Jan 1886 d. 1971
- 11 Julia Etta F Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.6.5]
- 10 Mildred Rountree Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.7]
b. 27 Sep 1834 d. 30 Sep 1834
- 10 Jasper Alexander Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.8]
b. 15 Sep 1835 d. 28 Jun 1899
- 10 John Robert Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.9]
b. 24 Mar 1838 d. 16 Jun 1863
- 10 Eliza Jane Mildred Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.10]
b. 5 Mar 1840 d. 12 Jun 1857
- 10 William H H Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.11]
b. 14 Apr 1842 d. 3 Apr 1862
- 10 Wilbourne Rountree Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.12]
b. 27 Feb 1844 d. 1 Jan 1921
- 10 Carson Wilburn Pruet [1.1.1.1.3.12.7.5.6.1]
- 9 Colonel Sandford Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7]
b. 1803 d. 17 Apr 1874
Mary Nancy Burge b. 1812 d. 16 Apr 1876
- 10 Frances E Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.1]
b. 1835 d. 6 Sep 1871
- 10 Adaline Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.2]
b. 1837
Henry Bolling Dandridge b. 1823
- 11 Rosalie Lightford Dandridge [1.1.1.1.3.12.7.5.7.2.1]
b. 1868
- 11 Henry B. Dandridge [1.1.1.1.3.12.7.5.7.2.2]
b. 1870
- 11 Nancy B. Dandridge [1.1.1.1.3.12.7.5.7.2.3]
b. 1874
- 11 Rosalie Lightford Dandridge [1.1.1.1.3.12.7.5.7.2.1]
- 10 William H Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.3]
b. 1839
- 10 Iverson Graves Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.4]
b. 10 Jan 1841 d. 1893
Maggie Key b. 18 Mar 1853 d. 28 Oct 1925
- 11 John Dickens Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.4.1]
b. 16 Oct 1878 d. 25 Nov 1949
- 11 John Dickens Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.4.1]
- 10 Jack Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.5]
b. 25 Jul 1842 d. 15 Dec 1843
- 10 Sandford Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.6]
b. 1845
- 10 Lucius Lamar Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7]
b. 3 Oct 1845 d. 28 Oct 1884
Drucilla Catherine Braden b. 7 Sep 1847 d. 18 May 1886
- 11 Frank Dickens Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.1]
b. Abt 1871
- 11 Hattie May Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.2]
b. 8 Dec 1873 d. 26 May 1964
Henry Waring Butler b. 8 May 1870 d. 24 Jan 1941
- 12 Isabel Butler [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.2.1]
b. 10 Mar 1898 d. 6 Jun 1967
- 12 Sanford Warring Butler [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.2.2]
b. 5 Nov 1899 d. 29 Jul 1933
- 12 Margaret Butler [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.2.3]
b. 20 Mar 1908 d. 1 Mar 1999
- 12 Isabel Butler [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.2.1]
- 11 Katie Bell Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.3]
b. 8 Aug 1875 d. 1 Mar 1964
- + Edwin Allen b. 1872 d. 6 Jul 1926
- + Edwin Allen b. 1872 d. 6 Jul 1926
- 11 Maggie Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.4]
b. Abt 1878
- 11 Robert Jenkins Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.5]
b. 1 Nov 1879 d. 20 Jul 1904
- 11 Frank Dickens Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.7.1]
- 10 Banner Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.8]
b. 1847
- 10 Lucinda G Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.9]
b. 17 Apr 1848 d. 1 Jun 1848
- 10 Frances E Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.7.1]
- 9 James Rogers Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8]
b. 1804 d. Aug 1863
Martha Ferguson b. 1807 d. 1880
- 10 Jefferson Dillard Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8.1]
b. 1844 d. 1918
Sarah Ann Cross b. 1862 d. 1945
- 11 J Oscar Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8.1.1]
b. 1885 d. 1957
Golda Rogers b. 1897 d. 1965
- 12 Rose Aileen Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8.1.1.1]
b. 9 Sep 1932 d. 17 Sep 2006 [ =>]
- 12 Rose Aileen Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8.1.1.1]
- 11 J Oscar Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8.1.1]
- 10 Jefferson Dillard Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.8.1]
- 9 Elijah Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9]
b. 4 Mar 1810 d. 14 Jul 1878
Elizabeth Madison Dugan b. 14 May 1815 d. 10 Aug 1876
- 10 Gary Wood Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.1]
b. 23 Jun 1839 d. Feb 1844
- 10 Captain Jasper Gibbs Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2]
b. 23 Jul 1840 d. 17 Oct 1918
Mary Seawell Shaw b. 11 May 1844 d. 7 Aug 1928
- 11 Cameron Ernest Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1]
b. 22 Oct 1870 d. 10 Oct 1956
Mary Edenton Kyle b. 4 Apr 1885 d. 18 Feb 1978
- 12 Finis Kyle Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1.1]
b. 31 May 1902 d. 17 Jun 1993
- 12 Cameron R Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1.2]
b. 1904
- 12 Clara Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1.3]
b. 1906
- 12 Mary Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1.4]
b. 1909
- 12 Baby Boy Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1.5]
b. 9 Aug 1915 d. 9 Aug 1915
- 12 Finis Kyle Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1.1]
- 11 Sallie Mae Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.2]
b. 18 Jul 1877 d. 28 Aug 1955
- + Dr John Levi Roland b. 10 Jul 1885 d. 5 Nov 1935
- + Dr John Levi Roland b. 10 Jul 1885 d. 5 Nov 1935
- 11 Fannie L Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.3]
b. 10 Jan 1880 d. 16 Sep 1961
- + Eugene Wilso McKinstry b. Abt 1881
- + Eugene Wilso McKinstry b. Abt 1881
- 11 Cameron Ernest Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.2.1]
- 10 Jane Texana Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.3]
b. 23 Sep 1843 d. 18 Jun 1872
- 10 Mary Ella Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.4]
b. 21 Sep 1846 d. 28 Jun 1860
- 10 Alice Virginia Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5]
b. Mar 1851 d. Oct 1918
William Alfred Cox Shell b. Mar 1854 d. Oct 1913
- 11 Nora Madison Shell [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.1]
b. 1874
- 11 Lillie May Shell [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.2]
b. 1880
- 11 Mary Shell [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.3]
b. Jun 1886
- 11 Benjamin Franklin Shell [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.4]
b. 14 Mar 1889 d. 24 May 1971
Vera Alea Davis b. Abt 1890
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.4.1]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.4.1]
- 11 Ella Virginia Shell [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.5]
b. 27 Oct 1892 d. 29 Dec 1960
Henry Marshall Howard b. 13 May 1888 d. 4 Nov 1951
- 12 Helen Irene Howard [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.5.1]
b. 14 Oct 1912 d. 20 Oct 1992
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.5.2]
- 12 Glen Dale Howard [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.5.3]
b. 4 Oct 1920 d. 3 Nov 1971 [ =>]
- 12 Helen Irene Howard [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.5.1]
- 11 Nora Madison Shell [1.1.1.1.3.12.7.5.9.5.1]
- 10 William Sanford Wilbourn, Sr [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6]
b. 14 Aug 1853 d. 18 Mar 1935
Victoria Josephie Saunders b. 26 Apr 1853 d. 14 Jul 1924
- 11 Ella WIlbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.1]
b. 4 Dec 1875 d. 9 Nov 1948
- + Jackson b. Abt 1874
- + Jackson b. Abt 1874
- 11 Reuben Elijah Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2]
b. 28 Nov 1877 d. 14 Nov 1963
Rosa E Bedenbaugh b. 11 Sep 1881 d. 18 Apr 1957
- 12 Birdie Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2.1]
b. 18 Oct 1904 d. 10 May 1987
- 12 Lamar Davis Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2.2]
b. 29 Nov 1908 d. 14 Mar 2004 [ =>]
- 12 Rosa May Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2.3]
b. 20 May 1910 d. 16 Jun 1998
- 12 Ulyssees Wilson Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2.4]
b. 8 Mar 1912 d. 7 Dec 1920
- 12 Audrey Carmen Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2.5]
b. 15 Feb 1914 d. 23 Apr 1915
- 12 Birdie Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.2.1]
- 11 Jannie Pearl Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.3]
b. 1880 d. 1957
- + Charles Wesley Baley b. 1881 d. 1957
- + Charles Wesley Baley b. 1881 d. 1957
- 11 William Sanford Wilbourn, Jr [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.4]
b. 8 Mar 1882 d. 17 Jun 1911
- 11 Archie Y Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.5]
b. 7 Jul 1884 d. 5 Mar 1963
- 11 Ramsey Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.6]
b. 31 Oct 1884 d. 12 May 1894
- 11 Ines Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.7]
b. 5 Dec 1890 d. 12 May 1892
- 11 Minnie Teck Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.8]
b. 28 Dec 1890 d. 11 Aug 1959
- 11 Mattie Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.9]
b. 19 Mar 1895 d. 11 Nov 1953
- + Wildes b. Abt 1894
- + Wildes b. Abt 1894
- 11 Maggie Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.10]
b. 19 Dec 1896 d. 20 Dec 1977
- + Chambers b. Abt 1895
- + Chambers b. Abt 1895
- 11 Ella WIlbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.6.1]
- 10 Gary Wood Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.9.1]
- 9 Jane Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.10]
b. 15 Oct 1811 d. 1890
John Bishop b. 1810 d. 3 Nov 1880
- 10 Adaline Bishop [1.1.1.1.3.12.7.5.10.1]
b. 1835
- 10 Mary Bishop [1.1.1.1.3.12.7.5.10.2]
b. 1842
- 10 Adaline Bishop [1.1.1.1.3.12.7.5.10.1]
- 9 Elizabeth Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.11]
b. 3 Jan 1812 d. 27 Feb 1888
Robert Monroe Robinson b. 2 Mar 1808 d. 12 Sep 1888
- 10 John Robinson [1.1.1.1.3.12.7.5.11.1]
b. 1830
- 10 George Robinson [1.1.1.1.3.12.7.5.11.2]
b. 1832
- 10 Joseph Robinson [1.1.1.1.3.12.7.5.11.3]
b. 1835
- 10 Hiram Hervey Robinson [1.1.1.1.3.12.7.5.11.4]
b. 1846
- 10 John Robinson [1.1.1.1.3.12.7.5.11.1]
- 9 Martha Patsy Wilbourn [1.1.1.1.3.12.7.5.1]
- 8 James Rountree [1.1.1.1.3.12.7.1]
Mildred Hart b. 20 Nov 1752 d. 18 Jan 1816
- 8 Thomas Hart Rountree [1.1.1.1.3.12.7.6]
b. 27 Mar 1778 d. 15 Jul 1828
Mary Gilbert b. Abt 1777
- 9 Katherine C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.6.1]
b. 10 Jun 1803 d. 10 Jun 1867
Reverend Thomas Harbison Shaw b. 17 Sep 1797 d. 23 Feb 1871
- 10 James Harbison Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1]
b. 16 Dec 1821 d. 10 Jan 1914
Elizabeth Varnette Motlow b. 23 Dec 1829 d. 8 Feb 1906
- 11 John Addison Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1]
b. 24 Sep 1847 d. 20 Feb 1923
Texana Chleo Henry b. 13 Dec 1853 d. 5 Aug 1934
- 12 Katie Elizabeth Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1.1]
b. 29 Nov 1882 d. 18 Aug 1950
- 12 Daisy Deen Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1.2]
b. 7 Apr 1884 d. 17 Mar 1935
- 12 Laura Ann Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1.3]
b. 23 Jan 1886 d. 25 Nov 1978
- 12 Arthur Addison Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1.4]
b. 12 Apr 1888 d. 5 Jul 1936 [ =>]
- 12 John William Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1.5]
b. 8 Oct 1891 d. 11 Feb 1958 [ =>]
- 12 Katie Elizabeth Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1.1]
- 11 Virginia Gertrude Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2]
b. 27 Jan 1850 d. 9 Jun 1910
James Baker Benson b. 1840 d. 1900
- 12 Elizabeth Vinetta Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.1]
b. 1 Sep 1867 d. 14 Jun 1897 [ =>]
- 12 Nancy Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.2]
b. 1872 d. 11 Jun 1940 [ =>]
- 12 Josephine Catherine Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.3]
b. 1874 d. 1942 [ =>]
- 12 Laura Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.4]
b. Abt 1878
- 12 Lydia Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.5]
b. Abt 1880
- 12 Johnny Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.6]
b. Mar 1886
- 12 Elizabeth Vinetta Benson [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.2.1]
- 11 Margret Kathryn Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3]
b. 15 May 1854 d. 12 Sep 1918
John Edward Landers b. 7 Oct 1845 d. 24 Sep 1920
- 12 James Isle Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.1]
b. 6 Nov 1874 d. 29 May 1884
- 12 Kathryn Berry Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.2]
b. 19 May 1876 d. 21 Dec 1971 [ =>]
- 12 Delona Elizabeth Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.3]
b. 16 Apr 1878 d. 12 Nov 1965
- 12 Luther Lee Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.4]
b. 24 Sep 1882 d. 9 Aug 1970
- 12 Felix Shaw Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.5]
b. 8 Oct 1884 d. 11 Jun 1961
- 12 Barnet Avery Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.6]
b. 28 May 1888 d. 14 Jul 1965
- 12 James Isle Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.3.1]
- 11 Thomas Harbison Shaw, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.4]
b. 27 Sep 1856 d. 17 Nov 1912
Nannie B Blocker b. 3 Apr 1861 d. 6 Jul 1938
- 12 Thomas Harbison Shaw, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.4.1]
b. 22 Jan 1889 d. 18 May 1963 [ =>]
- 12 Abner Blocker Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.4.2]
b. 28 Jul 1891 d. 28 May 1960
- 12 Thomas Harbison Shaw, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.4.1]
- 11 Felix Motlow Shaw, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.5]
b. 24 Nov 1859 d. 17 Jul 1908
- + Ella Matthews
Florence T Terry b. 29 May 1875 d. 7 Jul 1941
- 12 Ruth Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.5.1]
b. 28 Jul 1896 d. 18 May 1978 [ =>]
- 12 Adele Terry Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.5.2]
b. 5 Nov 1897 d. 26 Jan 1985 [ =>]
- 12 Hazel Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.5.3]
b. Sep 1899 d. 1983
- 12 Felix Motlow Shaw, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.5.4]
b. 28 Oct 1905 d. 17 Jun 1957 [ =>]
- 12 Ruth Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.5.1]
- + Ella Matthews
- 11 Mary Josephine Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.6]
b. 15 Jan 1863 d. 26 Oct 1951
John Everton Martin b. 16 Apr 1851 d. 23 Jan 1934
- 12 Elizabeth Barnella Martin [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.6.1]
b. 2 Dec 1879 d. 4 Nov 1916
- 12 Laura Martin [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.6.2]
b. 17 Sep 1881 d. 17 Mar 1985 [ =>]
- 12 Kathryn Kitty Martin [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.6.3]
b. 25 Jan 1885 d. 30 Apr 1990
- 12 Elizabeth Barnella Martin [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.6.1]
- 11 Laura Ann Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7]
b. 24 Sep 1866 d. 3 Apr 1929
Dr Jacob Coonce Burkett, Sr b. 4 Mar 1860 d. 28 Feb 1933
- 12 Olea Sidney Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.1]
b. 3 Aug 1888 d. 11 Jul 1973
- 12 Bernice Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.2]
b. 21 Oct 1890 d. 2 Jan 1973
- 12 Beulah Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.3]
b. 21 Apr 1893 d. 1983 [ =>]
- 12 Eugene Field Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.4]
b. 4 Mar 1896 d. Feb 1930
- 12 May Moss Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.5]
b. 1 May 1898 d. 1981
- 12 Homer Wells Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.6]
b. 30 Jun 1900 d. 1 Oct 1918
- 12 Jacob Coonce Burkett, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.7]
b. 28 Aug 1903 d. 25 Sep 1962
- 12 Olea Sidney Burkett [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.7.1]
- 11 Daisy Deen Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.8]
b. 28 Jul 1870 d. 18 Oct 1918
- 11 John Addison Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1.1]
- 10 John Addison Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.2]
b. 16 Dec 1821 d. 30 Oct 1829
- 10 William Rountree Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.3]
b. 18 Feb 1824 d. 10 May 1857
Louisa Elizabeth Parks b. 17 Jan 1825 d. 1861
- 11 Francis Marion Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.3.1]
b. 19 Aug 1850 d. 2 Jan 1891
- 11 Francis Marion Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.3.1]
- 10 Thomas Jefferson Shaw, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4]
b. 28 Aug 1825 d. 19 Jan 1892
Susan Minerva Landes b. 1832 d. 1926
- 11 George Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.1]
d. 1870
- 11 Mary E C Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2]
b. 28 Jun 1847 d. 22 Jan 1911
William L Bobo b. 29 Jan 1840 d. 4 Jun 1905
- 12 Kate Bobo [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2.1]
b. Jan 1870
- 12 Edgar Bobo [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2.2]
b. 19 Sep 1880 d. 18 Jul 1911
- 12 Lena Bobo [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2.3]
b. Apr 1883
- 12 Lannie Bobo [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2.4]
b. Apr 1883
- 12 Eugene Bobo [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2.5]
b. May 1885
- 12 Kate Bobo [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.2.1]
- 11 Thomas Jefferson Shaw, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.3]
b. 1853
- 11 Katie Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.4]
b. 1854 d. 1892
Harrison Hopwood Neece b. 1 Oct 1842 d. 27 Mar 1922
- 12 Lucien S Neece [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.4.1]
b. Aug 1885
- 12 Fannie B Neece [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.4.2]
b. May 1887
- 12 Lucien S Neece [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.4.1]
- 11 John F Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.5]
b. 1862
- 11 Tennessee Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.6]
b. 1865
- 11 Laura Ann Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.7]
b. 1867
- 11 Finnettie Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.8]
b. 1869
- 11 Sallie Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.9]
b. 1872
- 11 George Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.4.1]
- 10 Ann Porter Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5]
b. 1 Jan 1827 d. 15 Jun 1885
David Daniel Smoot b. 6 Sep 1814 d. 17 Apr 1863
- 11 Mary Elizabeth Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1]
b. 6 Apr 1843 d. 9 May 1883
Thomas Jefferson Henegar, Sr ¶ b. 31 Aug 1840 d. 3 May 1918
- 12 John Bell Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.1]
b. 13 Apr 1861 d. 23 Dec 1918
- 12 Mary Jane Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.2]
b. 25 Jul 1865 d. 14 May 1943 [ =>]
- 12 Belzora Belle Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.3]
b. 23 Jan 1867 d. 8 Apr 1946 [ =>]
- 12 James Thomas Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.4]
b. 26 Feb 1869 d. 16 May 1951
- 12 William Washington Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.5]
b. 27 Oct 1871 d. 29 Sep 1939
- 12 Lizzie May Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.6]
b. 1 May 1874 d. 23 Oct 1907
- 12 George W Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.7]
b. 14 Oct 1876 d. 29 Sep 1939
- 12 Daisy Lee Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.8]
b. 6 Apr 1881 d. 19 Dec 1971
- 12 Thomas Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.9]
b. 9 May 1883 d. 23 Nov 1883
- 12 John Bell Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1.1]
- 11 Catherine Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.2]
b. 1846 d. 14 Aug 1900
- + Martin Green Osborne b. Abt 1845
- + Martin Green Osborne b. Abt 1845
- 11 Nancy Vanette Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3]
b. 25 Jul 1847 d. 14 Aug 1900
Francis Marion Milton b. 10 Nov 1846 d. 13 Mar 1899
- 12 Charles A Milton [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3.1]
b. 25 Apr 1874 d. 16 Apr 1932
- 12 Dora A Milton [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3.2]
b. Apr 1877
- 12 William Daniel Milton [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3.3]
b. 29 Jul 1879 d. 17 Oct 1954
- 12 Daisy V Milton [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3.4]
b. Jun 1881
- 12 John Thomas Milton [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3.5]
b. 29 Dec 1884 d. Mar 1978 [ =>]
- 12 Charles A Milton [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.3.1]
- 11 Thomas M Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.4]
b. 2 Feb 1849 d. 27 Nov 1920
- 11 William Milton Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.5]
b. 1852 d. 1952
- 11 Benjamin Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.6]
b. 1853 d. 1940
- 11 James Wade Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.7]
b. 17 Sep 1855 d. 17 Jan 1942
Minnie Mary Boyer b. 1869 d. 1922
- 12 Alda Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.7.1]
b. 20 May 1881
- 12 Alda Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.7.1]
- 11 Susan Sophia Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8]
b. 26 Sep 1856 d. 5 Feb 1943
Thomas Jefferson Henegar, Sr ¶ b. 31 Aug 1840 d. 3 May 1918
- 12 Edgar Moore Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.1]
b. 2 Jul 1886 d. 17 Feb 1933
- 12 Frank Smoot Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.2]
b. 16 Aug 1887 d. 30 Mar 1986
- 12 Thomas Jefferson Henegar, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.3]
b. 29 Mar 1888 d. 8 Oct 1918
- 12 Ernest Clarence Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.4]
b. 11 Apr 1893 d. 5 Apr 1965
- 12 Ulric Shaw Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.5]
b. 11 Apr 1893 d. 5 Apr 1965
- 12 Harold Eugene Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.6]
b. 19 Dec 1894 d. 19 Apr 1978 [ =>]
- 12 Daniel Porter Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.7]
b. 21 Sep 1897 d. 24 Aug 1979
- 12 Edgar Moore Henegar [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.8.1]
- 11 Daniel P Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.9]
b. 6 Nov 1858 d. 6 Jan 1904
- + Betty Owen b. 16 Apr 1869 d. 15 Sep 1899
- + Betty Owen b. 16 Apr 1869 d. 15 Sep 1899
- 11 Anna Laura Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.10]
b. 4 Nov 1860 d. 4 Apr 1949
- + Harrison Hopwood Neece b. 1 Oct 1842 d. 27 Mar 1922
- + Harrison Hopwood Neece b. 1 Oct 1842 d. 27 Mar 1922
- 11 Mary Elizabeth Smoot [1.1.1.1.3.12.7.6.1.5.1]
- 10 Benjamin Walker Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.6]
b. 6 May 1830 d. 15 Feb 1861
Mary Davis b. Abt 1831
- 11 John M Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.6.1]
b. Abt 1855
- 11 John M Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.6.1]
- 10 Elizabeth Laura Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7]
b. 12 Sep 1832 d. 31 May 1896
Milton Nesbitt Moore, Sr b. 10 Mar 1829 d. 5 Jan 1906
- 11 Robert Lovard Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1]
b. Mar 1852 d. 1936
Lucy Louisa F Shofner b. 9 Nov 1855 d. 9 Aug 1939
- 12 Harvey Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1.1]
b. Oct 1875
- 12 Charles Lawson Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1.2]
b. 26 Mar 1878 [ =>]
- 12 Edna Ormsby Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1.3]
b. 21 Jul 1882 d. 30 Sep 1971
- 12 Floyd Shofner Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1.4]
b. 17 Jul 1885 d. Oct 1964
- 12 Robert Daniel Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1.5]
b. 4 Oct 1897
- 12 Harvey Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1.1]
- 11 Laura Ann Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.2]
b. 20 Oct 1855 d. 22 Jan 1932
- + Waggoner
- + Waggoner
- 11 Washington Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.3]
b. 1858 d. Bef 1870
- 11 Mary Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.4]
b. 1859 d. Bef 1870
- 11 Joe Lane Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.5]
b. 28 Jan 1861 d. 29 Jun 1937
- 11 Nanny M Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.6]
b. 1863
James Holman Sullivan b. 1 Feb 1854 d. 16 Jan 1896
- 12 Ella Sullivan [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.6.1]
b. 30 Jul 1883 d. 1961 [ =>]
- 12 Horace Moore Sullivan [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.6.2]
b. 30 Jul 1883 d. 20 Apr 1936
- 12 Emma Laura Sullivan [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.6.3]
b. Jan 1889
- 12 Ella Sullivan [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.6.1]
- 11 James Harvey Moore, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.7]
b. 1864 d. 9 Jan 1954
Ida M Moore b. 1879
- 12 James Harvey Moore, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.7.1]
b. 1888
- 12 Estelle Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.7.2]
b. 1890
- 12 James Harvey Moore, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.7.1]
- 11 Milton Nesbitt Moore, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.8]
b. 8 Aug 1871 d. 28 Nov 1944
- 11 William L Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.9]
b. 18 Jul 1877 d. 12 Jan 1914
- 11 Robert Lovard Moore [1.1.1.1.3.12.7.6.1.7.1]
- 10 Wade M Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.8]
b. 2 Feb 1836 d. 21 Aug 1855
- 10 Nancy Smith Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9]
b. 16 Dec 1837 d. 1921
Dr Abram Setliff b. 1817 d. 1875
- 11 John Thomas Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.1]
b. Sep 1862
- + Mollie Setliff b. 1870
- + Mollie Setliff b. 1870
- 11 William Wade Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.2]
b. 18 Sep 1862 d. 26 Dec 1909
Mattie Alice Brown b. 18 Nov 1873 d. 4 Feb 1949
- 12 James Paul Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.2.1]
b. 15 Dec 1905 d. 24 Oct 1984
- 12 James Paul Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.2.1]
- 11 J.L.M. Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.3]
b. 1864
- 11 Abraham Joseph Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.4]
b. 2 Feb 1867 d. 30 Jul 1955
- 11 A.L. Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.5]
b. 1868
- 11 Daisye Irene Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.6]
b. 6 Aug 1872 d. Apr 1969
- 11 Reuben B Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.7]
b. 1874 d. 1932
- 11 John Thomas Setliff [1.1.1.1.3.12.7.6.1.9.1]
- 10 Mary Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.10]
b. 21 Nov 1839 d. 6 Jan 1902
- 10 James Harbison Shaw [1.1.1.1.3.12.7.6.1.1]
- 9 James Lewis Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.2]
b. 1 Feb 1806 d. 13 Apr 1888
Musidora Flack b. 4 Oct 1807 d. 1 Nov 1849
- 10 Emily Jane Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1]
b. 7 Apr 1827 d. 30 Nov 1884
Rufus Burton Parks b. 5 May 1827 d. 21 Sep 1897
- 11 Rufus Alonzo Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1]
b. 21 Oct 1849 d. 10 Jun 1937
Susan Ann Holt b. 5 Jul 1851 d. 30 May 1930
- 12 Roy Hamilton Parks, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.1]
b. 4 Oct 1876 d. 30 Dec 1948 [ =>]
- 12 Pearl Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.2]
b. 30 Jul 1878 d. 7 Apr 1967 [ =>]
- 12 Harry Raymond Parks, (Xfer) [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.3]
b. 5 May 1881 d. 8 Mar 1958 [ =>]
- 12 Margaret Musadora Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.4]
b. Dec 1883 d. 1922 [ =>]
- 12 Annie May Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.5]
b. 21 Aug 1886 d. 7 Sep 1886
- 12 Marion Alice Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.6]
b. 13 Jan 1888 d. 6 Apr 1967 [ =>]
- 12 Lexie Logue Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.7]
b. 18 Mar 1891 d. 1 Aug 1975 [ =>]
- 12 Rufus Burton Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.8]
b. 16 Sep 1895 d. 16 Dec 1984 [ =>]
- 12 Roy Hamilton Parks, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1.1]
- 11 Rufus Alonzo Parks [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1.1]
- 10 Robert Flack Rowntree, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.2.2]
b. 9 Dec 1846 d. 20 Jul 1893
Elizabeth Betty Alma Smith b. 1857 d. 1926
- 11 Musidore Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.2.2.1]
b. 4 Jun 1885 d. 27 Jul 1974
Lawrence Lewis Montgomery b. 28 Jan 1882 d. 8 Aug 1948
- 12 Robert Lawrence Montgomery [1.1.1.1.3.12.7.6.2.2.1.1]
b. 2 Mar 1920 d. 4 Nov 2014 [ =>]
- 12 Robert Lawrence Montgomery [1.1.1.1.3.12.7.6.2.2.1.1]
- 11 Musidore Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.2.2.1]
- 10 Emily Jane Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.2.1]
- 9 Elizabeth Betsy Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.3]
b. 6 Apr 1811 d. Bef 1850
Felix J Landers b. 25 Aug 1804 d. Bef 1880
- 10 Susan Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.3.1]
b. 5 Aug 1828 d. 19 Apr 1900
James Thomas Smith Dance b. 1822 d. 1897
- 11 Susan Finetta Dance [1.1.1.1.3.12.7.6.3.1.1]
b. 1859 d. 1945
William David Leo Record b. 1849 d. 1897
- 12 Mary Record [1.1.1.1.3.12.7.6.3.1.1.1]
b. 1879 d. 1974 [ =>]
- 12 Mary Record [1.1.1.1.3.12.7.6.3.1.1.1]
- 11 Susan Finetta Dance [1.1.1.1.3.12.7.6.3.1.1]
- 10 Mary Jane Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2]
b. 12 Jan 1830 d. 12 Jan 1916
James Edens b. 31 Dec 1828 d. 19 Apr 1914
- 11 Joseph T Edens [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.1]
b. 21 Jun 1857 d. 9 May 1917
- 11 Susan Edens [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.2]
b. 28 Apr 1861 d. 15 Jan 1946
- + McDowell b. Abt 1860
- + McDowell b. Abt 1860
- 11 Cincinnati Edens [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3]
b. 27 Jun 1866 d. 27 Feb 1899
Thomas Jefferson Gore b. 31 May 1858 d. 29 Sep 1923
- 12 Infant Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.1]
d. 17 Sep 1904
- 12 Infant Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.2]
d. 1903
- 12 Alma Beatrice Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.3]
b. 6 Oct 1886 d. 8 Aug 1975 [ =>]
- 12 Effie Edna Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.4]
b. 4 Sep 1888 d. Oct 1973
- 12 Lena May Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.5]
b. 10 Jan 1891 d. 4 Nov 1972 [ =>]
- 12 Wanda Audys Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.6]
b. 2 May 1901 d. 21 Jul 1978
- 12 Connie Novella Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.7]
b. 27 Oct 1910 d. 19 Dec 1973
- 12 Infant Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.3.1]
- 11 Nannie Edens [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.4]
b. 1872 d. 1962
- + Dwight Woods b. 1873
- + Dwight Woods b. 1873
- 11 Lena Edens [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.5]
b. 22 Jun 1874 d. 24 Mar 1940
Joshua Gore b. 16 Sep 1868 d. 14 Dec 1950
- 12 Maude Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.5.1]
b. Aug 1894
- 12 Ed Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.5.2]
b. Sep 1895
- 12 Georgia Catherine Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.5.3]
b. 6 Aug 1899 d. Oct 1960 [ =>]
- 12 Frances Louise Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.5.4]
b. 16 Mar 1909 d. 11 Mar 1984 [ =>]
- 12 Maude Gore [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.5.1]
- 11 Joseph T Edens [1.1.1.1.3.12.7.6.3.2.1]
- 10 Susan Landers [1.1.1.1.3.12.7.6.3.1]
- 9 Nancy A Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.4]
b. 22 Apr 1813 d. 29 Apr 1876
Reverend William Stark Smith, Jr b. 9 Mar 1797 d. 1 Jan 1876
- 10 Felix Ezell Smith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1]
b. 10 Aug 1831 d. 11 Mar 1890
Mary Sophronia Mann b. 18 Apr 1838 d. 24 Nov 1916
- 11 Elizabeth Betty Alma Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.1]
b. 1857 d. 1926
Robert Flack Rowntree, Sr b. 9 Dec 1846 d. 20 Jul 1893
- 12 Musidore Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.1.1]
b. 4 Jun 1885 d. 27 Jul 1974 [ =>]
- 12 Musidore Rowntree [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.1.1]
- 11 William Starke Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.2]
b. 9 Oct 1858 d. 29 Oct 1915
Novella Stovall b. 18 Aug 1860 d. 21 Nov 1901
- 12 Ethel C Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.2.1]
b. Nov 1883
- 12 Novella Wade Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.2.2]
b. Jun 1888 d. 18 Apr 1931
- 12 Gilbert Stovall Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.2.3]
b. 28 Sep 1892 d. 8 Dec 1917
- 12 William Rogers Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.2.4]
b. 3 Apr 1894 d. 18 Jan 1969
- 12 Ethel C Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.2.1]
- 11 Nancy Nannie Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3]
b. 15 Apr 1862 d. 2 Apr 1941
William Henry Thaxton b. 8 Aug 1862 d. 5 Sep 1925
- 12 William Smith Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.1]
b. 25 Jan 1886 d. 3 Jan 1891
- 12 Mary Barsha Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.2]
b. 14 Apr 1888 d. 13 May 1968 [ =>]
- 12 Clara Ezelle Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.3]
b. 15 Feb 1891 d. 31 Jul 1966 [ =>]
- 12 Claude Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.4]
b. 15 Feb 1891 d. 5 Mar 1891
- 12 Henry James Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.5]
b. 20 Aug 1893 d. 25 Jan 1960
- 12 Felix Smith Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.6]
b. 14 Apr 1896 d. 28 Dec 1977 [ =>]
- 12 William Smith Thaxton [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.3.1]
- 11 Dr Matthew Mann Smith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.4]
b. 20 Nov 1864 d. 10 Jan 1924
Eleanor Lee Anderson b. 4 Aug 1871 d. 13 Mar 1957
- 12 Dr Matthew Mann Smith, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.4.1]
b. 29 Sep 1895 d. 25 Dec 1956
- 12 Stephen Gerard Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.4.2]
b. 29 May 1897 d. 1 Jul 1968
- 12 Dr Matthew Mann Smith, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.4.1]
- 11 James Newton Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.5]
b. 8 Jun 1867 d. 12 Feb 1898
- 11 John Turner Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.6]
b. 21 Mar 1870 d. 23 Sep 1900
- 11 Wade Morris Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.7]
b. 6 Aug 1872 d. 10 Jan 1953
Margaret Susan Smith b. 12 Aug 1883 d. 18 Jan 1961
- 12 Mary Wade Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.7.1]
b. 12 Jul 1920 d. 22 Feb 1978
- 12 Mary Wade Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.7.1]
- 11 Mary Leonora Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.8]
b. 31 Dec 1874 d. 1923
William Henry Campbell b. 5 Aug 1872 d. 23 Nov 1941
- 12 James Lawrence Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.8.1]
b. 23 Jun 1900 d. 30 Dec 1966
- 12 Felix Morris Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.8.2]
b. 13 Mar 1908 d. 23 Feb 2000
- 12 Ruth Helen Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.8.3]
b. 7 May 1916 d. 1 Nov 1994 [ =>]
- 12 James Lawrence Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.8.1]
- 11 Felix Ezell Smith, Jr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.9]
b. 31 Oct 1876 d. 25 May 1950
Maude Galen Barton b. 5 Sep 1879 d. 17 Feb 1970
- 12 Maude Galen Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.9.1]
b. 19 Aug 1902 d. 29 Nov 1988
- 12 Maude Galen Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.9.1]
- 11 George Lewis Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.10]
b. 24 Nov 1878 d. Nov 1880
- 11 Lawrence Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.11]
b. 24 Nov 1878 d. 24 Nov 1878
- 11 Georgie Ruth Helen Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.12]
b. 11 Mar 1884 d. 18 Mar 1951
- 11 Elizabeth Betty Alma Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1.1]
- 10 Lieutenant John Morgan Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.2]
b. 1833 d. 20 Nov 1862
- + Mary E Berry b. Abt 1835
- + Mary E Berry b. Abt 1835
- 10 Mildred Rountree Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3]
b. 24 Apr 1835 d. 29 Mar 1892
John Clark Wilson, (Xfer) b. 23 Dec 1825 d. 7 Aug 1897
- 11 Mary Ellen Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1]
b. 1 Jul 1855 d. 27 Apr 1924
William Wilson Puckett b. 8 Mar 1842 d. 1 Jul 1939
- 12 Almor Manor Puckett, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.1]
b. 31 Mar 1877 d. 3 Oct 1924 [ =>]
- 12 Mary Lillian Puckett [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.2]
b. 10 Dec 1878 d. 31 Oct 1958
- 12 John Wilson Puckett, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.3]
b. 19 Sep 1880 d. 21 Sep 1952 [ =>]
- 12 Lucy Elizabeth Puckett [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.4]
b. 18 Sep 1882 d. 15 Dec 1932 [ =>]
- 12 Felix Smith Puckett [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.5]
b. 7 Mar 1885 d. 23 Jul 1941 [ =>]
- 12 Walter William Puckett [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.6]
b. 20 Jan 1887 d. 13 May 1958 [ =>]
- 12 David Mills Puckett [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.7]
b. 20 Sep 1888 d. 10 May 1959 [ =>]
- 12 James Raymon Puckett [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.8]
b. 1893 d. 2 Jun 1967 [ =>]
- 12 Almor Manor Puckett, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1.1]
- 11 William Smith Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.2]
b. 4 Jan 1857 d. 19 Feb 1938
Virginia M Lunsford b. 15 Jul 1864 d. 25 Jul 1905
- 12 William David Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.2.1]
b. 15 Jul 1892 d. 11 Nov 1979 [ =>]
- 12 Grace Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.2.2]
b. 23 Dec 1895 d. 25 Dec 1895
- 12 Winnie Lee Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.2.3]
b. 22 Apr 1897 d. 9 Oct 1961
- 12 Myrtle Virginia Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.2.4]
b. 27 Jan 1903 d. 15 Feb 1976 [ =>]
- 12 William David Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.2.1]
- + Margaret W Rogers b. 1882
- 11 Annie R Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3]
b. 26 Nov 1858 d. 16 Jun 1934
John Thomas Megee b. Sep 1844 d. 21 Nov 1917
- 12 Alice Novella Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.1]
b. Oct 1882 d. 3 Dec 1948 [ =>]
- 12 Jonnie Mildred Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.2]
b. 2 Jan 1884 d. 4 Aug 1964 [ =>]
- 12 Mary Lena Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.3]
b. 19 Jul 1885 d. 25 Aug 1965 [ =>]
- 12 Robert Ernest Megee, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.4]
b. 18 Nov 1886 d. 6 Jan 1941 [ =>]
- 12 Infant Daughter Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.5]
b. 31 Mar 1889 d. 1 Apr 1889
- 12 Anna J Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.6]
b. 23 May 1890 d. 6 Mar 1929
- 12 Willie Edna Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.7]
b. 27 Nov 1893 d. 15 May 1963
- 12 Mattie Louise Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.8]
b. 6 Oct 1895 d. 18 Nov 1989 [ =>]
- 12 Alice Novella Megee [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.3.1]
- 11 John Morgan Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.4]
b. 3 Jul 1860 d. 21 Oct 1941
Martha Washington Cloud b. 9 Jan 1864 d. 22 Aug 1952
- 12 Lucile Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.4.1]
b. Abt 1901
- 12 Lucile Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.4.1]
- 11 James Boone Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.5]
b. 17 Mar 1862 d. 22 Jul 1925
Sarah N Sloss b. 19 Mar 1867 d. 9 Aug 1938
- 12 Novella Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.5.1]
b. 11 Oct 1886 d. 17 Nov 1980
- 12 Boone Sloss Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.5.2]
b. 21 Oct 1889 d. 29 Feb 1960 [ =>]
- 12 Newton Walton Wilson, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.5.3]
b. Sep 1894 d. 22 Apr 1951 [ =>]
- 12 Mary Carol Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.5.4]
b. 6 Feb 1899 d. 28 Feb 1968
- 12 Novella Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.5.1]
- 11 Mildred Elizabeth Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.6]
b. 16 Feb 1864 d. 28 Nov 1939
Winston Dudley Miller b. 10 Sep 1862 d. 10 Jun 1929
- 12 Wilson Dudley Miller [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.6.1]
b. 3 Oct 1885 d. 4 Mar 1967
- 12 Myrtle Estelle Miller [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.6.2]
b. 23 Jul 1891 d. 13 Jan 1970 [ =>]
- 12 Mildred Irene Miller [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.6.3]
b. 11 Aug 1893 d. 2 Apr 1934 [ =>]
- 12 Wilson Dudley Miller [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.6.1]
- 11 Sallie Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.7]
b. 16 Aug 1866 d. 23 May 1942
- 11 Dr Robert Lee Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.8]
b. 29 Jan 1871 d. 1 Apr 1958
Katherine Black Adams b. 6 Oct 1876 d. 3 Apr 1946
- 12 Robert Lee Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.8.1]
b. 30 Apr 1901 d. Mar 1968
- 12 William Burton Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.8.2]
b. 14 Mar 1906 d. 12 Sep 1993
- 12 James Boone Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.8.3]
b. 18 Mar 1909 d. 12 Apr 1986 [ =>]
- 12 James Adams Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.8.4]
b. 19 Dec 1913 d. 30 May 2000
- 12 Robert Lee Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.8.1]
- 11 Ben H Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.9]
b. 11 Dec 1872 d. 10 Sep 1950
- 11 Edna Cathryn Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.10]
b. 8 Aug 1878 d. 10 Aug 1953
Norman Wilbur Croslin b. 30 Jul 1874 d. 5 Nov 1953
- 12 Norman Wilburn Croslin [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.10.1]
b. 7 Sep 1901 d. 7 May 1967 [ =>]
- 12 Wilson Croslin [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.10.2]
b. 1904
- 12 Winston Croslin [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.10.3]
b. 1907
- 12 Norman Wilburn Croslin [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.10.1]
- 11 Mary Ellen Wilson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.3.1]
- 10 James Woods Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4]
b. 1 Jul 1837 d. 28 Apr 1911
Sarah Sally A Bryson b. 23 Feb 1839 d. 7 Oct 1914
- 11 John S Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4.1]
b. 24 Sep 1859 d. 29 Mar 1860
- 11 Felix Ezel Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4.2]
b. 2 Nov 1860 d. 11 Aug 1930
Mary Elizabeth Bettie Dean b. 6 Aug 1856 d. 16 Sep 1942
- 12 Annie Marshall Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4.2.1]
b. 4 Dec 1886 d. 22 Mar 1976
- 12 James Edward Pete Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4.2.2]
b. 20 Jun 1888 d. 14 Apr 1977
- 12 Annie Marshall Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4.2.1]
- 11 John S Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.4.1]
- 10 Mary Elizabeth Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5]
b. 7 Feb 1839 d. 25 Mar 1913
James Randall Jones, ¶ b. 10 May 1832 d. 24 Jun 1891
- 11 Nancy Ellen Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.1]
b. 1857 d. Bef 1900
George Johnson b. 2 Nov 1848 d. 13 Oct 1922
- 12 John Morgan Jack Johnson, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.1.1]
b. 16 Jan 1881 d. 18 Jun 1969 [ =>]
- 12 Charlie R Johnson [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.1.2]
b. 25 Sep 1892 d. 20 Feb 1961 [ =>]
- 12 John Morgan Jack Johnson, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.1.1]
- 11 Kate L Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.2]
b. 1859 d. Abt 1882
Robert E Turner b. 10 Feb 1860 d. 13 Feb 1924
- 12 McIver Mackie Turner [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.2.1]
b. 20 May 1877 d. 7 Mar 1955
- 12 Fred Marion Turner, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.2.2]
b. 22 Jul 1879 d. 8 Dec 1930 [ =>]
- 12 McIver Mackie Turner [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.2.1]
- 11 James Smith Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3]
b. 9 Nov 1860 d. 13 Dec 1896
Mary Ellen Piper b. 16 Aug 1858 d. 28 Sep 1899
- 12 Walter Dean Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.1]
b. 24 Oct 1882 d. 20 Feb 1966 [ =>]
- 12 James Roy Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.2]
b. 4 Jun 1886 d. 7 Sep 1937 [ =>]
- 12 Ruth Ellen Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.3]
b. 3 Dec 1889 d. 9 Feb 1967
- 12 Harvey Maddox Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.4]
b. 4 Oct 1891 d. 30 Jul 1956 [ =>]
- 12 Homer Hill Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.5]
b. 8 Sep 1893 d. 22 Feb 1967
- 12 Alfred Earl Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.6]
b. 28 Jul 1895 d. 3 Nov 1918
- 12 Walter Dean Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.3.1]
- 11 John M Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.4]
b. 23 Dec 1862 d. 18 May 1947
Mollie Caldwell b. 30 Jan 1879 d. 17 Feb 1964
- 12 Jessie P Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.4.1]
b. 6 Oct 1887 d. 21 Dec 1970
- 12 John Samuel Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.4.2]
b. 12 Jul 1889 d. 28 Dec 1946
- 12 Harold Edgar Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.4.3]
b. 3 Oct 1895 d. 6 Sep 1907
- 12 James Nathan Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.4.4]
b. 24 Jul 1898 d. 13 Feb 1974
- 12 Jessie P Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.4.1]
- 11 Jesse Burdette Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.5]
b. 28 Mar 1866 d. 24 Jun 1916
Mary Jane Patterson b. 11 Sep 1871 d. 21 Dec 1968
- 12 Willie Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.5.1]
b. Aug 1891
- 12 Lucile Eva Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.5.2]
b. 3 Sep 1893 d. 19 Mar 1947
- 12 Alva Johnnie Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.5.3]
b. Apr 1895 d. 16 Mar 1928
- 12 Morris Shephard Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.5.4]
b. 2 Jan 1899 [ =>]
- 12 Willie Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.5.1]
- 11 Abner Fluellen Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.6]
b. 16 Jun 1869 d. 24 Dec 1922
Eula Hammett b. 28 Oct 1873 d. 13 Sep 1907
- 12 Ethel Beulah Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.6.1]
b. 14 Jul 1897 d. 1 Oct 1916
- 12 Ludie Belle Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.6.2]
b. 20 Dec 1901 d. 19 Oct 1993 [ =>]
- 12 Donald Maurice Jones, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.6.3]
b. 29 Oct 1905 d. 4 Aug 1953 [ =>]
- 12 Infant Daughter Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.6.4]
b. Abt 1906 d. Abt 1906
- 12 Ethel Beulah Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.6.1]
- + Ellie Sullivan b. 1874
- 11 Wade Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.7]
b. 1872
- 11 Eugene Bremond Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.8]
b. 12 Aug 1873 d. 28 Aug 1918
Margaret Florence Wallace b. 11 Mar 1873 d. 29 Jul 1947
- 12 Jesse Raymond Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.8.1]
b. 8 Nov 1893 d. 27 Feb 1986 [ =>]
- 12 Hubert Eugene Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.8.2]
b. 2 Jan 1896 d. 7 Dec 1959 [ =>]
- 12 Bessie Irene Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.8.3]
b. 9 Mar 1898 d. 21 Dec 1985 [ =>]
- 12 Rufus Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.8.4]
b. Abt 1904
- 12 Jesse Raymond Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.8.1]
- 11 William Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.9]
b. 1874
- 11 Sallie Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.10]
b. 1876
- 11 Melvin Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.11]
b. 1878
- 11 Cora Belle Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.12]
b. 1880
George Albert Campbell b. 21 Jul 1878 d. 13 Apr 1943
- 12 Clarence Bell Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.12.1]
b. 21 Nov 1897 d. 8 Jan 1930 [ =>]
- 12 Clarence Bell Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.12.1]
- 11 Nancy Ellen Jones [1.1.1.1.3.12.7.6.4.5.1]
- 10 Ann E Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.6]
b. 1842 d. 1871
- + Jess Burdette b. Abt 1841
- + Jess Burdette b. Abt 1841
- 10 Catherine Kate Ann Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7]
b. 29 Apr 1844 d. 15 Jul 1877
Wiley Woodward Medearis b. 22 Mar 1836 d. 21 Jan 1908
- 11 William Smith Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1]
b. 30 May 1861 d. 1 Dec 1928
Laura Josephine Isaacs b. 13 Dec 1865 d. 6 Feb 1944
- 12 Annie Maude Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1.1]
b. 4 Jan 1886 d. 24 Nov 1963 [ =>]
- 12 James Burleson Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1.2]
b. 10 Jun 1887 d. 6 Oct 1975
- 12 Tommie Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1.3]
b. 1890 d. 1900
- 12 Lillie Gertrude Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1.4]
b. 9 May 1897 d. 21 Jan 1939 [ =>]
- 12 Annie Maude Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1.1]
- 11 Thomas Washington Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2]
b. 12 Feb 1866 d. 17 Dec 1947
Emma Magness b. 11 Mar 1869 d. 1 Dec 1917
- 12 Alice Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2.1]
b. 25 Feb 1888
- 12 Willis Washington Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2.2]
b. 18 Mar 1891 d. 5 Dec 1967 [ =>]
- 12 Carl Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2.3]
b. Jul 1894 d. 12 Dec 1909
- 12 Fannie Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2.4]
b. Aug 1898
- 12 Luce Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2.5]
b. 1901
- 12 Alice Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.2.1]
- 11 James Smith Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3]
b. 12 Sep 1867 d. 16 Nov 1946
Nancy Elizabeth Miles b. 1 Jan 1869 d. 25 Jan 1963
- 12 Albert Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.1]
b. 13 Aug 1890 d. 19 Jan 1953 [ =>]
- 12 Mary Anne Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.2]
b. 18 Nov 1891 d. 26 Feb 1951 [ =>]
- 12 Harriet Louella Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.3]
b. 28 Feb 1893 d. 13 Jul 1980 [ =>]
- 12 Jennie Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.4]
b. 11 Aug 1894 d. 28 Aug 1984 [ =>]
- 12 Otelia Kate Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.5]
b. 13 Dec 1895 d. 2 Apr 1943
- 12 James Andrew Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.6]
b. 28 Dec 1897 d. 10 Feb 1982
- 12 Hazel Maude Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.7]
b. 13 Feb 1899 d. 28 Jul 1990
- 12 Wiley Richard Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.8]
b. 10 Jun 1900 d. 17 Jun 1988
- 12 Miles Calvin Medearis, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.9]
b. 18 Mar 1902 d. 7 Dec 1975 [ =>]
- 12 Harold A Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.10]
b. 23 Jan 1904 d. 23 Feb 1989
- 12 Edna Edith Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.11]
b. 27 Sep 1905 d. 11 May 1995
- 12 Albert Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.3.1]
- 11 Sarah Annie Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4]
b. 25 May 1871 d. 19 Jan 1959
George Washington Fritts, ¶ b. 30 Mar 1867 d. 14 Mar 1942
- 12 Kathryn Frances Fritts [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.1]
b. 10 Jan 1895 d. 2 Dec 1934 [ =>]
- 12 John Wiley Fritts [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.2]
b. 18 Oct 1896 d. 21 Jan 1972 [ =>]
- 12 Roy Clifton Fritts [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.3]
b. 8 Feb 1899 d. 4 Jun 1978 [ =>]
- 12 James Smith Fritts, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.4]
b. 3 Dec 1901 d. 31 Dec 1989 [ =>]
- 12 Alice Edna Fritts [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.5]
b. 11 Mar 1906 d. 3 Oct 1986
- 12 Anna Mae Fritts [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.6]
b. 28 Apr 1909 d. 13 Jun 1977 [ =>]
- 12 Kathryn Frances Fritts [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.4.1]
- 11 Carrie Edna Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5]
b. Dec 1873 d. 10 Dec 1954
Henry Joseph Gassaway b. 12 Sep 1867 d. 3 Jun 1955
- 12 Neffie Gassaway [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5.1]
b. 19 Jul 1895 d. 24 Sep 1981 [ =>]
- 12 Bessie Alice Gassaway [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5.2]
b. 2 Dec 1898 d. 9 Apr 1939 [ =>]
- 12 Ray Gassaway [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5.3]
b. Abt 1903
- 12 Ruth Gassaway [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5.4]
b. Abt 1904
- 12 Lucy Mae Gassaway [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5.5]
b. Abt 1904
- 12 Neffie Gassaway [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.5.1]
- 11 Alice Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6]
b. Apr 1877 d. 5 Mar 1931
George Albert Campbell b. 21 Jul 1878 d. 13 Apr 1943
- 12 Clara Alice Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6.1]
b. 12 Sep 1902 d. 13 Nov 1965 [ =>]
- 12 Annie L Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6.2]
b. 1904 d. Bef 1920
- 12 George Wiley Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6.3]
b. 11 Nov 1906 d. 18 Nov 1991 [ =>]
- 12 James Albert Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6.4]
b. 23 Oct 1909 d. 27 Feb 1977
- 12 William Henry Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6.5]
b. 11 Nov 1911 d. 22 Oct 1966 [ =>]
- 12 Clara Alice Campbell [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.6.1]
- 11 William Smith Medearis [1.1.1.1.3.12.7.6.4.7.1]
- 10 Wade Morris Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8]
b. 20 Sep 1853 d. 11 Aug 1911
Alice Davidson b. 15 Oct 1852 d. 15 Feb 1886
- 11 Guy T Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.1]
b. 27 Jul 1873 d. 3 Aug 1903
- 11 William Roy Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.2]
b. 16 Nov 1876 d. Bef 1938
- + Marion Parris b. 22 May 1879
- + Marion Parris b. 22 May 1879
- 11 Myrtle Brian Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.3]
b. 7 Jun 1880 d. 3 Nov 1959
Fred Wolcott Householder b. 29 Aug 1884 d. 7 Feb 1966
- 12 Garrison Householder [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.3.1]
b. 6 Sep 1908 d. 26 Nov 1993 [ =>]
- 12 Beverly Householder [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.3.2]
b. 5 Sep 1910 d. 10 Apr 2002
- 12 Fred Walter Householder [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.3.3]
b. 1 Feb 1913 d. 4 Jan 1994 [ =>]
- 12 Edgar Sayles Householder [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.3.4]
b. 6 Apr 1915 d. 7 May 1977
- 12 Garrison Householder [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.3.1]
- 11 Jack Morgan Smith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.4]
b. 20 May 1882 d. 29 Nov 1955
Dee Beatty b. Sep 1888
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.4.1]
- 12 Janet Claire Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.4.2]
b. 29 Sep 1928 d. 1 Jan 2010 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.4.1]
- 11 Andrew Raymond Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.5]
b. 1884 d. 17 Nov 1911
Kate Abbott b. 5 Nov 1893
- 12 Alice Ruby Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.5.1]
b. 31 May 1911
- 12 Alice Ruby Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.5.1]
- 11 Guy T Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.1]
Otelia Hannig b. 7 Feb 1869 d. 16 Aug 1943
- 11 Morris Allen Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6]
b. 22 Sep 1889 d. 22 Sep 1935
Purity Cornelia Brock b. 31 Jul 1891 d. 28 Jun 1974
- 12 Mary Kathryn Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6.1]
b. 25 Sep 1920 d. 2 Sep 1980 [ =>]
- 12 Ruby Mae Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6.2]
b. 31 Dec 1921 d. 28 Dec 1993 [ =>]
- 12 John 'Jack' Morris Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6.3]
b. 2 Nov 1925 d. 14 Aug 1944
- 12 Billie Merle Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6.4]
b. 3 Oct 1927 d. 26 Mar 2016 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6.5]
- 12 Mary Kathryn Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6.1]
- 11 Annie Mildred Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.7]
b. 4 Feb 1893 d. 22 Aug 1981
John Hensley Keough b. 14 Aug 1887 d. 27 Sep 1964
- 12 Maribeth E Keough [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.7.1]
b. 23 Apr 1915 d. 4 Nov 1966 [ =>]
- 12 Major John Joe Keough [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.7.2]
b. 2 May 1917 d. 19 Apr 1944
- 12 Anna Lou Keough [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.7.3]
b. 20 Feb 1926 d. 30 Nov 1996 [ =>]
- 12 Maribeth E Keough [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.7.1]
- 11 Willie Wade Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.8]
b. 13 Jul 1895 d. 29 Nov 1955
- + Pearl Maggie Cunningham b. 26 May 1905 d. 12 Nov 1997
- + Pearl Maggie Cunningham b. 26 May 1905 d. 12 Nov 1997
- 11 James Bennett Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.9]
b. 8 Mar 1898 d. 20 May 1972
Amelia Alma Rebecca Eilers b. 6 May 1902 d. 12 Jun 1984
- 12 Dorothy Louise Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.9.1]
b. 9 Oct 1921 d. 7 May 1997
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.9.2]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.9.3]
- 12 Dorothy Louise Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.9.1]
- 11 Mary Maud Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10]
b. 7 Feb 1901 d. 11 Jan 1982
Russell Hasledon Robbins b. 25 Mar 1889 d. 11 Apr 1950
- 12 Russell Ferris Robbins [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10.1]
b. 12 Oct 1921 d. 25 Jun 1984 [ =>]
- 12 Jack Horrace Robbins [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10.2]
b. 18 Nov 1922 d. 24 Jun 2007
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10.3]
[ =>]
- 12 Russell Ferris Robbins [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10.1]
Frank August Benner, II b. 1 Apr 1894 d. 4 Oct 1989
- 12 Frank August Benner, III [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10.4]
b. 29 Mar 1933 d. 26 Jan 1993
- 12 Frank August Benner, III [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.10.4]
- 11 Wade Travis Bob Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.11]
b. 21 Jan 1905 d. 2 Mar 1974
Ruth Leola Boston b. 17 Dec 1907 d. 2 Feb 1993
- 12 Betty Jo Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.11.1]
b. 19 Aug 1927 d. 3 Jun 2003 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.11.2]
- 12 Betty Jo Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.11.1]
- 11 Harry Gilbert Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.12]
b. 14 Oct 1910 d. 4 Feb 1982
- + Grace Perry b. 3 Dec 1914 d. 17 Apr 2006
- + Grace Perry b. 3 Dec 1914 d. 17 Apr 2006
- 11 Morris Allen Smith [1.1.1.1.3.12.7.6.4.8.6]
- 10 Felix Ezell Smith, Sr [1.1.1.1.3.12.7.6.4.1]
- 9 Katherine C Rountree [1.1.1.1.3.12.7.6.1]
- 8 Martha "Patsy" Rountree [1.1.1.1.3.12.7.7]
b. 6 Oct 1783 d. 30 Jun 1863
Reverend Cary Cox, Jr b. 1 Oct 1778 d. 2 Jun 1871
- 9 Sarah Elizabeth Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1]
b. 27 Sep 1806 d. 17 Oct 1835
Bartley Martin Cox b. Jul 1802 d. 22 Dec 1872
- 10 Dr Wade Chappell Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1]
b. 7 Aug 1822 d. 23 Jan 1875
Martha Adeline Pearson b. 1825 d. Abt 1858
- 11 L L Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.1]
b. 1850
- 11 Sarah Adeline Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.2]
b. 31 Oct 1851 d. 2 Oct 1900
- + William Owen Butler b. Abt 1850
- + William Owen Butler b. Abt 1850
- 11 Nart Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.3]
b. 1855
- 11 Lela J Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.4]
b. 1857 d. 30 Sep 1930
- 11 L L Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.1]
Mariah Louise Gorley b. 17 Apr 1833 d. 15 Mar 1914
- 11 Bartley Martin Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.5]
b. 19 Jul 1860
- 11 Malinda Walker Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6]
b. 21 Dec 1865 d. 31 Dec 1942
Andrew Jackson Moore b. 7 Apr 1858 d. 6 Nov 1939
- 12 William Douglas Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.1]
b. 18 Feb 1886 d. 12 May 1902
- 12 Helen Estella Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.2]
b. 24 Feb 1888 d. 11 Jul 1890
- 12 Linnie Dell Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.3]
b. 26 Dec 1890 d. 26 Jun 1969
- 12 Harry Jackson Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.4]
b. 3 Jun 1892 d. 3 May 1978
- 12 Edith Louise Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.5]
b. 13 Dec 1893 d. 25 Oct 1984
- 12 Florence Ethel Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.6]
b. 8 Jul 1895 d. 8 Jan 1988
- 12 Joe Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.7]
b. Dec 1899
- 12 Neomia Ann Elizabeth Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.8]
b. 6 Sep 1902 d. 24 Mar 1991
- 12 Pendelton Taliaferro Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.9]
b. 27 Nov 1904 d. 28 May 1980 [ =>]
- 12 Harney Spencer Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.10]
b. 13 Dec 1906 d. 11 Feb 1950
- 12 William Douglas Moore [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.6.1]
- 11 Wade C Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.7]
b. 1869 d. Bef 1880
- 11 Bartley Martin Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1.5]
- 10 Alexis Henry Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2]
b. 1830 d. 13 Feb 1893
Sarah Elizabeth Boynton b. 1835 d. 2 Feb 1903
- 11 Mary Elizabeth Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.1]
b. 24 Dec 1851 d. 16 Feb 1924
- + Palmer b. Abt 1850
- + Palmer b. Abt 1850
- 11 Barkley Wade Cox, Sr [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2]
b. 24 Apr 1860 d. 1 Apr 1929
Alice Louise Brock b. Dec 1868 d. 14 Oct 1949
- 12 Reverend Norman Wade Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.1]
b. 28 Oct 1888 d. Feb 1968 [ =>]
- 12 Dessie Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.2]
b. Oct 1890
- 12 William Chappel Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.3]
b. 4 Mar 1896 d. 22 Feb 1972 [ =>]
- 12 Jewel B Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.4]
b. Mar 1898
- 12 Orien Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.5]
b. Abt 1901
- 12 Charlie Barnes Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.6]
b. 10 Feb 1903 d. 7 Aug 1981 [ =>]
- 12 Frances Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.7]
b. Abt 1905
- 12 Cary Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.8]
b. Abt 1908
- 12 Barkley Wade Cox, Jr [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.9]
b. 17 Oct 1912 d. Aug 1986
- 12 Reverend Norman Wade Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.2.1]
- 11 Mary Elizabeth Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.2.1]
- 10 Sarah Elizabeth Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3]
b. 22 Feb 1832
John Henry Parson
- 11 Jr. John Henry Parson [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3.1]
- 11 Sarah E.C.G. Parson [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3.2]
- 11 Jr. John Henry Parson [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3.1]
Joseph LeRoy Griffin b. 1829 d. 1856
- 11 Bartley Cox Griffin [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3.3]
d. infancy
- 11 Joseph L Griffin [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3.4]
b. 1858
- 11 Bartley Cox Griffin [1.1.1.1.3.12.7.7.1.3.3]
- 10 Dr Wade Chappell Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1.1]
- 9 Clarissa Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.2]
b. 1808
- 9 Sarah Elizabeth Cox [1.1.1.1.3.12.7.7.1]
- 8 Thomas Hart Rountree [1.1.1.1.3.12.7.6]
- 7 Dorcas Rountree [1.1.1.1.3.12.8]
b. 1745 d. Aug 1780
Drury Murrell b. 1743 d. 15 Jan 1801
- 8 David Murrell [1.1.1.1.3.12.8.1]
b. 25 Oct 1772 d. 25 May 1822
Elizabeth Harlan b. 10 Aug 1778 d. 6 Sep 1848
- 9 John Jonas Murrell [1.1.1.1.3.12.8.1.1]
b. 16 Nov 1802 d. 3 Dec 1847
Susan J McClellan
- 10 Ann Murrell [1.1.1.1.3.12.8.1.1.1]
b. 1831
William Lewis b. 1770 d. 1855
- 11 Martha Lewis [1.1.1.1.3.12.8.1.1.1.1]
b. 1825 d. 1857
Jesse A Peacock b. 1819 d. 1850
- 12 Serena Jane Peacock [1.1.1.1.3.12.8.1.1.1.1.1]
b. 14 Jan 1844 d. 28 Feb 1926 [ =>]
- 12 Serena Jane Peacock [1.1.1.1.3.12.8.1.1.1.1.1]
- 11 Martha Lewis [1.1.1.1.3.12.8.1.1.1.1]
- 10 Ann Murrell [1.1.1.1.3.12.8.1.1.1]
- 9 John Jonas Murrell [1.1.1.1.3.12.8.1.1]
- 8 David Murrell [1.1.1.1.3.12.8.1]
- 7 Mary Molly Rountree [1.1.1.1.3.12.9]
b. 1747 d. 5 Jul 1813
William Whitlock b. 1745 d. 23 May 1805
- 8 Nancy Whitlock [1.1.1.1.3.12.9.1]
b. 1770 d. 1848
William Richard Faucett, Sr b. 1768 d. 1840
- 9 William Richard Faucett, Jr [1.1.1.1.3.12.9.1.1]
b. 1789 d. 1843
Mary Reece b. Abt 1810
- 10 William Richard Faucett, III [1.1.1.1.3.12.9.1.1.1]
b. 1832 d. Aft 1900
Joanna Hudspeth b. 21 Aug 1851 d. 2 Apr 1902
- 11 Mary A Faucett [1.1.1.1.3.12.9.1.1.1.1]
b. 1872 d. 27 Jul 1943
Basil Lee Thomas Lucas b. 1 Feb 1874 d. 27 Dec 1959
- 12 Cecil E Lucas [1.1.1.1.3.12.9.1.1.1.1.1]
b. 1904 d. 1982 [ =>]
- 12 Cecil E Lucas [1.1.1.1.3.12.9.1.1.1.1.1]
- 11 Mary A Faucett [1.1.1.1.3.12.9.1.1.1.1]
- 10 Samuel Faucett [1.1.1.1.3.12.9.1.1.2]
b. 22 Sep 1835 d. 2 Feb 1897
Mary Jane McCombs b. 23 Jan 1840 d. 16 Aug 1902
- 11 Mary J Faucett [1.1.1.1.3.12.9.1.1.2.1]
b. Apr 1872
John W Mann b. 1867
- 12 William Thomas Mann [1.1.1.1.3.12.9.1.1.2.1.1]
b. 16 Apr 1894 d. 16 Oct 1964 [ =>]
- 12 William Thomas Mann [1.1.1.1.3.12.9.1.1.2.1.1]
- 11 Mary J Faucett [1.1.1.1.3.12.9.1.1.2.1]
- 10 William Richard Faucett, III [1.1.1.1.3.12.9.1.1.1]
- 9 William Richard Faucett, Jr [1.1.1.1.3.12.9.1.1]
- 8 Sarah Whitlock [1.1.1.1.3.12.9.2]
b. 10 Feb 1778 d. 8 Sep 1855
Thomas Ray b. 1780 d. 1862
- 9 Mary Polly Ray [1.1.1.1.3.12.9.2.1]
b. 1822 d. 1855
Tully Huelet Holladay b. 1822 d. 1899
- 10 James Ira Holladay [1.1.1.1.3.12.9.2.1.1]
b. 1844 d. 1928
Sarah Elizabeth Kelley b. 1846 d. 1919
- 11 KIng Frederick Holladay [1.1.1.1.3.12.9.2.1.1.1]
b. 1878 d. 1964
Alice Hunnicut b. 1881 d. 1947
- 12 Selma Holladay [1.1.1.1.3.12.9.2.1.1.1.1]
b. 1906 d. 24 May 1999 [ =>]
- 12 Selma Holladay [1.1.1.1.3.12.9.2.1.1.1.1]
- 11 KIng Frederick Holladay [1.1.1.1.3.12.9.2.1.1.1]
- 10 James Ira Holladay [1.1.1.1.3.12.9.2.1.1]
- 9 Mary Polly Ray [1.1.1.1.3.12.9.2.1]
- 8 Mary Faucett Whitlock [1.1.1.1.3.12.9.3]
b. 1779 d. 18 Oct 1851
William Bentley b. 22 Mar 1781 d. 12 Oct 1845
- 9 Sarah Bentley [1.1.1.1.3.12.9.3.1]
b. 1800 d. 1870
Matthew Johnson b. 1796 d. Nov 1850
- 10 Nancy Jane Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.1]
b. 1822 d. 22 Mar 1860
Moses Self b. 13 Nov 1820 d. 26 Nov 1886
- 11 Francis Marion Self [1.1.1.1.3.12.9.3.1.1.1]
b. 18 Oct 1841 d. 26 Oct 1923
Eliza Jane Tidwell b. 14 Feb 1844 d. 19 Sep 1927
- 12 Nathaniel H Self [1.1.1.1.3.12.9.3.1.1.1.1]
b. Dec 1864 d. 18 Nov 1933 [ =>]
- 12 Nathaniel H Self [1.1.1.1.3.12.9.3.1.1.1.1]
- 11 Francis Marion Self [1.1.1.1.3.12.9.3.1.1.1]
- 10 William Marion Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.2]
b. 22 Oct 1836 d. 3 Apr 1916
Mary Jane Bentley b. 7 Feb 1836 d. 29 Mar 1915
- 11 Dock William Draper Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.2.1]
b. 24 Jan 1870 d. 12 Nov 1951
Margaret E Payne b. 13 Jul 1873 d. 7 Jun 1931
- 12 John Oscar Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.2.1.1]
b. 13 Oct 1902 d. 10 Oct 1970 [ =>]
- 12 John Oscar Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.2.1.1]
- 11 Dock William Draper Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.2.1]
- 10 Nancy Jane Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.1.1]
- 9 James Bentley [1.1.1.1.3.12.9.3.2]
b. Abt 1807 d. 28 Mar 1841
Jane b. Abt 1818
- 10 Mary Ann Bentley [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1]
b. 4 Nov 1835 d. 17 Jan 1920
Alfred Johnson b. 1831 d. 5 Jan 1915
- 11 Lewis Henry Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1]
b. 27 Jul 1868 d. 26 Jul 1941
Judy E Glasscock b. 23 Sep 1878 d. 9 Sep 1965
- 12 Elmer J Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.1]
b. 1900
- 12 Ruth J Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.2]
b. 1901
- 12 Coleman S Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.3]
b. 5 Jul 1902 d. 15 Feb 1984 [ =>]
- 12 Roy F Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.4]
b. 1904
- 12 Walter L Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.5]
b. 1906
- 12 Nellie A Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.6]
b. 1907
- 12 Stella I Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.7]
b. 1910
- 12 Mary E Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.8]
b. 1912
- 12 Ernest Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.9]
b. 1914
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.10]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.11]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.12]
- 12 Elmer J Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1.1]
- 11 Lewis Henry Johnson [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1.1]
- 10 Mary Ann Bentley [1.1.1.1.3.12.9.3.2.1]
- 9 Lucinda Bentley [1.1.1.1.3.12.9.3.3]
b. 7 Jul 1820 d. 1859
Taliferro Cox b. 1815 d. 1905
- 10 Asberry Garrison Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.1]
b. 26 Nov 1836 d. 19 Mar 1919
- 10 Mary Frances Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2]
b. 25 Sep 1843 d. 6 Jul 1927
Daniel Wilson Stanley b. 3 Feb 1846 d. 13 Sep 1932
- 11 Emma Frances Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1]
b. 6 Dec 1866 d. 28 Dec 1949
John Henry Combs b. 21 Mar 1870 d. 9 Jun 1949
- 12 Charles Daniel Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.1]
b. 20 Nov 1891 d. 14 Nov 1961
- 12 Vickie Alma Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.2]
b. 11 Jan 1893 d. 16 Oct 1968
- 12 Joe Henry Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.3]
b. 28 Oct 1895 d. 21 Nov 1972
- 12 John Larkin Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.4]
b. 10 Jun 1898 d. 7 Mar 1988
- 12 Janie Sue Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.5]
b. 20 Jan 1901 d. 5 Feb 1983
- 12 Almon Parker Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.6]
b. 15 Jul 1903 d. 5 Mar 1986 [ =>]
- 12 Owen Lee Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.7]
b. 1 May 1907 d. 31 Jan 1965
- 12 Charles Daniel Combs [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1.1]
- 11 Melvin Jeter Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.2]
b. 19 Nov 1870 d. Jun 1938
- 11 Nancy Caroline Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.3]
b. 21 Dec 1875 d. 18 May 1940
- + Stegall b. Abt 1874
- + Stegall b. Abt 1874
- 11 Martin Daniel Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.4]
b. 24 Jul 1879 d. 27 Sep 1959
- 11 John Larkin Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.5]
b. 2 May 1881 d. 2 Apr 1963
- 11 Owen Levi Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.6]
b. 4 Dec 1885 d. 1918
- 11 Emma Frances Stanley [1.1.1.1.3.12.9.3.3.2.1]
- 10 Louis Ibzan Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.3]
b. 20 Sep 1846 d. 15 Oct 1932
- 10 Mirame Elvira Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.4]
b. 1 Feb 1848 d. 2 Jan 1931
- + Gage b. Abt 1847
- + Gage b. Abt 1847
- 10 Lucinda Caroline Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.5]
b. 18 Nov 1851 d. 5 Oct 1919
- + Rushing b. Abt 1850
- + Rushing b. Abt 1850
- 10 Texas Ann Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.6]
b. 30 Mar 1853 d. 1 Feb 1939
- + McIntosh b. Abt 1852
- + McIntosh b. Abt 1852
- 10 Upton Asa Wright Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.7]
b. 21 Apr 1857 d. 5 Feb 1940
- 10 Asberry Garrison Cox [1.1.1.1.3.12.9.3.3.1]
- 9 Sarah Bentley [1.1.1.1.3.12.9.3.1]
- 8 Nancy Whitlock [1.1.1.1.3.12.9.1]
- 7 Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.10]
b. 1748 d. 1815
Letitia Barnard b. 1748 d. Jan 1838
- 8 John R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1]
b. 11 Feb 1770 d. 13 May 1853
Rebecca Hawkins b. 4 Jul 1774 d. 1838
- 9 Maj John Hawkins Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1]
b. 24 Mar 1805 d. 27 Jun 1890
Mary Grace Mitchell d. 15 Oct 1835
- 10 John M Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.1]
b. 1836
- 10 George Hancock Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.2]
b. 25 Jun 1840 d. 11 May 1893
- 10 Laura Gridley Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.3]
b. 7 Dec 1841
- 10 Mary Grace Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.4]
b. 6 Apr 1845 d. 10 Jul 1845
- 10 Mary Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.5]
b. 12 Jun 1846 d. 17 Sep 1846
- 10 Lydia Taylor Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.6]
b. 23 Jan 1853
- 10 Harrison Hawkins Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.7]
b. 27 Jan 1855
- 10 Charles Jewett Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.8]
b. 19 Sep 1858 d. 16 Oct 1884
- 10 Cora Southworth Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.9]
b. 19 Sep 1858
- 10 John M Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.1]
Lydia Hart Southworth b. 2 Mar 1818 d. 16 Jun 1881
- 10 Philip Sylvester Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.10]
b. 8 Jun 1848 d. 27 Sep 1917
- + Emily Tull b. 28 Oct 1832 d. 8 Feb 1917
- + Emily Tull b. 28 Oct 1832 d. 8 Feb 1917
- 10 Philip Sylvester Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1.10]
- 9 Rutherford Harrison Rowntree [1.1.1.1.3.12.10.1.2]
b. 31 May 1813 d. 29 Oct 1891
- 9 Maj John Hawkins Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1.1]
- 8 Jesse Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2]
b. 1772 d. Aug 1842
- + Polly Wallace
Sarah C Brown b. 1791 d. 18 May 1843
- 9 Syrena Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.1]
b. 1811 d. 23 Sep 1850
- 9 Matilda Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.2]
b. 13 Dec 1814 d. 29 May 1876
- + Sanford Beck b. 1802 d. 29 May 1871
- + Sanford Beck b. 1802 d. 29 May 1871
- 9 Voltaire R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3]
b. 3 Sep 1821 d. 3 Jan 1892
Francis Louisa Fitzhugh b. 22 Mar 1832 d. 13 Feb 1910
- 10 Ada S Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.1]
b. 17 Nov 1867 d. 23 Jul 1882
- 10 Ida Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.2]
b. 17 Nov 1867 d. 6 Sep 1937
- + Sterling Price Coffey b. 6 Jun 1862 d. 21 Sep 1944
- + Sterling Price Coffey b. 6 Jun 1862 d. 21 Sep 1944
- 10 Dudley Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.3]
b. 1 Feb 1869 d. 7 Mar 1923
Gertie England b. 1 Feb 1875 d. 22 May 1971
- 11 Ressie R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.3.1]
b. 19 Aug 1894 d. 20 Sep 1986
- + Ray Edwin McCarley b. 1 Sep 1895 d. 8 Jul 1971
- + Ray Edwin McCarley b. 1 Sep 1895 d. 8 Jul 1971
- 11 Lela Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.3.2]
b. 25 Jan 1901 d. 27 Nov 1974
- + Thadeus Gerard Crossett b. 1882 d. 1974
- + Thadeus Gerard Crossett b. 1882 d. 1974
- 11 Ressie R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.3.1]
- 10 Ada S Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.3.1]
- 9 Volney K Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.4]
b. 1826 d. 18 Jan 1879
- + Anna Maria Craven b. 1826 d. 26 Aug 1899
- + Anna Maria Craven b. 1826 d. 26 Aug 1899
- 9 Mary Ann Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.5]
b. 10 Mar 1827 d. 13 Jun 1902
Jacob Galusha Sherman b. 11 Dec 1815 d. 20 May 1888
- 10 Anna E Farr [1.1.1.1.3.12.10.2.5.1]
d. 3 May 1876
- 10 Edward Roger Sherman [1.1.1.1.3.12.10.2.5.2]
b. 20 Apr 1854 d. 18 Dec 1914
- 10 Laura E Stubbs [1.1.1.1.3.12.10.2.5.3]
b. 13 Jan 1857 d. 22 Apr 1888
- 10 Lyman Jacob Sherman [1.1.1.1.3.12.10.2.5.4]
b. 2 Jan 1860 d. 1 Oct 1923
- 10 Charles Roundtree Sherman [1.1.1.1.3.12.10.2.5.5]
b. 29 Oct 1862 d. 10 Nov 1943
- 10 Clayton C Sherman [1.1.1.1.3.12.10.2.5.6]
b. 4 Apr 1866 d. 19 Sep 1901
- 10 Stella Mae Sherman [1.1.1.1.3.12.10.2.5.7]
b. 1870 d. 1966
Herbert Milton Hanson b. Abt 1869
- 11 Floyd Arthur Hanson [1.1.1.1.3.12.10.2.5.7.1]
b. 29 May 1903 d. 7 Oct 1979
Martha Carolyn Geist b. Abt 1904
- 11 Floyd Arthur Hanson [1.1.1.1.3.12.10.2.5.7.1]
- 10 Anna E Farr [1.1.1.1.3.12.10.2.5.1]
- 9 Jesse Ballard Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6]
b. 16 Jan 1832 d. 22 Jan 1879
Mary Lindsey Gordon b. 20 May 1841 d. 12 Jan 1916
- 10 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1]
b. 31 Mar 1869 d. 25 May 1950
Maude Ola Staples b. Mar 1876 d. 12 Apr 1964
- 11 Francis Ballard Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1]
b. 15 Jan 1892 d. 20 Sep 1977
Maude O Self b. 27 Jan 1898 d. 6 Nov 1993
- 12 Victor Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.1]
b. 18 Aug 1913 d. 7 Mar 1981
- 12 Bruce Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.2]
b. 2 Dec 1915 d. 28 May 1991
- 12 Margie Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.3]
b. 23 Jun 1917 d. 8 Aug 1997
- 12 Victor Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.1]
Alma Murrill Hightower b. 1903 d. 1991
- 12 Jack London Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.4]
b. 26 May 1931 d. 31 Dec 1988
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.5]
- 12 Jack London Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1.4]
- 11 Esther Iola Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.2]
b. 3 Oct 1893 d. 10 Apr 1988
Eli Percy Haralson b. 21 Feb 1895 d. 26 Aug 1939
- 12 William Rudolph Haralson [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.2.1]
b. 14 Nov 1919 d. 22 Feb 1952
- 12 William Rudolph Haralson [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.2.1]
- 11 Florence Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.3]
b. Nov 1895 d. Oct 1980
- 11 Cleo L Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.4]
b. Mar 1899
- 11 Euel Ray Dick Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.5]
b. 28 May 1902 d. 16 Feb 1980
Lottie Leigh b. 24 May 1909 d. 13 Feb 1988
- 12 Betty Leigh Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.5.1]
b. 13 Apr 1927 d. 4 Oct 1992
- 12 Betty Leigh Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.5.1]
- 11 Narcie M Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.6]
b. 9 Jul 1905 d. 21 Apr 1992
- 11 William Spencer Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.7]
b. 1907
- 11 Dudley Glenn Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.8]
b. 1912 d. 7 Mar 2007
- + Living
- + Living
- 11 Francis Ballard Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1.1]
- 10 William Andrew Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.6.1]
- 9 Syrena Rountree [1.1.1.1.3.12.10.2.1]
- + Polly Wallace
- 8 Susannah Rountree [1.1.1.1.3.12.10.3]
b. 1774 d. 1806
Charles Sidebottom b. 1750 d. Aug 1809
- 9 Sarah Sidebottom [1.1.1.1.3.12.10.3.1]
b. 12 Aug 1798 d. 18 Aug 1856
Joseph Srygley b. 3 Mar 1791 d. 30 Nov 1862
- 10 Augustus Harrison Srygley [1.1.1.1.3.12.10.3.1.1]
b. 4 Jan 1814 d. 2 Jan 1879
Nancy Fitzhugh Dawson b. 30 Apr 1817 d. 17 Dec 1895
- 11 Jeremiah J Srygley [1.1.1.1.3.12.10.3.1.1.1]
b. 22 Jan 1847 d. 24 Dec 1922
Eliza F Lawhorn b. 17 Aug 1851 d. 9 Jul 1938
- 12 Henry Lewis Srygley [1.1.1.1.3.12.10.3.1.1.1.1]
b. 1 Mar 1886 d. 2 Sep 1960 [ =>]
- 12 Henry Lewis Srygley [1.1.1.1.3.12.10.3.1.1.1.1]
- 11 Jeremiah J Srygley [1.1.1.1.3.12.10.3.1.1.1]
- 10 Augustus Harrison Srygley [1.1.1.1.3.12.10.3.1.1]
- 9 Sarah Sidebottom [1.1.1.1.3.12.10.3.1]
- 8 William R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4]
b. 4 Apr 1776 d. 17 May 1856
Judith Webb b. 25 May 1779 d. 24 Nov 1854
- 9 Linville Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1]
b. 1 Aug 1801 d. 3 Aug 1866
Susan S Thompson b. 14 Oct 1808 d. 18 May 1850
- 10 Judith G Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1]
b. 1828 d. 1860
James Lewis Jetton, (xfer) b. 14 May 1817 d. 9 Apr 1864
- 11 Martha E Jetton [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1]
b. Feb 1857 d. 14 Feb 1937
James Walker Emerson b. 1853 d. 1885
- 12 James. Emerson [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1.1]
b. 1876
- 12 Celia Emerson [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1.2]
b. 1879
- 12 Ira Bell Emerson [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1.3]
b. 6 Jun 1879 d. 1908 [ =>]
- 12 Newton Francis Emerson [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1.4]
b. 11 Feb 1881
- 12 James. Emerson [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1.1]
- 11 Martha E Jetton [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1.1]
- 10 William F Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.2]
b. 1830
- 10 Temperance J Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.3]
b. 1832 d. 1860
- 10 Henrietta S Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.4]
b. 1834 d. 17 Mar 1903
- 10 Newton J Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.5]
b. 1835
- 10 Rhoda G Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.6]
b. 1837
- 10 Harry H Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.7]
b. 1840
- 10 Nepper J Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.8]
b. 1843
- 10 Allen Barnett Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9]
b. 8 Sep 1846 d. 1 Jan 1893
Margaret Ann Reeves b. Abt 1851
- 11 Frank Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.1]
b. 9 Mar 1869 d. 21 Aug 1872
- 11 Ula Mae Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.2]
b. 16 Jan 1872 d. 31 Dec 1948
- + Marshall Lee Bell b. 23 Oct 1868 d. 27 Dec 1954
- + Marshall Lee Bell b. 23 Oct 1868 d. 27 Dec 1954
- 11 James Paul Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.3]
b. 16 Jul 1875 d. 25 Jul 1934
Nellie Baker b. Abt 1880
- 12 Herbert Allen Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.3.1]
b. 17 Jul 1899 d. 10 Mar 1962
- 12 Herbert Allen Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.3.1]
- 11 George Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.4]
b. Abt 1879
- 11 Frank Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.9.1]
- 10 Hiram C Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.10]
b. 1849
- 10 James B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.11]
b. 1849
- 10 Judith G Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1.1]
- 9 Allen B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2]
b. 23 Mar 1803 d. 23 Feb 1847
Spicey Oden b. 1796 d. 1849
- 10 John Milton Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1]
b. 31 Dec 1825 d. 19 Nov 1864
Nancy W Moore b. 1829
- 11 Allen B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1]
b. 23 Nov 1848 d. 13 Aug 1913
Josephine Harris b. 14 Nov 1852 d. 27 Dec 1939
- 12 Frank Edgar Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.1]
b. 14 Aug 1877 d. 13 Jul 1953
- 12 Ralph Eugene Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.2]
b. 1 Feb 1880 d. 15 Feb 1943
- 12 Myrtle B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.3]
b. Aug 1882
- 12 Lola Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.4]
b. May 1885
- 12 William Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.5]
b. May 1888
- 12 Nellie E Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.6]
b. Mar 1891
- 12 Clyde Emory Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.7]
b. 18 Nov 1893 d. 22 Feb 1920
- 12 Frank Edgar Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1.1]
- 11 Allen B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1.1]
- 10 Polly B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.2]
b. 1827 d. 1865
- 10 Greenville Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.3]
b. 1828 d. 1860
- 10 Elizabeth P Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.4]
b. 1830
- 10 Aaron L Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.5]
b. 1831
- 10 Judy R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.6]
b. 1832 d. 1857
- 10 Hiram N Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.7]
b. 1834
- 10 Jefferson Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.8]
b. 1836 d. 1862
- 10 Turner Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.9]
b. 1839
- 10 Robert Smith Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.10]
b. 1843 d. 1925
- 10 John Milton Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.2.1]
- 9 William C Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3]
b. 1808 d. 1865
- 10 Daniel Richard Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3.1]
b. Mar 1840 d. 5 Mar 1906
- 11 Daniel Benjamin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3.1.1]
b. 3 Nov 1889 d. 2 Jul 1959
Carrie L Vincent
- 12 Lemuel Vincent Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3.1.1.1]
b. 15 Mar 1932 d. 15 Jan 2006 [ =>]
- 12 Lemuel Vincent Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3.1.1.1]
- 11 Daniel Benjamin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3.1.1]
- 10 Daniel Richard Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.3.1]
- 9 John D Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.4]
b. May 1825 d. 29 Dec 1913
Minerva A Holt b. 3 Apr 1830 d. 1863
- 10 William Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.4.1]
b. 1850
- 10 Josephine Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.4.2]
b. 1855
- 10 Sarah J Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.4.3]
b. 1857
- 10 Lenville Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.4.4]
b. 1859
- 10 William Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.4.1]
- + Lucy Gordon
- 9 Linville Rountree [1.1.1.1.3.12.10.4.1]
- 8 Priscilla Rountree [1.1.1.1.3.12.10.5]
b. 1780
William Miller b. 19 Jun 1776 d. 30 Jun 1841
- 9 Randolph Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1]
b. 8 Dec 1802 d. 21 Mar 1875
Rachel Gore b. 1803 d. 1849
- 10 Turner Rountree Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1.1]
b. 12 Feb 1835 d. 5 May 1902
- 10 Turner Rountree Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1.1]
Sally Sarah Conner b. 1818
- 10 Melvina Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2]
b. 30 Jan 1852 d. 22 Oct 1922
James Adams Musick b. 30 Jan 1852 d. 22 Oct 1922
- 11 Eliza Jane Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.1]
b. 29 Jan 1850 d. 11 Nov 1913
- + Jones b. Abt 1849
- + Jones b. Abt 1849
- 11 William Joseph Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.2]
b. 15 Oct 1852 d. 15 Jan 1929
- 11 John A Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.3]
b. 18 Oct 1854 d. 7 Mar 1900
- 11 James Volney Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.4]
b. 8 Dec 1857 d. 25 Aug 1944
- 11 Lavonia Paridine Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.5]
b. 26 Mar 1859 d. 18 Jan 1939
- + Kelly b. Abt 1858
- + Kelly b. Abt 1858
- 11 Ida Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.6]
b. 6 Jul 1871 d. 20 Nov 1947
- + Ambrose b. Abt 1870
- + Ambrose b. Abt 1870
- 11 William Edward Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7]
b. 22 Mar 1880 d. 1 Nov 1961
Stella Ann Jolly b. 9 May 1886 d. 29 Mar 1979
- 12 James Otis Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.1]
b. 22 Jan 1904 d. 25 Mar 1989
- 12 Ida Mae Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.2]
b. 17 May 1906 d. 23 Apr 2002
- 12 Maggie Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.3]
b. 12 Apr 1910 d. 14 Jun 2005
- 12 Elmer L Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.4]
b. 3 Apr 1913 d. 7 Feb 1997
- 12 Mae Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.5]
b. 5 Feb 1916 d. 7 Feb 1916
- 12 Claude Edward Musick, Sr [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.6]
b. 28 Mar 1917 d. 9 Jun 1991 [ =>]
- 12 Georgia Alice Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.7]
b. 25 Mar 1920 d. 29 Jan 2006
- 12 Wilma Maxine Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.8]
b. 24 Jan 1923 d. 31 Mar 2018
- 12 James Otis Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.7.1]
- 11 Frank Devilbiss Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.8]
b. 8 Dec 1886 d. 28 Feb 1963
- 11 Eliza Jane Musick [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2.1]
- 10 Melvira Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1.3]
b. 25 Mar 1855 d. 21 Jan 1936
- + Stubblefield b. Abt 1854
- + Stubblefield b. Abt 1854
- 10 Melvina Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1.2]
- 9 Samuel Lackey Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.2]
b. 11 Jul 1805 d. 22 May 1838
- 9 William Malcolm Miller, Sr [1.1.1.1.3.12.10.5.3]
b. 16 Feb 1810 d. 25 Jul 1889
- 9 Randolph Miller [1.1.1.1.3.12.10.5.1]
- 8 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.10.6]
b. 1783 d. 1850
Henry Martin Webb b. 1783 d. 1838
- 9 Julia Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.1]
b. 1809 d. 1885
Thompson Farris b. 1809 d. 1880
- 10 Wiliam Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1]
b. 1835 d. 1876
Rebecca Jane Crawford b. 1843 d. 1917
- 11 Christopher Columbus Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1.1]
b. 27 Aug 1870 d. 14 May 1948
Eva Lena Hunt b. 13 Sep 1884 d. 29 May 1982
- 12 Henry Martin Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1.1.1]
b. 2 Dec 1905 d. 17 Feb 1998 [ =>]
- 12 Delbert Lee Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1.1.2]
b. 12 Jun 1922 d. 13 Feb 1965 [ =>]
- 12 Henry Martin Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1.1.1]
- 11 Christopher Columbus Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1.1]
- 10 Wiliam Farris [1.1.1.1.3.12.10.6.1.1]
- 9 Obediah Hendrick Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2]
b. 1812 d. 1855
Sarah Averett b. 29 Oct 1816 d. 17 Dec 1841
- 10 Henry Martin Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.1]
b. 1835 d. 1911
- 10 Elijah Everett Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.2]
b. 17 Nov 1839 d. 1 Jan 1908
Hannah Jane Matlock b. 4 Jul 1847 d. 9 Jan 1882
- 11 Emery Martin Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.2.1]
b. 17 Jul 1869 d. 3 Jan 1951
Indiana Cox b. 20 Jun 1871 d. 12 Oct 1943
- 12 Elijah Newton Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.2.1.1]
b. 24 Mar 1894 d. 20 Oct 1970 [ =>]
- 12 Elijah Newton Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.2.1.1]
- 11 Emery Martin Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.2.1]
- 10 Henry Martin Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.2.1]
- 9 Elizabeth Ann Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.3]
b. 1820
James Henry Wright b. 27 Mar 1823 d. 12 Nov 1899
- 10 Arminta Caroline Wright [1.1.1.1.3.12.10.6.3.1]
b. 1 Jan 1861 d. 14 Mar 1944
Benjamin Ezra Newton Smith b. 15 Jan 1859 d. 25 Nov 1929
- 11 George Bennett Smith [1.1.1.1.3.12.10.6.3.1.1]
b. 25 Apr 1899 d. 12 Jul 1976
Rose Isabel Giswein b. 24 Jul 1903 d. 19 Oct 1947
- 12 Robert Bennett Smith [1.1.1.1.3.12.10.6.3.1.1.1]
b. 21 Nov 1925 d. 15 Jan 2013 [ =>]
- 12 Robert Bennett Smith [1.1.1.1.3.12.10.6.3.1.1.1]
- 11 George Bennett Smith [1.1.1.1.3.12.10.6.3.1.1]
- 10 Arminta Caroline Wright [1.1.1.1.3.12.10.6.3.1]
- 9 Naomi Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.4]
b. 1823 d. 22 Nov 1880
John Nelson Trout b. 1823 d. 22 Nov 1880
- 10 Jacob Martin Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1]
b. 30 Jan 1855 d. 21 Feb 1925
Harriett Darnell b. 15 Sep 1860 d. 20 Apr 1928
- 11 John Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1]
b. 14 Dec 1877 d. 22 Apr 1950
Polly Ann Southard b. 5 Feb 1882 d. 1 Mar 1965
- 12 Jim Henry Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1.1]
b. Abt 1899
- 12 Ralph Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1.2]
b. 7 Apr 1903 d. 6 May 1964 [ =>]
- 12 Hillary Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1.3]
b. Abt 1905
- 12 Roy Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1.4]
b. Abt 1907
- 12 Minnie Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1.5]
b. Abt 1909
- 12 Jim Henry Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1.1]
- 11 John Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1.1]
- 10 Jacob Martin Trout [1.1.1.1.3.12.10.6.4.1]
- 9 Julia Webb [1.1.1.1.3.12.10.6.1]
- 8 Sally Rountree [1.1.1.1.3.12.10.7]
b. 1784
- + James Jones b. 1784
- + James Jones b. 1784
- 8 Holly B Rountree [1.1.1.1.3.12.10.8]
b. 1788
- 8 Turner Rountree [1.1.1.1.3.12.10.9]
b. 1788 d. 1840
- 8 James Rountree [1.1.1.1.3.12.10.10]
b. 1789
Polly Butcher b. 1789
- 9 James Rountree [1.1.1.1.3.12.10.10.1]
- 9 Letitia Rountree [1.1.1.1.3.12.10.10.2]
- 9 James Rountree [1.1.1.1.3.12.10.10.1]
- 8 Green F Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11]
b. 15 Mar 1790 d. 14 Mar 1858
Nancy White b. 7 Nov 1792 d. 22 Jan 1868
- 9 Greenville Jesse Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.1]
b. 1816 d. 1857
- 9 Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2]
b. 28 May 1817 d. 13 Feb 1891
Elizabeth Betsey Blair b. Abt 1820 d. Aft 1880
- 10 Margaret Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.1]
b. 20 Jul 1839 d. 18 Apr 1924
- + Benjamin Franklin Ellison b. 14 Sep 1838 d. 15 Jul 1915
- + Benjamin Franklin Ellison b. 14 Sep 1838 d. 15 Jul 1915
- 10 Mary Catherine Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.2]
b. 23 Nov 1840 d. 2 Apr 1933
- + Martin Whittle b. May 1838 d. 1914
- + Martin Whittle b. May 1838 d. 1914
- 10 Sarah Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.3]
b. 21 Mar 1842 d. 2 Apr 1933
- + James A J Cole b. 14 Sep 1834 d. 8 Apr 1891
- + James A J Cole b. 14 Sep 1834 d. 8 Apr 1891
- 10 James Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.4]
b. 12 Sep 1843 d. 2 May 1923
- + Janie Keirh
Laura Allis Hunt
- 11 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.4.1]
b. 21 Apr 1886 d. 22 Apr 1953
- + Charlie H Stone b. 1870 d. 20 Jul 1923
- + Charlie H Stone b. 1870 d. 20 Jul 1923
- 11 Joseph H Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.4.2]
b. Sep 1889
- 11 Mary Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.4.1]
- + Janie Keirh
- 10 John Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.5]
b. Abt 1844 d. Bef 1870
- 10 Pleasant Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.6]
b. 12 May 1845 d. 22 May 1930
- 10 William Washington Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.7]
b. 1847 d. 1863
- 10 Wilbourn Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.8]
b. 1848 d. Feb 1855
- 10 Joseph Jackson Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.9]
b. Abt 1848 d. 29 Aug 1886
Sarah M Shaw b. 1856
- 11 Odie W Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.9.1]
b. 1879
- 11 Odie W Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.9.1]
- 10 J Scott Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.10]
b. 6 Apr 1851 d. 15 Dec 1931
- 10 Jesse C Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.11]
b. 17 Jan 1854 d. 24 Mar 1914
Mary Ellen Kinslow b. 20 Jan 1860 d. 15 Sep 1928
- 11 Noah Lester Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.11.1]
b. 13 Apr 1884 d. 27 Sep 1966
- 11 Mettie Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.11.2]
b. 9 Aug 1891 d. 2 Jul 1962
- + Poynter b. Abt 1890
- + Poynter b. Abt 1890
- 11 Alla Bethel Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.11.3]
b. 24 Sep 1902 d. 28 Sep 1917
- 11 Noah Lester Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.11.1]
- 10 Henry Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12]
b. 26 Sep 1855 d. 11 Sep 1914
Nancy P Stevens b. 20 Jul 1861 d. 20 Oct 1942
- 11 William Arthur Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.1]
b. 25 Oct 1882 d. 27 Dec 1943
- 11 John Morton Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.2]
b. 9 Mar 1885 d. 10 Nov 1943
- 11 Charles Trenton Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.3]
b. 22 Jul 1893 d. 21 Jun 1976
- 11 Eula Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.4]
b. 22 Jan 1896 d. 13 Jan 1897
- 11 Sarah Beulah Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.5]
b. 1897 d. 1903
- 11 Joseph Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.6]
b. 21 Feb 1900 d. 25 Feb 1900
- 11 William Arthur Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.12.1]
- 10 Benjamin Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13]
b. 15 Feb 1858 d. 25 May 1925
Esther Elizabeth Lay b. 7 Jun 1863 d. 20 Nov 1936
- 11 William Elmer Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.1]
b. 2 Sep 1883 d. 30 Oct 1967
Kittie Ann Vincent b. 16 Nov 1885 d. 7 Jan 1953
- 12 Inas L Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.1.1]
b. 27 Jul 1908 d. 28 Mar 1992
- 12 Inas L Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.1.1]
- 11 Luther Sylvanus Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.2]
b. 3 Feb 1887 d. 5 Mar 1983
Millie Lee Johnson b. 24 Feb 1894 d. 4 Dec 1985
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.2.1]
- 12 Robert Howard Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.2.2]
b. 8 Jun 1921 d. 27 Jan 1993 [ =>]
- 12 Grover Weldon Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.2.3]
b. 3 Apr 1923 d. 27 Apr 2003
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.2.1]
- 11 Minnie Myrtle Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.3]
b. 22 Dec 1888 d. 15 Jul 1968
- + Everett F Minton b. Abt 1887
- + Everett F Minton b. Abt 1887
- 11 Mary E Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.4]
b. 7 Jul 1893 d. 24 May 1991
- 11 John Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5]
b. 2 May 1895 d. 22 Aug 1975
Anna Pearl Willis b. 9 Apr 1894 d. 18 Mar 1983
- 12 Faye Elaine Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5.1]
b. 14 May 1920 d. 30 Dec 2013
- 12 Warren Thomas Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5.2]
b. 5 Aug 1922 d. 27 May 2000
- 12 Floy Eloise Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5.3]
b. 7 Sep 1925 d. 6 Oct 2000
- 12 Donald Burton Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5.4]
b. 1 Jan 1928 d. 1 Mar 2003 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5.5]
- 12 Faye Elaine Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.5.1]
- 11 Florence Elisie Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.6]
b. 20 May 1898 d. 5 Feb 1996
- + Marshall Abraham Johnson b. 17 Jan 1877 d. 22 Jan 1952
- + Marshall Abraham Johnson b. 17 Jan 1877 d. 22 Jan 1952
- 11 Nellie Gladys Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.7]
b. 1905 d. Feb 1984
- + Barney Wilson Coleman b. Abt 1904
- + Barney Wilson Coleman b. Abt 1904
- 11 Nelson Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.8]
b. 23 Mar 1906 d. 5 Feb 1997
Creola Combest b. 2 Aug 1909 d. 10 Aug 1985
- 12 James Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.8.1]
b. 12 May 1930 d. 16 Apr 2013 [ =>]
- 12 Norma Gene Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.8.2]
b. 7 Sep 1937 d. 24 Apr 1990
- 12 James Franklin Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.8.1]
- 11 William Elmer Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.13.1]
- 10 Margaret Jane Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.2.1]
- 9 Orville H. Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.3]
b. 1818 d. 14 Jun 1883
- 9 Pleasant P Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.4]
b. 27 Dec 1819 d. 1904
- 9 Edwin W Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.5]
b. 1821 d. 25 Sep 1846
- 9 Greenberry M Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.6]
b. 1823 d. 1852
- 9 Marion G Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.7]
b. 3 Sep 1826 d. 1852
- 9 Elizabeth W Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.8]
b. 30 Apr 1829 d. 18 Nov 1892
Thomas Harrison Waters b. 18 Feb 1820 d. 2 Apr 1895
- 10 George W Waters [1.1.1.1.3.12.10.11.8.1]
b. 11 Apr 1848 d. 28 Aug 1899
Sarah Sally Burns b. 8 Aug 1860 d. 21 Jan 1953
- 11 George Alonzo Waters [1.1.1.1.3.12.10.11.8.1.1]
b. 5 Feb 1890 d. 14 Jun 1934
Esther May Farris b. 25 Mar 1894 d. 11 Nov 1957
- 12 Ralph Alonzo Waters [1.1.1.1.3.12.10.11.8.1.1.1]
b. 25 Jul 1915 d. 26 Feb 1970 [ =>]
- 12 Ralph Alonzo Waters [1.1.1.1.3.12.10.11.8.1.1.1]
- 11 George Alonzo Waters [1.1.1.1.3.12.10.11.8.1.1]
- 10 George W Waters [1.1.1.1.3.12.10.11.8.1]
- 9 Nancy W Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.9]
b. 26 Jan 1832
- 9 Melville B Rowntree [1.1.1.1.3.12.10.11.10]
b. 28 Feb 1836
- 9 Greenville Jesse Rountree [1.1.1.1.3.12.10.11.1]
- 8 Millie Rountree [1.1.1.1.3.12.10.12]
b. 1791
- 8 John R Rountree [1.1.1.1.3.12.10.1]
- 7 Drusilla Rountree [1.1.1.1.3.12.11]
b. 17 Feb 1748 d. 17 Feb 1781
Captain Anthony Haden b. 26 Mar 1746 d. 28 Apr 1828
- 8 Turner Richardson Haden, Sr [1.1.1.1.3.12.11.1]
b. 13 Nov 1773 d. 1 Sep 1812
Rebecca Cave b. 1775 d. 26 Oct 1849
- 9 Nancy Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.1]
b. 15 Oct 1801 d. 3 Apr 1893
John H Harris b. Abt 1800
- 10 James S Harris [1.1.1.1.3.12.11.1.1.1]
b. 21 Feb 1818 d. Abt 1889
Elvira Kelly b. Abt 1820
- 11 Susan Frances Harris [1.1.1.1.3.12.11.1.1.1.1]
b. 6 Sep 1844 d. 31 Jan 1917
Bushrod Borum b. Abt 1843
- 12 Davis Borum [1.1.1.1.3.12.11.1.1.1.1.1]
b. Abt 1900 [ =>]
- 12 Davis Borum [1.1.1.1.3.12.11.1.1.1.1.1]
- 11 Susan Frances Harris [1.1.1.1.3.12.11.1.1.1.1]
- 10 James S Harris [1.1.1.1.3.12.11.1.1.1]
- 9 Turner Richardson Haden, Jr [1.1.1.1.3.12.11.1.2]
b. 13 Aug 1808 d. 16 Dec 1878
Louisa Cave b. 1800 d. 1846
- 10 Mary Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.1]
b. 1828 d. 1844
- 10 Mary Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.1]
Sarah Ann Lloyd b. 26 Nov 1822 d. 12 Dec 1895
- 10 Rebecca Edward Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2]
b. 7 Aug 1848 d. 15 Apr 1940
Paul Morris Wright b. 13 May 1849 d. 18 Feb 1920
- 11 James Kelly Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1]
b. 25 Oct 1878 d. 1 Dec 1941
Nancy G Fish b. 14 Sep 1881 d. 17 Sep 1939
- 12 Rebecca Esther Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1.1]
b. 1909 d. 1991
- 12 James K Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1.2]
b. 1912
- 12 William E Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1.3]
b. 10 Aug 1914 [ =>]
- 12 Living [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1.4]
- 12 Rebecca Esther Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1.1]
- 11 Turner R H Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.2]
b. 13 Oct 1880 d. 13 Dec 1961
- 11 Harriet Laura Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.3]
b. 12 Nov 1888 d. 19 Mar 1973
- + Smith b. 1888
- + Smith b. 1888
- 11 James Kelly Wright [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2.1]
- 10 Mary Smith Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.3]
b. 10 Feb 1850 d. 13 Jul 1931
- + Duncan b. Abt 1849
- + Duncan b. Abt 1849
- 10 Joel Thomas Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.4]
b. 1 Oct 1851 d. 1 Jul 1914
- 10 Isaac Lloyd Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.5]
b. 11 Aug 1854 d. 12 Dec 1940
- 10 James Antony Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.6]
b. 1 Aug 1856 d. 5 Jun 1942
- 10 Margaret Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.7]
b. 4 Aug 1859 d. 3 Feb 1926
- + Martin b. Abt 1858
- + Martin b. Abt 1858
- 10 Laura Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.8]
b. 8 Jun 1862 d. 28 Apr 1944
- 10 Rella Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.9]
b. Sep 1868 d. 6 Dec 1922
- + Gillaspie b. Abt 1867
- + Gillaspie b. Abt 1867
- 10 Rebecca Edward Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.2.2]
- 9 Nancy Haden [1.1.1.1.3.12.11.1.1]
- 8 Rebecca Haden [1.1.1.1.3.12.11.2]
b. 1 Dec 1778 d. 21 Nov 1838
Richard Epperson b. 2 Oct 1772 d. 30 Aug 1841
- 9 John Henry Epperson [1.1.1.1.3.12.11.2.1]
b. 15 Jul 1799 d. 26 Nov 1867
Elizabeth R Roark b. 6 Dec 1800 d. 1851
- 10 Susannah Lucinda Epperson [1.1.1.1.3.12.11.2.1.1]
b. 11 Apr 1818 d. 18 Mar 1893
Jesse Carrol b. 5 Oct 1811 d. 16 Sep 1860
- 11 Elizabeth Ann Carrol [1.1.1.1.3.12.11.2.1.1.1]
b. 1 Apr 1841 d. 23 Oct 1905
Augustus Weigel b. 20 Oct 1834 d. 14 Sep 1916
- 12 Elizabeth Susan Weigel [1.1.1.1.3.12.11.2.1.1.1.1]
b. 3 Dec 1873 d. 15 Jul 1967 [ =>]
- 12 Elizabeth Susan Weigel [1.1.1.1.3.12.11.2.1.1.1.1]
- 11 Elizabeth Ann Carrol [1.1.1.1.3.12.11.2.1.1.1]
- 10 Susannah Lucinda Epperson [1.1.1.1.3.12.11.2.1.1]
- 9 John Henry Epperson [1.1.1.1.3.12.11.2.1]
- 8 Turner Richardson Haden, Sr [1.1.1.1.3.12.11.1]
- 7 Isabella Rowntree [1.1.1.1.3.12.1]
- 6 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.3.1]
- 5 Elizabeth Rountree [1.1.1.1.1]
- 4 John Rountree [1.1.1.1]
- 3 Joseph Rountree [1.1.1]
- 2 Ralph Rountree [1.2]
b. 1575 d. 1627
- 2 William Rowntree [1.1]